KIDDICRAFT LIMITED
Visión general
| Nombre de la empresa | KIDDICRAFT LIMITED |
|---|---|
| Estado de la empresa | Disuelta |
| Forma jurídica | Sociedad de responsabilidad limitada |
| Número de empresa | 00798901 |
| Jurisdicción | Inglaterra/Gales |
| Fecha de constitución | |
| Fecha de cese |
Resumen
| Tiene PSCs súper seguros | No |
|---|---|
| Tiene gravámenes | Sí |
| Tiene historial de insolvencia | No |
| La sede social está en disputa | No |
¿Cuál es el propósito de KIDDICRAFT LIMITED?
- Empresa inactiva (99999) / Actividades de organizaciones y organismos extraterritoriales
¿Dónde se encuentra KIDDICRAFT LIMITED?
| Dirección de la sede social | 3rd Floor The Porter Building 1 Brunel Way SL1 1FQ Slough Berkshire England |
|---|---|
| Dirección de la sede social no entregable | No |
¿Cuáles fueron los nombres anteriores de KIDDICRAFT LIMITED?
| Nombre de la empresa | Desde | Hasta |
|---|---|---|
| HESTAIR KIDDICRAFT LIMITED | 31 dic 1977 | 31 dic 1977 |
| KIDDICRAFT LIMITED | 01 abr 1964 | 01 abr 1964 |
¿Cuáles son las últimas cuentas de KIDDICRAFT LIMITED?
| Últimas cuentas | |
|---|---|
| Últimas cuentas cerradas hasta | 31 dic 2020 |
¿Cuáles son las últimas presentaciones para KIDDICRAFT LIMITED?
| Fecha | Descripción | Documento | Tipo | |
|---|---|---|---|---|
Boletín oficial final disuelto por cancelación voluntaria | 1 páginas | GAZ2(A) | ||
Declaración de confirmación presentada el 01 mar 2022 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||
Primer aviso en el boletín oficial para la cancelación voluntaria | 1 páginas | GAZ1(A) | ||
Solicitud de exclusión de la empresa del registro | 3 páginas | DS01 | ||
Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 31 dic 2020 | 5 páginas | AA | ||
Declaración de confirmación presentada el 01 mar 2021 con actualizaciones | 4 páginas | CS01 | ||
Nombramiento de Mr Michael Joseph Pellegrino como director el 01 feb 2021 | 2 páginas | AP01 | ||
Cese del nombramiento de Robert John Normile como director el 31 dic 2020 | 1 páginas | TM01 | ||
Cambio de datos del director Mr Prashant Bapna el 26 oct 2020 | 2 páginas | CH01 | ||
Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 31 dic 2019 | 5 páginas | AA | ||
Modification des détails de Mattel Uk Limited en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 27 abr 2020 | 2 páginas | PSC05 | ||
Domicilio social registrado cambiado de The Porter Building 1 Brunel Way Slough Berkshire SL1 1FQ England a 3rd Floor the Porter Building 1 Brunel Way Slough Berkshire SL1 1FQ el 27 abr 2020 | 1 páginas | AD01 | ||
Modification des détails de Mattel Uk Limited en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 06 abr 2020 | 2 páginas | PSC05 | ||
Domicilio social registrado cambiado de Mattel House Vanwall Business Park Vanwall Road Maidenhead Berkshire SL6 4UB a The Porter Building 1 Brunel Way Slough Berkshire SL1 1FQ el 06 abr 2020 | 1 páginas | AD01 | ||
Declaración de confirmación presentada el 01 mar 2020 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||
Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 31 dic 2018 | 5 páginas | AA | ||
Cambio de datos del director Mr Prashant Bapna el 21 ago 2019 | 2 páginas | CH01 | ||
Declaración de confirmación presentada el 01 mar 2019 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||
Cese del nombramiento de Dean William Ikin como director el 11 ene 2019 | 1 páginas | TM01 | ||
Nombramiento de Mr Prashant Bapna como director el 11 ene 2019 | 2 páginas | AP01 | ||
Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 31 dic 2017 | 5 páginas | AA | ||
Cese del nombramiento de Wendy Elizabeth Hill como director el 03 abr 2018 | 1 páginas | TM01 | ||
Declaración de confirmación presentada el 01 mar 2018 con actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||
Cese del nombramiento de Dominic Julian Geddes como director el 31 dic 2017 | 1 páginas | TM01 | ||
Cambio de datos del director Dean William Ikin el 10 nov 2017 | 2 páginas | CH01 | ||
¿Quiénes son los directivos de KIDDICRAFT LIMITED?
| Nombre | Nombrado el | Renunció el | Rol | Dirección | Identificación de la empresa | País de residencia | Nacionalidad | Fecha de nacimiento | Ocupación | Número |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TUNG, Sukhjiwan Kaur | Secretario | The Porter Building 1 Brunel Way SL1 1FQ Slough 3rd Floor Berkshire England | British | 106672290002 | ||||||
| BAPNA, Prashant | Director | The Porter Building 1 Brunel Way SL1 1FQ Slough 3rd Floor Berkshire England | England | Indian | 254409830003 | |||||
| HICK, Michael Brian | Director | The Porter Building 1 Brunel Way SL1 1FQ Slough 3rd Floor Berkshire England | United Kingdom | British | 181935360002 | |||||
| PELLEGRINO, Michael Joseph | Director | Continental Boulevard El Segundo 333 California 90245 United States | United States | American | 279596470001 | |||||
| CHEVALLIER, Michael John Mayne | Secretario | 40 Fletcher Road Chiswick W4 5AS London | British | 1233360001 | ||||||
| COUNTE, Ronald David | Secretario | 144 Northampton Road LE16 9HF Market Harborough Leicestershire | British | 45256000001 | ||||||
| DESAI, Bimal | Secretario | 24 Springfield Road SL6 2YN Maidenhead Berkshire | British | 80089020001 | ||||||
| GARSIDE, Cliff | Secretario | 8 Deyncourt DH1 3QB Durham | British | 56344140001 | ||||||
| MAWBY, John David | Secretario | The Homestead Main Street Lyddington LE15 9LS Oakham Leicestershire | British | 54979840001 | ||||||
| ALLMARK, David | Director | Castle Street OX10 8DW Wallingford Park Farm House Oxfordshire | England | British | 127080930002 | |||||
| ALLMARK, David | Director | Little Acorns Main Street Stoke Row RG9 5RB Henley On Thames Oxfordshire | British | 69860640002 | ||||||
| BENISON, Graham Ernest | Director | Heather Cottage School Lane Lower Swell GL54 1LH Cheltenham Gloucestershire | British | 61693570001 | ||||||
| BINGHAM, William | Director | Close Hill Naunton GL54 3AA Cheltenham Gloucestershire | United Kingdom | British | 113609900001 | |||||
| CHRISTMAN, Steven | Director | 28 Llanvair Drive SL5 9HT South Ascot Berkshire | American | 100016200001 | ||||||
| DOWNS, Kevin | Director | 21 Gleneagles Drive Stretton DE13 0YG Burton On Trent Staffordshire | United Kingdom | British | 14395290001 | |||||
| GEDDES, Dominic Julian | Director | Mattel House Vanwall Business Park SL6 4UB Vanwall Road Maidenhead Berkshire | England | British | 31394560003 | |||||
| GUARISCO, William Salvatore | Director | Jagerslaan 9 2243 Eh Wassenaar Netherlands | Usa | 46054880001 | ||||||
| HARPER, John Laurence | Director | Framley Startins Lane SL6 9AN Cookham Dean Berkshire | England | British | 177644130001 | |||||
| HILL, Wendy Elizabeth | Director | Mattel House Vanwall Business Park SL6 4UB Vanwall Road Maidenhead Berkshire | England | British | 179051940002 | |||||
| HORTON, Denis Edward | Director | 31 Bedford Road Moor Park HA6 2AY Northwood Middlesex | British | 20007900002 | ||||||
| IKIN, Dean William | Director | Mattel House Vanwall Business Park SL6 4UB Vanwall Road Maidenhead Berkshire | England | Australian | 162397500004 | |||||
| ISITT, Christopher John Shute | Director | 5 West End Cholsey OX10 9LW Wallingford Oxfordshire | British | 49272840001 | ||||||
| JACKSON, Joanne | Director | 7039 Salt Road 14031 Clarance New York U S A | American | 1170400001 | ||||||
| JEANS, Michael | Director | 83 Marlow Bottom SL7 3NA Marlow Buckinghamshire | British | 50463930001 | ||||||
| JORDAN, Jacqueline Emily | Director | 19 Woodlands Grove TW7 6NS Isleworth Middlesex | British | 94380010001 | ||||||
| KINGSTON, Michael Kevin | Director | 5 Beechingstoke SL7 1JH Marlow Buckinghamshire | Irish | 1389290001 | ||||||
| LAW, Monica | Director | 317 Regent Street LO5 1JO Niagara On The Lake Ontario Canada | Canadian | 34333500001 | ||||||
| MAWBY, John David | Director | The Homestead Main Street Lyddington LE15 9LS Oakham Leicestershire | British | 54979840001 | ||||||
| MURTHA, Eugene | Director | Wayfield 1a Gossmore Lane SL7 1QQ Marlow Buckinghamshire | Us Citizen | 76216870001 | ||||||
| NORMILE, Robert John | Director | 333 Continental Boulevard El Segundo California 90245 United States | United States | American | 163804110001 | |||||
| ORAVEC, Bruce Joseph | Director | 30 Mill Road Boxford Masachusetts 01921 Usa | Usa | 25153800001 | ||||||
| PEAN, Jean Christophe | Director | Danes Place New Road RG9 3LG Lower Shiplake Oxfordshire | French | 94379490001 | ||||||
| REDDY, Sandeep Rajaram | Director | Flat 5 24 Harcourt Terrace SW10 9JR London | Indian | 112471610001 | ||||||
| ROCHE, Adrian Edward | Director | Burcombe House Chalford Hill GL6 8EN Stroud Gloucestershire | British | 12414150001 | ||||||
| SANDERSON, Antony Richard | Director | 3 Carlton Grange Gosforth, Newcastle Upon Tyne NE3 4QF Ne3 4qf | United Kingdom | British | 114998910001 |
¿Quiénes son las personas con control significativo de KIDDICRAFT LIMITED?
| Nombre | Notificado el | Dirección | Cesado | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mattel Uk Limited | 06 abr 2016 | The Porter Building 1 Brunel Way SL1 1FQ Slough 3rd Floor Berkshire England | No | ||||||||||
| |||||||||||||
Naturaleza del control
| |||||||||||||
¿Tiene KIDDICRAFT LIMITED alguna carga?
| Clasificación | Fechas | Estado | Detalles | |
|---|---|---|---|---|
| Guarantee & debenture | Creado el 28 may 1982 Entregado el 11 jun 1982 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All monies due or to become due from the company and/or hestair kiddieft group limited to the chargee on any account whatsoever. | |
Breve descripción Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill, bookdebts uncalled capital, buildings fixtures, fixed plant & machinery. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
Fuente de datos
- Companies House del Reino Unido
El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros. - Licencia: CC0