KIDDICRAFT LIMITED

  • Visión general
  • Resumen
  • Propósito
  • Dirección
  • Nombres anteriores
  • Cuentas
  • Presentaciones
  • Directivos
  • Personas con control significativo
  • Gravámenes
  • Fuente de datos
  • Visión general

    Nombre de la empresaKIDDICRAFT LIMITED
    Estado de la empresaDisuelta
    Forma jurídicaSociedad de responsabilidad limitada
    Número de empresa 00798901
    JurisdicciónInglaterra/Gales
    Fecha de constitución
    Fecha de cese

    Resumen

    Tiene PSCs súper segurosNo
    Tiene gravámenes
    Tiene historial de insolvenciaNo
    La sede social está en disputaNo

    ¿Cuál es el propósito de KIDDICRAFT LIMITED?

    • Empresa inactiva (99999) / Actividades de organizaciones y organismos extraterritoriales

    ¿Dónde se encuentra KIDDICRAFT LIMITED?

    Dirección de la sede social
    3rd Floor The Porter Building
    1 Brunel Way
    SL1 1FQ Slough
    Berkshire
    England
    Dirección de la sede social no entregableNo

    ¿Cuáles fueron los nombres anteriores de KIDDICRAFT LIMITED?

    Nombres anteriores de la empresa
    Nombre de la empresaDesdeHasta
    HESTAIR KIDDICRAFT LIMITED31 dic 197731 dic 1977
    KIDDICRAFT LIMITED01 abr 196401 abr 1964

    ¿Cuáles son las últimas cuentas de KIDDICRAFT LIMITED?

    Últimas cuentas
    Últimas cuentas cerradas hasta31 dic 2020

    ¿Cuáles son las últimas presentaciones para KIDDICRAFT LIMITED?

    Presentaciones
    FechaDescripciónDocumentoTipo

    Boletín oficial final disuelto por cancelación voluntaria

    1 páginasGAZ2(A)

    Declaración de confirmación presentada el 01 mar 2022 sin actualizaciones

    3 páginasCS01

    Primer aviso en el boletín oficial para la cancelación voluntaria

    1 páginasGAZ1(A)

    Solicitud de exclusión de la empresa del registro

    3 páginasDS01

    Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 31 dic 2020

    5 páginasAA

    Declaración de confirmación presentada el 01 mar 2021 con actualizaciones

    4 páginasCS01

    Nombramiento de Mr Michael Joseph Pellegrino como director el 01 feb 2021

    2 páginasAP01

    Cese del nombramiento de Robert John Normile como director el 31 dic 2020

    1 páginasTM01

    Cambio de datos del director Mr Prashant Bapna el 26 oct 2020

    2 páginasCH01

    Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 31 dic 2019

    5 páginasAA

    Modification des détails de Mattel Uk Limited en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 27 abr 2020

    2 páginasPSC05

    Domicilio social registrado cambiado de The Porter Building 1 Brunel Way Slough Berkshire SL1 1FQ England a 3rd Floor the Porter Building 1 Brunel Way Slough Berkshire SL1 1FQ el 27 abr 2020

    1 páginasAD01

    Modification des détails de Mattel Uk Limited en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 06 abr 2020

    2 páginasPSC05

    Domicilio social registrado cambiado de Mattel House Vanwall Business Park Vanwall Road Maidenhead Berkshire SL6 4UB a The Porter Building 1 Brunel Way Slough Berkshire SL1 1FQ el 06 abr 2020

    1 páginasAD01

    Declaración de confirmación presentada el 01 mar 2020 sin actualizaciones

    3 páginasCS01

    Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 31 dic 2018

    5 páginasAA

    Cambio de datos del director Mr Prashant Bapna el 21 ago 2019

    2 páginasCH01

    Declaración de confirmación presentada el 01 mar 2019 sin actualizaciones

    3 páginasCS01

    Cese del nombramiento de Dean William Ikin como director el 11 ene 2019

    1 páginasTM01

    Nombramiento de Mr Prashant Bapna como director el 11 ene 2019

    2 páginasAP01

    Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 31 dic 2017

    5 páginasAA

    Cese del nombramiento de Wendy Elizabeth Hill como director el 03 abr 2018

    1 páginasTM01

    Declaración de confirmación presentada el 01 mar 2018 con actualizaciones

    3 páginasCS01

    Cese del nombramiento de Dominic Julian Geddes como director el 31 dic 2017

    1 páginasTM01

    Cambio de datos del director Dean William Ikin el 10 nov 2017

    2 páginasCH01

    ¿Quiénes son los directivos de KIDDICRAFT LIMITED?

    Directivos
    NombreNombrado elRenunció elRolDirecciónIdentificación de la empresaPaís de residenciaNacionalidadFecha de nacimientoOcupaciónNúmero
    TUNG, Sukhjiwan Kaur
    The Porter Building
    1 Brunel Way
    SL1 1FQ Slough
    3rd Floor
    Berkshire
    England
    Secretario
    The Porter Building
    1 Brunel Way
    SL1 1FQ Slough
    3rd Floor
    Berkshire
    England
    BritishSolicitor106672290002
    BAPNA, Prashant
    The Porter Building
    1 Brunel Way
    SL1 1FQ Slough
    3rd Floor
    Berkshire
    England
    Director
    The Porter Building
    1 Brunel Way
    SL1 1FQ Slough
    3rd Floor
    Berkshire
    England
    EnglandIndianFinance Director254409830003
    HICK, Michael Brian
    The Porter Building
    1 Brunel Way
    SL1 1FQ Slough
    3rd Floor
    Berkshire
    England
    Director
    The Porter Building
    1 Brunel Way
    SL1 1FQ Slough
    3rd Floor
    Berkshire
    England
    EnglandBritishSales Director181935360002
    PELLEGRINO, Michael Joseph
    Continental Boulevard
    El Segundo
    333
    California 90245
    United States
    Director
    Continental Boulevard
    El Segundo
    333
    California 90245
    United States
    United StatesAmericanExpert Counsel & Asst General Counsel279596470001
    CHEVALLIER, Michael John Mayne
    40 Fletcher Road
    Chiswick
    W4 5AS London
    Secretario
    40 Fletcher Road
    Chiswick
    W4 5AS London
    British1233360001
    COUNTE, Ronald David
    144 Northampton Road
    LE16 9HF Market Harborough
    Leicestershire
    Secretario
    144 Northampton Road
    LE16 9HF Market Harborough
    Leicestershire
    British45256000001
    DESAI, Bimal
    24 Springfield Road
    SL6 2YN Maidenhead
    Berkshire
    Secretario
    24 Springfield Road
    SL6 2YN Maidenhead
    Berkshire
    BritishChartered Accountant80089020001
    GARSIDE, Cliff
    8 Deyncourt
    DH1 3QB Durham
    Secretario
    8 Deyncourt
    DH1 3QB Durham
    BritishAccountant56344140001
    MAWBY, John David
    The Homestead Main Street
    Lyddington
    LE15 9LS Oakham
    Leicestershire
    Secretario
    The Homestead Main Street
    Lyddington
    LE15 9LS Oakham
    Leicestershire
    BritishDirector Finance54979840001
    ALLMARK, David
    Castle Street
    OX10 8DW Wallingford
    Park Farm House
    Oxfordshire
    Director
    Castle Street
    OX10 8DW Wallingford
    Park Farm House
    Oxfordshire
    EnglandBritishGeneral Manager127080930002
    ALLMARK, David
    Little Acorns Main Street
    Stoke Row
    RG9 5RB Henley On Thames
    Oxfordshire
    Director
    Little Acorns Main Street
    Stoke Row
    RG9 5RB Henley On Thames
    Oxfordshire
    BritishMarketing Director69860640002
    BENISON, Graham Ernest
    Heather Cottage School Lane
    Lower Swell
    GL54 1LH Cheltenham
    Gloucestershire
    Director
    Heather Cottage School Lane
    Lower Swell
    GL54 1LH Cheltenham
    Gloucestershire
    BritishDirector61693570001
    BINGHAM, William
    Close Hill
    Naunton
    GL54 3AA Cheltenham
    Gloucestershire
    Director
    Close Hill
    Naunton
    GL54 3AA Cheltenham
    Gloucestershire
    United KingdomBritishCompany Director113609900001
    CHRISTMAN, Steven
    28 Llanvair Drive
    SL5 9HT South Ascot
    Berkshire
    Director
    28 Llanvair Drive
    SL5 9HT South Ascot
    Berkshire
    AmericanFinance Director100016200001
    DOWNS, Kevin
    21 Gleneagles Drive
    Stretton
    DE13 0YG Burton On Trent
    Staffordshire
    Director
    21 Gleneagles Drive
    Stretton
    DE13 0YG Burton On Trent
    Staffordshire
    United KingdomBritishFinance Director14395290001
    GEDDES, Dominic Julian
    Mattel House
    Vanwall Business Park
    SL6 4UB Vanwall Road Maidenhead
    Berkshire
    Director
    Mattel House
    Vanwall Business Park
    SL6 4UB Vanwall Road Maidenhead
    Berkshire
    EnglandBritishCountry Manager & Vp31394560003
    GUARISCO, William Salvatore
    Jagerslaan 9
    2243 Eh Wassenaar
    Netherlands
    Director
    Jagerslaan 9
    2243 Eh Wassenaar
    Netherlands
    UsaVice President Finance-Europe46054880001
    HARPER, John Laurence
    Framley Startins Lane
    SL6 9AN Cookham Dean
    Berkshire
    Director
    Framley Startins Lane
    SL6 9AN Cookham Dean
    Berkshire
    EnglandBritishManaging Director177644130001
    HILL, Wendy Elizabeth
    Mattel House
    Vanwall Business Park
    SL6 4UB Vanwall Road Maidenhead
    Berkshire
    Director
    Mattel House
    Vanwall Business Park
    SL6 4UB Vanwall Road Maidenhead
    Berkshire
    EnglandBritishCustomer Marketing & Brand Communication Director179051940002
    HORTON, Denis Edward
    31 Bedford Road
    Moor Park
    HA6 2AY Northwood
    Middlesex
    Director
    31 Bedford Road
    Moor Park
    HA6 2AY Northwood
    Middlesex
    BritishManaging Director20007900002
    IKIN, Dean William
    Mattel House
    Vanwall Business Park
    SL6 4UB Vanwall Road Maidenhead
    Berkshire
    Director
    Mattel House
    Vanwall Business Park
    SL6 4UB Vanwall Road Maidenhead
    Berkshire
    EnglandAustralianFinance Director162397500004
    ISITT, Christopher John Shute
    5 West End
    Cholsey
    OX10 9LW Wallingford
    Oxfordshire
    Director
    5 West End
    Cholsey
    OX10 9LW Wallingford
    Oxfordshire
    BritishCompany Director49272840001
    JACKSON, Joanne
    7039 Salt Road
    14031 Clarance
    New York
    U S A
    Director
    7039 Salt Road
    14031 Clarance
    New York
    U S A
    AmericanCompany Director1170400001
    JEANS, Michael
    83 Marlow Bottom
    SL7 3NA Marlow
    Buckinghamshire
    Director
    83 Marlow Bottom
    SL7 3NA Marlow
    Buckinghamshire
    BritishCompany Director50463930001
    JORDAN, Jacqueline Emily
    19 Woodlands Grove
    TW7 6NS Isleworth
    Middlesex
    Director
    19 Woodlands Grove
    TW7 6NS Isleworth
    Middlesex
    BritishMarketing Director94380010001
    KINGSTON, Michael Kevin
    5 Beechingstoke
    SL7 1JH Marlow
    Buckinghamshire
    Director
    5 Beechingstoke
    SL7 1JH Marlow
    Buckinghamshire
    IrishCompany Director1389290001
    LAW, Monica
    317 Regent Street
    LO5 1JO Niagara On The Lake
    Ontario
    Canada
    Director
    317 Regent Street
    LO5 1JO Niagara On The Lake
    Ontario
    Canada
    CanadianCompany President - Internatio34333500001
    MAWBY, John David
    The Homestead Main Street
    Lyddington
    LE15 9LS Oakham
    Leicestershire
    Director
    The Homestead Main Street
    Lyddington
    LE15 9LS Oakham
    Leicestershire
    BritishDirector Finance54979840001
    MURTHA, Eugene
    Wayfield 1a Gossmore Lane
    SL7 1QQ Marlow
    Buckinghamshire
    Director
    Wayfield 1a Gossmore Lane
    SL7 1QQ Marlow
    Buckinghamshire
    Us CitizenGeneral Manager76216870001
    NORMILE, Robert John
    333 Continental Boulevard
    El Segundo
    California 90245
    United States
    Director
    333 Continental Boulevard
    El Segundo
    California 90245
    United States
    United StatesAmericanExecutive Vp & Chief Legal Officer163804110001
    ORAVEC, Bruce Joseph
    30 Mill Road
    Boxford
    Masachusetts 01921
    Usa
    Director
    30 Mill Road
    Boxford
    Masachusetts 01921
    Usa
    UsaCompany Director25153800001
    PEAN, Jean Christophe
    Danes Place
    New Road
    RG9 3LG Lower Shiplake
    Oxfordshire
    Director
    Danes Place
    New Road
    RG9 3LG Lower Shiplake
    Oxfordshire
    FrenchGeneral Manager Uk & N Ireland94379490001
    REDDY, Sandeep Rajaram
    Flat 5
    24 Harcourt Terrace
    SW10 9JR London
    Director
    Flat 5
    24 Harcourt Terrace
    SW10 9JR London
    IndianFinance Director112471610001
    ROCHE, Adrian Edward
    Burcombe House
    Chalford Hill
    GL6 8EN Stroud
    Gloucestershire
    Director
    Burcombe House
    Chalford Hill
    GL6 8EN Stroud
    Gloucestershire
    BritishCompany Director12414150001
    SANDERSON, Antony Richard
    3 Carlton Grange
    Gosforth, Newcastle Upon Tyne
    NE3 4QF Ne3 4qf
    Director
    3 Carlton Grange
    Gosforth, Newcastle Upon Tyne
    NE3 4QF Ne3 4qf
    United KingdomBritishDirector114998910001

    ¿Quiénes son las personas con control significativo de KIDDICRAFT LIMITED?

    Personas con control significativo
    NombreNotificado elDirecciónCesado
    The Porter Building
    1 Brunel Way
    SL1 1FQ Slough
    3rd Floor
    Berkshire
    England
    06 abr 2016
    The Porter Building
    1 Brunel Way
    SL1 1FQ Slough
    3rd Floor
    Berkshire
    England
    No
    Forma jurídicaPrivate Limited Company
    País de registroEngland
    Autoridad legalEngland And Wales
    Lugar de registroCompanies House
    Número de registro1471442
    Naturaleza del control
    • La persona posee, directa o indirectamente, más del 75% de las acciones de la compañía.
    • La persona posee, directa o indirectamente, más del 75% de los derechos de voto en la empresa.
    • La persona tiene el derecho, directa o indirectamente, de nombrar o destituir a la mayoría de la junta directiva de la empresa.

    ¿Tiene KIDDICRAFT LIMITED alguna carga?

    Gravámenes
    ClasificaciónFechasEstadoDetalles
    Guarantee & debenture
    Creado el 28 may 1982
    Entregado el 11 jun 1982
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company and/or hestair kiddieft group limited to the chargee on any account whatsoever.
    Breve descripción
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill, bookdebts uncalled capital, buildings fixtures, fixed plant & machinery.
    Personas con derecho
    • Barclays Bank PLC
    Transacciones
    • 11 jun 1982Registro de una carga

    Fuente de datos

    • Companies House del Reino Unido
      El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros.
    • Licencia: CC0