AVIS BUDGET UK LIMITED
Visión general
| Nombre de la empresa | AVIS BUDGET UK LIMITED |
|---|---|
| Estado de la empresa | Activa |
| Forma jurídica | Sociedad de responsabilidad limitada |
| Número de empresa | 00802486 |
| Jurisdicción | Inglaterra/Gales |
| Fecha de constitución |
Resumen
| Tiene PSCs súper seguros | No |
|---|---|
| Tiene gravámenes | No |
| Tiene historial de insolvencia | No |
| La sede social está en disputa | No |
¿Cuál es el propósito de AVIS BUDGET UK LIMITED?
- Alquiler y arrendamiento de automóviles y vehículos de motor ligeros (77110) / Actividades administrativas y de apoyo
¿Dónde se encuentra AVIS BUDGET UK LIMITED?
| Dirección de la sede social | Avis Budget House Park Road RG12 2EW Bracknell, Berkshire England England |
|---|---|
| Dirección de la sede social no entregable | No |
¿Cuáles fueron los nombres anteriores de AVIS BUDGET UK LIMITED?
| Nombre de la empresa | Desde | Hasta |
|---|---|---|
| AVIS RENT A CAR LIMITED | 24 abr 1964 | 24 abr 1964 |
¿Cuáles son las últimas cuentas de AVIS BUDGET UK LIMITED?
| Vencido | No |
|---|---|
| Próximas cuentas | |
| Próximo período contable finaliza el | 31 dic 2025 |
| Próximas cuentas vencen el | 30 sept 2026 |
| Últimas cuentas | |
| Últimas cuentas cerradas hasta | 31 dic 2024 |
¿Cuál es el estado de la última declaración de confirmación para AVIS BUDGET UK LIMITED?
| Vencido | Sí |
|---|---|
| Última declaración de confirmación cerrada hasta | 19 nov 2025 |
| Próxima declaración de confirmación vence | 03 dic 2025 |
| Última declaración de confirmación | |
| Próxima declaración de confirmación cerrada hasta | 19 nov 2024 |
| Vencido | Sí |
¿Cuáles son las últimas presentaciones para AVIS BUDGET UK LIMITED?
| Fecha | Descripción | Documento | Tipo | |
|---|---|---|---|---|
Cuentas completas preparadas hasta el 31 dic 2024 | 52 páginas | AA | ||
Declaración de confirmación presentada el 19 nov 2024 con actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||
Nombramiento de Mr David Thomas Calabria como director el 15 oct 2024 | 2 páginas | AP01 | ||
Cese del nombramiento de Paul Leslie Ford como director el 15 oct 2024 | 1 páginas | TM01 | ||
Cuentas completas preparadas hasta el 31 dic 2023 | 50 páginas | AA | ||
Registro de la carga 008024860018, creada el 01 mar 2024 | 19 páginas | MR01 | ||
Registro de la carga 008024860017, creada el 01 mar 2024 | 22 páginas | MR01 | ||
Declaración de confirmación presentada el 19 nov 2023 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||
Cuentas completas preparadas hasta el 31 dic 2022 | 52 páginas | AA | ||
Declaración de confirmación presentada el 19 nov 2022 con actualizaciones | 4 páginas | CS01 | ||
Cuentas completas preparadas hasta el 31 dic 2021 | 51 páginas | AA | ||
Notification de Avis Europe Holdings Limited en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 05 jul 2022 | 1 páginas | PSC02 | ||
Cessation de Avis Europe Overseas Ltd en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 05 jul 2022 | 1 páginas | PSC07 | ||
Registro de la carga 008024860016, creada el 20 may 2022 | 20 páginas | MR01 | ||
Registro de la carga 008024860015, creada el 20 may 2022 | 22 páginas | MR01 | ||
Nombramiento de Mr Alan Christopher Olivier-Smith como director el 31 dic 2021 | 2 páginas | AP01 | ||
Cese del nombramiento de Nina Anne Bell como director el 31 dic 2021 | 1 páginas | TM01 | ||
Cese del nombramiento de Jason Christopher Godsell Turner como director el 31 dic 2021 | 1 páginas | TM01 | ||
Declaración de confirmación presentada el 19 nov 2021 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||
Cuentas completas preparadas hasta el 31 dic 2020 | 54 páginas | AA | ||
Cuentas completas preparadas hasta el 31 dic 2019 | 49 páginas | AA | ||
Declaración de confirmación presentada el 19 nov 2020 con actualizaciones | 4 páginas | CS01 | ||
Cese del nombramiento de Thomas Matthew Mannion como secretario el 03 feb 2020 | 1 páginas | TM02 | ||
Estado de capital tras una asignación de acciones el 29 nov 2019
| 3 páginas | SH01 | ||
Declaración de confirmación presentada el 19 nov 2019 con actualizaciones | 4 páginas | CS01 | ||
¿Quiénes son los directivos de AVIS BUDGET UK LIMITED?
| Nombre | Nombrado el | Renunció el | Rol | Dirección | Identificación de la empresa | País de residencia | Nacionalidad | Fecha de nacimiento | Ocupación | Número | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LALL, Inderpal | Secretario | Park Road RG12 2EW Bracknell Avis Budget House Berkshire United Kingdom | 248829990001 | |||||||||||
| CALABRIA, David Thomas | Director | Park Road RG12 2EW Bracknell, Berkshire Avis Budget House England England | United States | American | 327315000001 | |||||||||
| OLIVIER-SMITH, Alan Christopher | Director | Park Road RG12 2EW Bracknell, Berkshire Avis Budget House England England | England | English | 291382010001 | |||||||||
| JONES, Gail Marion | Secretario | Park Road RG12 2EW Bracknell Avis Budget House Berkshire United Kingdom | 177026380001 | |||||||||||
| MANNION, Thomas Matthew | Secretario | Park Road RG12 2EW Bracknell, Berkshire Avis Budget House England England | 248810510001 | |||||||||||
| NICHOLSON, Judith Ann | Secretario | Park Road RG12 2EW Bracknell Avis House Berks England | British | 27201530002 | ||||||||||
| SYKES, William Jeremy | Secretario | Flat 12 75 Warwick Square SW2 2AR London | British | 95677680001 | ||||||||||
| BROUGHTON SECRETARIES LIMITED | Secretario corporativo | Welbeck Street W1G 9YE London 7 England |
| 86181860001 | ||||||||||
| BELL, Nina Anne | Director | Park Road RG12 2EW Bracknell Avis Budget House Berkshire United Kingdom | England | British | 99807710003 | |||||||||
| BELL, Nina Anne | Director | 11 The Burlings SL5 8BY Ascot Berkshire | England | British | 99807710003 | |||||||||
| BRADSHAW, Kevin Michael | Director | Park Road RG12 2EW Bracknell Avis House Berkshire England | England | British | 124019940001 | |||||||||
| BRETT, Robert Alastair Parker | Director | Bridleway Cottage Amersham Road HP9 2UG Beaconsfield Bucks | British | 98639480001 | ||||||||||
| CATHCART, William Alun | Director | Robin Rag The Common GU6 8SH Cranleigh Surrey | British | 9490580007 | ||||||||||
| CEILLE, Kaye | Director | Park Road RG12 2EW Bracknell Avis House Berks United Kingdom | United Kingdom | Usa | 167363840001 | |||||||||
| COATES, Richard John | Director | 7 Spinfield Lane West SL7 2DB Marlow Bucks | British | 81363010001 | ||||||||||
| COWAN, Christopher Ian | Director | Ballards Ballards Lane RH8 0SN Limpsfield Surrey | British | 54679190001 | ||||||||||
| DE LUSSU, Renato Luigi Romolo | Director | Park Road RG12 2EW Bracknell Avis House Berks United Kingdom | United Kingdom | Italian | 154937650001 | |||||||||
| DYER, Keith Francis | Director | Keans Acre Hawthorn Lane, Farnham Common SL2 3TA Slough | British | 90737770001 | ||||||||||
| FILLINGHAM, Stuart Barry David | Director | Park Road RG12 2EW Bracknell Avis House Berkshire England | England | British | 99807720001 | |||||||||
| FORD, Paul Leslie | Director | Park Road RG12 2EW Bracknell Avis Budget House Berkshire United Kingdom | United Kingdom | British | 197045450001 | |||||||||
| FORD, Paul Leslie | Director | Park Road RG12 2EW Bracknell Avis House Berkshire England | United Kingdom | British | 45288050004 | |||||||||
| GENT, Stuart James Ashley | Director | Sisters Avenue Battersea SW11 5SN London 54 | British | 136386040001 | ||||||||||
| GRAHAM, Michael Steven | Director | 16 Redwood Place HP9 1RP Beaconsfield Bucks | United Kingdom | British | 76628590002 | |||||||||
| HANNA, Kenneth George | Director | 5 Onslow Drive Ascot Mansions SL5 7UL North Ascot Berkshire | British | 78515410001 | ||||||||||
| KIGHTLEY, Mark John | Director | Park Road RG12 2EW Bracknell, Berkshire Avis Budget House England England | England | British | 111716530001 | |||||||||
| MALONEY, David Ossian | Director | 64 Ledborough Lane HP9 2DG Beaconsfield Buckinghamshire | United Kingdom | British | 69071800002 | |||||||||
| MCCAFFERTY, Mark | Director | 39 Meadway KT10 9HG Esher Surrey | United Kingdom | British | 61788610002 | |||||||||
| MCENANEY, Michael | Director | Fernkloof Stone Copse, Stoney Lane RG18 9HQ Ashmore Green Berkshire | British | 49285350003 | ||||||||||
| MEDLEY, Luke | Director | 5 The Riverbank SL4 5HU Windsor Berkshire | British | 66286840001 | ||||||||||
| SACHDEVA, Rajiv | Director | Park Road RG12 2EW Bracknell Avis House Berks United Kingdom | United Kingdom | British | 169861260001 | |||||||||
| SAMPEUR, Georges Henri Pierre | Director | 16 Priory Road TW9 3DF Richmond Surrey | French | 47894490001 | ||||||||||
| SERVODIDIO, Mark Jeffrey | Director | Park Road RG12 2EW Bracknell Avis Budget House Berkshire United Kingdom | Uk | United States | 179141820001 | |||||||||
| SMITH, Gary Neil | Director | Park Road RG12 2EW Bracknell Avis House Berkshire England | England | British | 157695700001 | |||||||||
| SMITH, Martyn Robert | Director | Park Road RG12 2EW Bracknell Avis House Berks United Kingdom | England | British | 100650660001 | |||||||||
| SMITH, Martyn Robert | Director | 61 Esmond Road W4 1JE London | England | British | 100650660001 |
¿Quiénes son las personas con control significativo de AVIS BUDGET UK LIMITED?
| Nombre | Notificado el | Dirección | Cesado | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Avis Europe Holdings Limited | 05 jul 2022 | Park Road RG12 2EW Bracknell Avis Budget House England | No | ||||||||||
| |||||||||||||
Naturaleza del control
| |||||||||||||
| Avis Europe Overseas Ltd | 01 jun 2016 | Park Road RG12 2EW Bracknell Avis Budget House England | Sí | ||||||||||
| |||||||||||||
Naturaleza del control
| |||||||||||||
Fuente de datos
- Companies House del Reino Unido
El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros. - Licencia: CC0