MULGATE INVESTMENTS LIMITED

MULGATE INVESTMENTS LIMITED

  • Visión general
  • Resumen
  • Propósito
  • Dirección
  • Cuentas
  • Presentaciones
  • Directivos
  • Gravámenes
  • Fuente de datos
  • Visión general

    Nombre de la empresaMULGATE INVESTMENTS LIMITED
    Estado de la empresaDisuelta
    Forma jurídicaSociedad de responsabilidad limitada
    Número de empresa 00809506
    JurisdicciónInglaterra/Gales
    Fecha de constitución
    Fecha de cese

    Resumen

    Tiene PSCs súper segurosNo
    Tiene gravámenes
    Tiene historial de insolvenciaNo
    La sede social está en disputaNo

    ¿Cuál es el propósito de MULGATE INVESTMENTS LIMITED?

    • Desarrollo de proyectos de construcción (41100) / Construcción
    • Compraventa de bienes inmobiliarios propios (68100) / Actividades inmobiliarias

    ¿Dónde se encuentra MULGATE INVESTMENTS LIMITED?

    Dirección de la sede social
    5 Wigmore Street
    London
    W1U 1PB
    Dirección de la sede social no entregableNo

    ¿Cuáles son las últimas cuentas de MULGATE INVESTMENTS LIMITED?

    Últimas cuentas
    Últimas cuentas cerradas hasta31 mar 2012

    ¿Cuáles son las últimas presentaciones para MULGATE INVESTMENTS LIMITED?

    Presentaciones
    FechaDescripciónDocumentoTipo

    Boletín oficial final disuelto por cancelación voluntaria

    1 páginasGAZ2(A)

    Primer aviso en el boletín oficial para la cancelación voluntaria

    1 páginasGAZ1(A)

    Solicitud de exclusión de la empresa del registro

    2 páginasDS01

    Déclaration annuelle établie au 24 ago 2013 avec liste complète des actionnaires

    6 páginasAR01
    Presentaciones asociadas
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    capital02 sept 2013

    Estado de capital el 02 sept 2013

    • Capital: GBP 5,000,000
    SH01

    Cuentas completas preparadas hasta el 31 mar 2012

    13 páginasAA

    Déclaration annuelle établie au 24 ago 2012 avec liste complète des actionnaires

    6 páginasAR01

    Cuentas completas preparadas hasta el 31 mar 2011

    16 páginasAA

    Se ha descontinuado la acción de cancelación obligatoria

    1 páginasDISS40

    Déclaration annuelle établie au 24 ago 2011

    6 páginasAR01

    Cuentas completas preparadas hasta el 31 mar 2010

    16 páginasAA

    Déclaration annuelle établie au 24 ago 2010

    6 páginasAR01

    Cuentas completas preparadas hasta el 31 mar 2009

    15 páginasAA

    Primer aviso en el boletín oficial para la cancelación obligatoria

    1 páginasGAZ1

    Cambio de datos del director Christopher George White el 01 may 2010

    3 páginasCH01

    Cambio de datos del director Mr Maurice Moses Benady el 01 may 2010

    3 páginasCH01

    Cuentas completas preparadas hasta el 31 mar 2008

    17 páginasAA

    legacy

    4 páginas363a

    legacy

    1 páginas288b

    legacy

    2 páginas288a

    legacy

    4 páginas288a

    legacy

    4 páginas288a

    Resoluciones

    Resolutions
    1 páginasRESOLUTIONS
    Acuerdos
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    capital

    Resoluciones

    Auth dirs re sect 175(5)a of ca 2006 10/11/2008
    RES13

    Resoluciones

    Resolutions
    1 páginasRESOLUTIONS
    Acuerdos
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    capital

    Resoluciones

    Auth dirs re sect 175(5)a of ca 2006 10/11/2008
    RES13

    Resoluciones

    Resolutions
    1 páginasRESOLUTIONS
    Acuerdos
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    capital

    Resolución de autoridad para comprar un número de acciones

    RES09

    Resoluciones

    Resolutions
    4 páginasRESOLUTIONS
    Acuerdos
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    capital

    Resoluciones

    Auth dirs re sect 175(5)a of ca 2006 10/11/2008
    RES13
    incorporation

    Resolución de modificación de los Artículos de Asociación

    RES01

    ¿Quiénes son los directivos de MULGATE INVESTMENTS LIMITED?

    Directivos
    NombreNombrado elRenunció elRolDirecciónIdentificación de la empresaPaís de residenciaNacionalidadFecha de nacimientoOcupaciónNúmero
    REIT (CORPORATE SERVICES) LIMITED
    5 Wigmore Street
    W1U 1PB London
    Secretario corporativo
    5 Wigmore Street
    W1U 1PB London
    79571870001
    BENADY, Maurice Moses
    Line Wall Road
    Gibraltar
    57/63
    Gibraltar
    Director
    Line Wall Road
    Gibraltar
    57/63
    Gibraltar
    GibraltarBritish69435160001
    WHITE, Christopher George
    Line Wall Road
    Gibraltar
    57/63
    Gibraltar
    Director
    Line Wall Road
    Gibraltar
    57/63
    Gibraltar
    GibraltarBritish80132540006
    TRAFALGAR OFFICERS LIMITED
    Wigmore Street
    W1U 1PB London
    3rd Floor 5
    Director corporativo
    Wigmore Street
    W1U 1PB London
    3rd Floor 5
    135415010001
    CURTIS, Ernest Leonard
    Cedar Lodge
    Greenfield Lane Hawksworth Guiseley
    LS20 8HF Leeds
    West Yorkshire
    Secretario
    Cedar Lodge
    Greenfield Lane Hawksworth Guiseley
    LS20 8HF Leeds
    West Yorkshire
    British19382660001
    GIBSON, William Mcaulay
    Ivy Bank
    1 Easby Drive
    LS29 9BE Ilkley
    West Yorkshire
    Secretario
    Ivy Bank
    1 Easby Drive
    LS29 9BE Ilkley
    West Yorkshire
    British5387660001
    GILBERT, Nicholas Jay
    Woodville
    14 Carlton Park Avenue
    WF8 3HQ Pontefract
    West Yorkshire
    Secretario
    Woodville
    14 Carlton Park Avenue
    WF8 3HQ Pontefract
    West Yorkshire
    British81344240001
    JOBBINS, Stuart
    16 Riverside Avenue
    LS21 2RT Otley
    West Yorkshire
    Secretario
    16 Riverside Avenue
    LS21 2RT Otley
    West Yorkshire
    British108146440001
    MILLINGTON, Paul Terence
    2a Gilleyfield Avenue
    Dore
    S17 3NS Sheffield
    Secretario
    2a Gilleyfield Avenue
    Dore
    S17 3NS Sheffield
    British58693930003
    BELL, John Drummond
    Gates Garth
    49 Rutland Drive
    HG1 2NX Harrogate
    North Yorkshire
    Director
    Gates Garth
    49 Rutland Drive
    HG1 2NX Harrogate
    North Yorkshire
    United KingdomBritish63940900001
    BELL, John Drummond
    Gates Garth
    49 Rutland Drive
    HG1 2NX Harrogate
    North Yorkshire
    Director
    Gates Garth
    49 Rutland Drive
    HG1 2NX Harrogate
    North Yorkshire
    United KingdomBritish63940900001
    BEST, George Laidler
    Kiddall Hall Farm
    York Road Barwick In Elmet
    LS14 3AE Leeds
    West Yorkshire
    Director
    Kiddall Hall Farm
    York Road Barwick In Elmet
    LS14 3AE Leeds
    West Yorkshire
    British2748600001
    CULL, David Geoffrey Maurice
    8 Centennial Court
    High Street
    WD3 1AW Rickmansworth
    Hertfordshire
    Director
    8 Centennial Court
    High Street
    WD3 1AW Rickmansworth
    Hertfordshire
    British84076630001
    CURTIS, Ernest Leonard
    Cedar Lodge
    Greenfield Lane Hawksworth Guiseley
    LS20 8HF Leeds
    West Yorkshire
    Director
    Cedar Lodge
    Greenfield Lane Hawksworth Guiseley
    LS20 8HF Leeds
    West Yorkshire
    British19382660001
    EVANS, Andreas Frederick
    Leathley Grange
    LS21 2LA Leathley
    North Yorkshire
    Director
    Leathley Grange
    LS21 2LA Leathley
    North Yorkshire
    United KingdomBritish9485290003
    EVANS, Dominic Redvers
    Pine Lodge
    9 Sandmoor Avenue
    LS17 7DW Leeds
    West Yorkshire
    Director
    Pine Lodge
    9 Sandmoor Avenue
    LS17 7DW Leeds
    West Yorkshire
    British7095590001
    EVANS, Frederick Redvers
    16 Sandmoor Drive
    LS17 7DG Leeds
    West Yorkshire
    Director
    16 Sandmoor Drive
    LS17 7DG Leeds
    West Yorkshire
    British4409160001
    EVANS, Roderick Michael
    Oakhill House
    Roundhay Park Lane
    LS17 8AR Leeds
    Director
    Oakhill House
    Roundhay Park Lane
    LS17 8AR Leeds
    British40175270002
    GIBSON, William Mcaulay
    Ivy Bank
    1 Easby Drive
    LS29 9BE Ilkley
    West Yorkshire
    Director
    Ivy Bank
    1 Easby Drive
    LS29 9BE Ilkley
    West Yorkshire
    British5387660001
    HELLIWELL, David Alistair
    8 Farndale Close
    Spofforth Hill
    LS22 4XE Wetherby
    West Yorkshire
    Director
    8 Farndale Close
    Spofforth Hill
    LS22 4XE Wetherby
    West Yorkshire
    EnglandBritish15578740001
    HORSBROUGH, Pauline Elizabeth
    30 The Orchard
    Wrenthorpe
    WF2 0LL Wakefield
    West Yorkshire
    Director
    30 The Orchard
    Wrenthorpe
    WF2 0LL Wakefield
    West Yorkshire
    United KingdomBritish4961270001
    MCKENDRICK, Charles
    St Anns Main Street
    LS22 5EB Kirk Deighton
    North Yorkshire
    Director
    St Anns Main Street
    LS22 5EB Kirk Deighton
    North Yorkshire
    United KingdomBritish173983190001
    MILLINGTON, Paul Terence
    2a Gilleyfield Avenue
    Dore
    S17 3NS Sheffield
    Director
    2a Gilleyfield Avenue
    Dore
    S17 3NS Sheffield
    United KingdomBritish58693930003
    SYERS, Alan Matthew
    135 Temple Lane
    Copmanthorpe
    YO23 3TE York
    North Yorkshire
    Director
    135 Temple Lane
    Copmanthorpe
    YO23 3TE York
    North Yorkshire
    EnglandBritish65588650002
    TURNER, Philip Arthur
    Red Roofs 2 Mulberry Garth
    Thorp Arch
    LS23 7AF Wetherby
    West Yorkshire
    Director
    Red Roofs 2 Mulberry Garth
    Thorp Arch
    LS23 7AF Wetherby
    West Yorkshire
    British66424440001
    REIT(CORPORATE DIRECTORS) LIMITED
    5 Wigmore Street
    W1U 1PB London
    Director corporativo
    5 Wigmore Street
    W1U 1PB London
    74030120002

    ¿Tiene MULGATE INVESTMENTS LIMITED alguna carga?

    Gravámenes
    ClasificaciónFechasEstadoDetalles
    Security agreement
    Creado el 19 sept 2007
    Entregado el 26 sept 2007
    Pendiente
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from each obligor to any finance party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descripción
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • Eurohypo Ag,London Branch
    Transacciones
    • 26 sept 2007Registro de un cargo (395)
    Sixth supplemental trust deed
    Creado el 14 jun 2005
    Entregado el 01 jul 2005
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    £100,000,000 and all other monies due or to become due under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descripción
    Property k/a sinfin lane industrial estate, sinfin, derbyshire t/no's DY361077 and DY22024 together with all buildings and erections and fixtures (including trade fixtures) and fittings and fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • The Law Debenture Trust Corporation P.L.C
    Transacciones
    • 01 jul 2005Registro de un cargo (395)
    • 27 abr 2007Declaración de que parte o la totalidad de la propiedad de una carga flotante ha sido liberada (403b)
    • 29 sept 2007Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Supplemental legal mortgage to composite guarantee and debenture dated 27 may 1999
    Creado el 28 mar 2003
    Entregado el 09 abr 2003
    Pendiente
    Cantidad garantizada
    All monies,obligations and liabilities due or to become due from the obligors or any of them to any of the beneficiaries under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descripción
    F/Hold land on north west side of sinfin lane,derby; DY22024 with all buildings and fixtures thereon.
    Personas con derecho
    • National Westminster Bank PLC as Security Agent for Itself and the Beneficiaries
    Transacciones
    • 09 abr 2003Registro de un cargo (395)
    Supplemental legal mortgage to composite guarantee and debenture dated 27 may 1999
    Creado el 28 ene 2002
    Entregado el 06 feb 2002
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descripción
    The freehold land known as dollis hill research station t/no. MX122172 and the freehold land known as land and buildings on the west side of stoneferry road, kingston upon hull t/no. HS125192. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • National Westminster Bank PLC as Security Agent and Trustee for Itself and the Beneficiaries
    Transacciones
    • 06 feb 2002Registro de un cargo (395)
    • 29 sept 2007Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Deed of release and substitution
    Creado el 06 ago 1999
    Entregado el 11 ago 1999
    Pendiente
    Cantidad garantizada
    The principal of and interest on the £100,000,000 11% first mortgage debenture stock 2025 of evans of leeds limited (formerly evan of leeds PLC) and all other monies intended to be secured by a trust deed dated 20 september 1985 and deeds supplemental thereto (as defined)
    Breve descripción
    Dollis hill estate brook road dollis hill london t/n-MX122172 together with all buildings and erections or fixtures (including trade fixtures) and fittings and fixed plant and machinery for the time being thereon,. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • The Law Debenture Trust Corporation P.L.C.
    Transacciones
    • 11 ago 1999Registro de un cargo (395)
    • 27 abr 2007Declaración de que parte o la totalidad de la propiedad de una carga flotante ha sido liberada (403b)
    • 10 ago 2007Declaración de que parte o la totalidad de la propiedad de una carga flotante ha sido liberada (403b)
    Deed of accession (supplemental to a composite guarantee and mortgage debenture dated 27 may 1999)
    Creado el 03 ago 1999
    Entregado el 16 ago 1999
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies obligations and liabilities due owing or incurred by the obligors (as defined) or any of them to any of the beneficiaries (as defined) including all monies obligations and liabilities due owing or incurred by the obligors or any of them to any of the beneficiaries under or in connection with the finance documents (as defined) (or any of them) and/or on any account whatsoever
    Breve descripción
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • National Westminster Bank PLC
    Transacciones
    • 16 ago 1999Registro de un cargo (395)
    • 27 ago 1999Declaración de que parte o la totalidad de la propiedad de una carga flotante ha sido liberada (403b)
    • 04 dic 1999Declaración de que parte o la totalidad de la propiedad de una carga flotante ha sido liberada (403b)
    • 21 jun 2000Declaración de que parte o la totalidad de la propiedad de una carga flotante ha sido liberada (403b)
    • 29 sept 2007Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Legal mortgage
    Creado el 06 ene 1999
    Entregado el 08 ene 1999
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company and/or evans of leeds PLC to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    Dollis hill research station l/b brent-MX122172. Assigns the goodwill of all businesses from time to time carried on at the property with the benefit of all authorisations permits registration certificates or licences of any kind also by way of fixed charge the equipment and goods (if any) and all other fixtures fittings plant and machinery and by way of floating charge on other moveable plant machinery furniture equipment goods and other effects which from time to time on the property.
    Personas con derecho
    • Yorkshire Bank PLC
    Transacciones
    • 08 ene 1999Registro de un cargo (395)
    • 23 jul 1999Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Deed of release & substitution
    Creado el 18 sept 1997
    Entregado el 22 sept 1997
    Pendiente
    Cantidad garantizada
    The principal of and interest on the £100,000,000 11% first mortgage debenture stock 2025 of evans of leeds PLC and all other monies intended to be secured by a trust deed dated 20 september 1985 and deeds supplemental thereto
    Breve descripción
    Land at 9 grape lane york t/n NYK191013 together with all buildings erections fixtures (including trade fixtures) and fittings and fixed plant and machinery thereon.
    Personas con derecho
    • The Law Debenture Trust Corporation P.L.C.
    Transacciones
    • 22 sept 1997Registro de un cargo (395)
    • 21 jun 2000Declaración de que parte o la totalidad de la propiedad de una carga flotante ha sido liberada (403b)
    • 27 abr 2007Declaración de que parte o la totalidad de la propiedad de una carga flotante ha sido liberada (403b)
    Deed of release and substitution
    Creado el 20 sept 1996
    Entregado el 24 sept 1996
    Pendiente
    Cantidad garantizada
    The principal amount of the original stock and the new stock together with interest arising under a trust deed dated 20TH september 1985,a deed of release and substitution dated 7TH april 1988,a first supplemental trust deed dated 1ST february 1989,a deed of release dated 29TH march 1989,a second supplemental trust deed dated 4TH december 1992,a third supplemental trust deed dated 4TH november 1993,a deed of release and substitution dated 29TH september 1994,a deed of confirmation dated 17TH november 1994,a deed of release dated 12TH july 1995,a deed of release and substitution dated 26TH september 1995 and a deed of release dated 21ST june 1996 together constituting and securing £100,000,000 11 per cent first mortgage debenture stock 2025.
    Breve descripción
    F/H land and buildings k/a 34 to 42 even and 42A and 42B washway road and oaklands house oaklands drive sale t/n GM478629.
    Personas con derecho
    • The Law Debenture Trust Corporation PLC
    Transacciones
    • 24 sept 1996Registro de un cargo (395)
    • 27 abr 2007Declaración de que parte o la totalidad de la propiedad de una carga flotante ha sido liberada (403b)
    Memorandum of deposit
    Creado el 08 sept 1995
    Entregado el 25 sept 1995
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee as security trustee under the loan agreement (as defined) and the memorandum of deposit
    Breve descripción
    Land and buildings k/a 9 grape lane york t/n NYK30372 with all fixtures fittings plant and machinery.
    Personas con derecho
    • Midland Bank PLC
    Transacciones
    • 25 sept 1995Registro de un cargo (395)
    • 28 jul 1998Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Memorandum of deposit
    Creado el 08 sept 1995
    Entregado el 25 sept 1995
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee as security trustee under the loan agreement (as defined) and this memorandum of deposit
    Breve descripción
    Land and buildings k/a 7 colliergate york t/n NYK56126 with title absolute with all fixtures and fittings.
    Personas con derecho
    • Midland Bank PLC
    Transacciones
    • 25 sept 1995Registro de un cargo (395)
    • 28 jul 1998Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Third supplemental trust deed
    Creado el 04 nov 1993
    Entregado el 19 nov 1993
    Pendiente
    Cantidad garantizada
    £100,000,000 (being the aggregate principal amount of the original stock and the new stock) 11% first mortgage debenture stock 2025 and all other monies due under the terms of the principal trust deed and deeds supplemental thereto
    Breve descripción
    Various properties as specified in form 395. see the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • The Law Debenture Trust Corporation
    Transacciones
    • 19 nov 1993Registro de un cargo (395)
    • 10 ago 2007Declaración de que parte o la totalidad de la propiedad de una carga flotante ha sido liberada (403b)
    Memorandum of deposit
    Creado el 22 ene 1993
    Entregado el 03 feb 1993
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the loan agreement of even date
    Breve descripción
    Land and buildings k/a 7 colliergate york t/n nyk 56126 and land and buildings k/a 9 grape lane york t/n nyk 30372.
    Personas con derecho
    • Midland Bank PLC as Security Trustee for Itself the Banks the Agents and Arranger
    Transacciones
    • 03 feb 1993Registro de un cargo (395)
    • 07 jul 1995Declaración de que parte o la totalidad de la propiedad de una carga flotante ha sido liberada (403b)
    • 07 jul 1995Declaración de que parte o la totalidad de la propiedad de una carga flotante ha sido liberada (403b)
    • 27 jul 1999Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Second supplemental trust deed
    Creado el 04 dic 1992
    Entregado el 08 dic 1992
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    £87,000,000 11% first mortgage debenture stock 2025 and all other monies due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee under the terms of the charge
    Breve descripción
    Various properties as specified in form 395 ref M655C.
    Personas con derecho
    • The Law Debenture Trust PLC
    Transacciones
    • 08 dic 1992Registro de un cargo (395)
    • 28 jul 1998Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    • 28 jul 1998Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    • 28 jul 1998Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    • 27 jul 1999Declaración de que parte o la totalidad de la propiedad de una carga flotante ha sido liberada (403b)
    • 17 ago 1999Declaración de que parte o la totalidad de la propiedad de una carga flotante ha sido liberada (403b)
    • 17 ago 1999Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Memorandum of equitable charge
    Creado el 07 ene 1992
    Entregado el 09 ene 1992
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All moneys due or to become due from the company to the chargee under the terms of the loan agreement dated 7TH december 1988 and this charge
    Breve descripción
    Land and buildings on north west side of sinfin lane, derby comprising the whole of the property registered at h m land registry under t/n dy 30545. land lying to the north of wordsworth avenue derby comprising the whole of the property registered at H.M. land registry under t/ndy 215291.
    Personas con derecho
    • Midland Bank Plcas Security Trustee for the Banks
    Transacciones
    • 09 ene 1992Registro de un cargo (395)
    • 15 ene 1993Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Memerandum of equitable & charge
    Creado el 04 mar 1991
    Entregado el 09 mar 1991
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee as security trustee for the banks (as defined therein) under the loan ageement and under the terms of the charge.
    Breve descripción
    F/H land & buildings on the east side of walney road barrow in furness, cumbria title no:- cu 6053.
    Personas con derecho
    • Midland Bank PLC
    Transacciones
    • 09 mar 1991Registro de una carga
    • 15 ene 1993Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Memerandum of equitable charge
    Creado el 27 oct 1989
    Entregado el 08 nov 1989
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee as security trustee for the banks (as defined) under the terms of a loan agreement dated 7/12/88
    Breve descripción
    F/H land situate to the north east of low lane horsforth title no wyk 269133 including all fixtures fitings (other than trade fixtures & fittings plant & machinery (see from 395 for full details).
    Personas con derecho
    • Midland Bank PLC
    Transacciones
    • 08 nov 1989Registro de una carga
    • 15 ene 1993Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Memarandum of equitable charge
    Creado el 27 oct 1989
    Entregado el 30 oct 1989
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee as security trustee for the banks (as defined therein) under a loan agreement dated 7/12/88 and amended by a first supplemented agreement dated 23/1/89 under the terms of the charge
    Breve descripción
    F/H land situate to the south of feltham rd, ashford, surrey title no:- sy 479887 (including all fixtures fittings other than trade fixtures fittings & including the benifit of all agreements (see from 395 for full details).
    Personas con derecho
    • Midland Bank PLC
    Transacciones
    • 30 oct 1989Registro de una carga
    • 13 dic 1991Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Memorandum of equitable charge
    Creado el 17 feb 1989
    Entregado el 20 feb 1989
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of a loan agreement dated 7/12/88 and the charge
    Breve descripción
    All the property listed on the schedule including fixtures fittings plant and machinery (see from 395 for full details).
    Personas con derecho
    • Midland Bank Plcas Security Trustee for the Banks
    Transacciones
    • 20 feb 1989Registro de una carga
    • 14 nov 1991Declaración de que parte o la totalidad de la propiedad de una carga flotante ha sido liberada (403b)
    • 15 ene 1993Declaración de que parte o la totalidad de la propiedad de una carga flotante ha sido liberada (403b)
    • 21 ago 2002Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Memerandum & equitable charge
    Creado el 07 dic 1988
    Entregado el 13 dic 1988
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of a loan agreement dated 7/12/88 and the charge
    Breve descripción
    All the property listed on the schedule including fixtures fittings plant and machinary (see from 395 for full details).
    Personas con derecho
    • Midland Bank Plcas Security Trustee for the Banks
    Transacciones
    • 13 dic 1988Registro de una carga
    • 11 may 1992Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Deed of release and substitution
    Creado el 07 abr 1988
    Entregado el 08 abr 1988
    Pendiente
    Cantidad garantizada
    Original stock created by a trust deed dated 20 september 1985
    Breve descripción
    Roman house, sittingbourne, kent title no 4568386.
    Personas con derecho
    • The Law Debenture Trust Corporation PLC
    Transacciones
    • 08 abr 1988Registro de una carga
    • 27 jul 1999Declaración de que parte o la totalidad de la propiedad de una carga flotante ha sido liberada (403b)
    • 27 abr 2007Declaración de que parte o la totalidad de la propiedad de una carga flotante ha sido liberada (403b)
    Trust deed
    Creado el 20 sept 1985
    Entregado el 08 oct 1985
    Pendiente
    Cantidad garantizada
    Sterling pounds 12,000,000 11% first mortgate debenture stock 2025 of evans of leeds PLC and other moneys payable pursuant to the trust deed or intended to be secured thereby
    Breve descripción
    Premises adjoining brook road, dollis hill, willesdon NW2 l/b of brent title no mx 122172 premises at feltham road, ashford, surrey title no. Sy 479887 premises at low lane, horsforth, leeds. Title no. Wyk 269133 (see doc M41 for full details) together with all buildings and erections and fixtures (including trade fixtures) and fittings, fixed plant and machinery thereon.
    Personas con derecho
    • The Law Debenture Trust Corporation PLC
    Transacciones
    • 08 oct 1985Registro de una carga
    • 02 oct 1995Declaración de que parte o la totalidad de la propiedad de una carga flotante ha sido liberada (403b)
    • 27 jul 1999Declaración de que parte o la totalidad de la propiedad de una carga flotante ha sido liberada (403b)
    • 27 jul 1999Declaración de que parte o la totalidad de la propiedad de una carga flotante ha sido liberada (403b)
    • 27 jul 1999Declaración de que parte o la totalidad de la propiedad de una carga flotante ha sido liberada (403b)
    • 30 ene 2002Declaración de que parte o la totalidad de la propiedad de una carga flotante ha sido liberada (403b)
    • 27 abr 2007Declaración de que parte o la totalidad de la propiedad de una carga flotante ha sido liberada (403b)
    • 10 ago 2007Declaración de que parte o la totalidad de la propiedad de una carga flotante ha sido liberada (403b)
    Legal charge
    Creado el 13 abr 1973
    Entregado el 17 abr 1973
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from evans of leeds LTD on any account whatsoever.
    Breve descripción
    64 and 66 vicar lane no 6 and 8 sydney st no 5 & 7 hanwood st leeds.
    Personas con derecho
    • Yorkshire Bank LTD
    Transacciones
    • 17 abr 1973Registro de una carga
    • 18 oct 1992Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Legal charge
    Creado el 13 abr 1973
    Entregado el 17 ene 1973
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from evans of leeds LTD to yorkshire bank LTD. On any account whatsoever.
    Breve descripción
    Land containing 97 sq. Yards or thereabouts in vicar lane leeds no 60 and 62 vicar lane leeds.
    Personas con derecho
    • Yorkshire Bank LTD
    Transacciones
    • 17 ene 1973Registro de una carga
    • 18 oct 1992Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)

    Fuente de datos

    • Companies House del Reino Unido
      El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros.
    • Licencia: CC0