CITY LEASING (MEDWAYSIDE) LIMITED
Visión general
Nombre de la empresa | CITY LEASING (MEDWAYSIDE) LIMITED |
---|---|
Estado de la empresa | Disuelta |
Forma jurídica | Sociedad de responsabilidad limitada |
Número de empresa | 00830929 |
Jurisdicción | Inglaterra/Gales |
Fecha de constitución | |
Fecha de cese |
Resumen
Tiene PSCs súper seguros | No |
---|---|
Tiene gravámenes | Sí |
Tiene historial de insolvencia | Sí |
La sede social está en disputa | No |
¿Cuál es el propósito de CITY LEASING (MEDWAYSIDE) LIMITED?
- Otras actividades de apoyo a los negocios n.c.p. (82990) / Actividades administrativas y de apoyo
¿Dónde se encuentra CITY LEASING (MEDWAYSIDE) LIMITED?
Dirección de la sede social | 8 Salisbury Square EC4Y 8BB London |
---|---|
Dirección de la sede social no entregable | No |
¿Cuáles fueron los nombres anteriores de CITY LEASING (MEDWAYSIDE) LIMITED?
Nombre de la empresa | Desde | Hasta |
---|---|---|
LLOYDS INTERNATIONAL LEASING LIMITED | 31 dic 1980 | 31 dic 1980 |
LBI CREDIT LIMITED | 31 dic 1977 | 31 dic 1977 |
CLARK EQUIPMENT CREDIT LIMITED | 14 dic 1964 | 14 dic 1964 |
¿Cuáles son las últimas cuentas de CITY LEASING (MEDWAYSIDE) LIMITED?
Últimas cuentas | |
---|---|
Últimas cuentas cerradas hasta | 31 dic 2010 |
¿Cuáles son las últimas presentaciones para CITY LEASING (MEDWAYSIDE) LIMITED?
Fecha | Descripción | Documento | Tipo | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gaceta final disuelta tras la liquidación | 1 páginas | GAZ2 | ||||||||||
Cese del nombramiento de Scott Mckay Barkman como director el 08 oct 2012 | 1 páginas | TM01 | ||||||||||
Devolución de la reunión final en una liquidación voluntaria de miembros | 4 páginas | 4.71 | ||||||||||
Cese del nombramiento de Pamela Hindley Smith como director el 22 jun 2012 | 1 páginas | TM01 | ||||||||||
Cese del nombramiento de Ian Paul Faraday como director el 25 jun 2012 | 1 páginas | TM01 | ||||||||||
Domicilio social registrado cambiado de 23 Great Winchester Street London EC2P 2AX el 19 mar 2012 | 2 páginas | AD01 | ||||||||||
Nombramiento de un liquidador voluntario | 1 páginas | 600 | ||||||||||
Resoluciones Resolutions | 1 páginas | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Declaración de solvencia | 3 páginas | 4.70 | ||||||||||
legacy | 3 páginas | MG02 | ||||||||||
legacy | 3 páginas | MG02 | ||||||||||
legacy | 3 páginas | MG02 | ||||||||||
legacy | 3 páginas | MG02 | ||||||||||
Déclaration annuelle établie au 31 ene 2012 avec liste complète des actionnaires | 6 páginas | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
legacy | 1 páginas | SH20 | ||||||||||
legacy | 1 páginas | CAP-SS | ||||||||||
Resoluciones Resolutions | 1 páginas | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Estado de capital el 20 ene 2012
| 4 páginas | SH19 | ||||||||||
Cese del nombramiento de Vaughan Williams como director el 21 sept 2011 | 1 páginas | TM01 | ||||||||||
Cuentas completas preparadas hasta el 31 dic 2010 | 12 páginas | AA | ||||||||||
Déclaration annuelle établie au 31 ene 2011 avec liste complète des actionnaires | 7 páginas | AR01 | ||||||||||
Cuentas completas preparadas hasta el 31 dic 2009 | 11 páginas | AA | ||||||||||
Cambio de datos del director Vaughan Williams el 02 abr 2009 | 1 páginas | CH01 | ||||||||||
Déclaration annuelle établie au 31 ene 2010 avec liste complète des actionnaires | 6 páginas | AR01 | ||||||||||
Nombramiento de Mr Scott Mckay Barkman como director | 2 páginas | AP01 | ||||||||||
¿Quiénes son los directivos de CITY LEASING (MEDWAYSIDE) LIMITED?
Nombre | Nombrado el | Renunció el | Rol | Dirección | Identificación de la empresa | País de residencia | Nacionalidad | Fecha de nacimiento | Ocupación | Número |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RUTHERFORD, Adam Paul | Secretario | 1 Great Winchester Street EC2N 2DB London Winchester House | British | 70451850004 | ||||||
BLACK, Nicola Suzanne | Secretario | Springfield 24 Drovers Way CM23 4GF Bishops Stortford Hertfordshire | British | 52160130002 | ||||||
FLETCHER, Edward Michael | Secretario | 3 Aldrich Terrace SW18 3PU Earlsfield | British | 78572640002 | ||||||
HATCHER, Michael Roger | Secretario | Hunyani Ardleigh Road Little Bromley CO11 2QA Manningtree Essex | British | 6759000002 | ||||||
MASLEN, Frederick Charles Archibald | Secretario | 69 Hayes Hill Hayes BR2 7HN Bromley Kent | British | 3770350001 | ||||||
O'CONNOR, Sharon Noelle | Secretario | 176 Blagdon Road KT3 4AL New Malden Surrey | Irish | 45487120003 | ||||||
STAFFORD, Paul Andrew | Secretario | 85 Roman Road IG1 2NZ Ilford Essex | British | Company Secretary | 48252270001 | |||||
BARKMAN, Scott Mckay | Director | Walden House Road CM9 8PJ Great Totham 1a Essex United Kingdom | United Kingdom | New Zealander | Accountant | 91404900001 | ||||
BRADFORD, Valerie Ann | Director | Canfield Park Cottage Canfield Road, Takeley CM22 6ST Bishops Stortford Hertfordshire | British | Accountant | 74285610001 | |||||
CUMMING, Andrew John | Director | 305 Mountjoy House Barbican EC2Y 8BP London | United Kingdom | British | Banker | 46297770002 | ||||
DAVIES, John Anthony | Director | Westmead Stables Weedon HP22 4NN Aylesbury Buckinghamshire | British | Banker | 32423210001 | |||||
DAVIES, John Thomas | Director | 2 Hearn Close Tylers Green HP10 8JT Penn Buckinghamshire | British | Banker | 2501430001 | |||||
DEWDNEY, Andrew David | Director | Cranfield Broad Oak TN12 7NN Benchley Kent | British | Banker | 88480180001 | |||||
FARADAY, Ian Paul | Director | Great Winchester Street EC2N 2DB London Winchester House 1 | British | Banker | 117970910002 | |||||
FOAD, Allan Robert | Director | 19 Dukes Orchard DA5 2DU Bexley Kent | British | Banker | 40761160001 | |||||
FULLELOVE, William Roy | Director | 10 Ennismore Avenue GU1 1SP Guildford Surrey | British | Banker | 46128130001 | |||||
GREEN, Michael Jonathan | Director | 109 Hampstead Way NW11 7LR London | England | British | Banker | 141461000001 | ||||
HARRISON, David Henry Arnold | Director | Woodcote Lodge West Horsley KT24 6ET Leatherhead Surrey | Uk | British | Banker | 8949580001 | ||||
KING, Roger Steuart | Director | 27 Somerset Square W14 8EE London | Us Citezen | Credit Direcor | 79713690001 | |||||
MILES, Peter Bernard | Director | Brentwood House Winchester Road GU32 1JS West Meon Hampshire | British | Banker | 41327480001 | |||||
MILES, Peter Bernard | Director | Brentwood House Winchester Road GU32 1JS West Meon Hampshire | British | Banker | 41327480001 | |||||
MOORE, Alan Edward | Director | Flat 2, 20 Wigmore Street W1U 2RQ London | British | Banker | 71480200001 | |||||
O'SULLIVAN, Lee Scott | Director | 1 Great Winchester Street EC2N 2DB Winchester House London United Kingdom | British | Chartered Accountant | 120275570002 | |||||
OSBORNE, David Hase | Director | The Manor House Bishops Down Road TN4 8XL Tunbridge Wells Kent | United Kingdom | British | Banker | 7602680004 | ||||
PRITCHARD, David Peter | Director | 17 Thorney Crescent SW11 3TT London | England | British | Bank Director | 57244610001 | ||||
RIDING, Frederick Michael Peter | Director | York House Clifton Down Road BS8 4AG Clifton Bristol | British | Banker | 76317830002 | |||||
ROOS, Nicholas Andrew | Director | 2 Claremont Park N3 1TH London | British | Banker | 88479620001 | |||||
SEGGINS, Roger Russell | Director | Marronwood 4 Kelvedon Avenue KT12 5ED Walton On Thames Surrey | British | Banker | 46846030003 | |||||
SMITH, Pamela Hindley | Director | 1 Great Winchester Street EC2N 2DB Winchester House London United Kingdom | British | Investment Banker | 38994140002 | |||||
TWIDALE, Peter Gordon | Director | 12 Baymans Wood Shenfield CM15 8BT Brentwood Essex | British | Managing Director | 73077810001 | |||||
VOWLES, Anthony Brian | Director | Hopgardens Hopgarden Lane TN13 1PX Sevenoaks Kent | British | Director | 75134410001 | |||||
WILLIAMS, Vaughan | Director | 1 Great Winchester Street EC2N 2DB London Winchester House | British | Merchant Banker | 33495830005 |
¿Tiene CITY LEASING (MEDWAYSIDE) LIMITED alguna carga?
Clasificación | Fechas | Estado | Detalles | |
---|---|---|---|---|
Deed of covenants | Creado el 13 abr 1989 Entregado el 17 abr 1989 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada For further securing all monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of a financial agreement dated 16.9.88 the deed of covenants a charge dated 13.4.89 and any other such documents | |
Breve descripción Mv 'blackrock' & her engines machinery boats the insurances and her earnings please see doc m 174 for details. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
Statutory mortgage | Creado el 13 abr 1989 Entregado el 17 abr 1989 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All monies due or to become due from the company to the chargee on any account current regulated by a financial agreement dated 16.9.88 and a deed of covenants dated 13.4.89. | |
Breve descripción 64/64 shares in mv 'blackrock' register the port of london official no 717140 and in her boats & appurtenances. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
Shipowners agreements | Creado el 16 sept 1988 Entregado el 19 sept 1988 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the agreements dated 16.9.88. | |
Breve descripción Any moneys payable to the company under the terms of clause 9(b) on 15 (b) of the financial agreement dated 16.9.88. (please see form 395). | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
Financial agreement | Creado el 16 sept 1988 Entregado el 19 sept 1988 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada £2,560,000 and all other monies due or to become due from the company to the chargee not exceeding £2,560,000. under the terms of the financial agreement dated 16.9.88, the building agreement dated 23.5.88 as movated by a movation agreement dated 21.7.88. | |
Breve descripción All the company's beneficial interest and all its benefits rights and titles under the contract inc the vessel her machinery equipment and materials, all moneys payable. (Please see form 395 for further details). | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
Trust agreement and agreement supplemental thereto dated 1-8-81 | Creado el 15 abr 1981 Adquirido el 18 sept 1981 Entregado el 09 oct 1981 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada Ukd 20,000,000 | |
Breve descripción Property acquired by lloyds international leasing LTD. From seabord coastt line railroad company:- 200 new 100 ton 60 ft 9 in cuf railroad box cares listed in the us official railay equipment register (the 'register') as scl 9550/95749 inclusive and 237 new 100 ton 7000 cu ft railroad woodchip hopper cars listed in the registerer as scl 196475-196711 inclusive. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
Trust agreement and agreement supplemental thereto dated 1-8-81 | Creado el 15 abr 1981 Adquirido el 18 sept 1981 Entregado el 09 oct 1981 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada Ukd 20,000,000 | |
Breve descripción Property acquired by lloyds international leasing LTD from louisville and nashville railroad company:- 100 new 100 ton 4750 cu. Ft. Covered railroad hopper cars listed in the us official railway equipment register (the 'register') as l & n 242600 - 242699 inclusive; and 489 new 100 ton railroad coal hopper cars listed in the register as l & n 551621 - 552109 inclusive. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
|
¿Tiene CITY LEASING (MEDWAYSIDE) LIMITED algún caso de insolvencia?
Número de expediente | Fechas | Tipo | Profesionales | Otro | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
| Liquidación voluntaria de socios |
|
Fuente de datos
- Companies House del Reino Unido
El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros. - Licencia: CC0