CITY LEASING (MEDWAYSIDE) LIMITED

CITY LEASING (MEDWAYSIDE) LIMITED

  • Visión general
  • Resumen
  • Propósito
  • Dirección
  • Nombres anteriores
  • Cuentas
  • Presentaciones
  • Directivos
  • Gravámenes
  • Insolvencia
  • Fuente de datos
  • Visión general

    Nombre de la empresaCITY LEASING (MEDWAYSIDE) LIMITED
    Estado de la empresaDisuelta
    Forma jurídicaSociedad de responsabilidad limitada
    Número de empresa 00830929
    JurisdicciónInglaterra/Gales
    Fecha de constitución
    Fecha de cese

    Resumen

    Tiene PSCs súper segurosNo
    Tiene gravámenes
    Tiene historial de insolvencia
    La sede social está en disputaNo

    ¿Cuál es el propósito de CITY LEASING (MEDWAYSIDE) LIMITED?

    • Otras actividades de apoyo a los negocios n.c.p. (82990) / Actividades administrativas y de apoyo

    ¿Dónde se encuentra CITY LEASING (MEDWAYSIDE) LIMITED?

    Dirección de la sede social
    8 Salisbury Square
    EC4Y 8BB London
    Dirección de la sede social no entregableNo

    ¿Cuáles fueron los nombres anteriores de CITY LEASING (MEDWAYSIDE) LIMITED?

    Nombres anteriores de la empresa
    Nombre de la empresaDesdeHasta
    LLOYDS INTERNATIONAL LEASING LIMITED31 dic 198031 dic 1980
    LBI CREDIT LIMITED31 dic 197731 dic 1977
    CLARK EQUIPMENT CREDIT LIMITED14 dic 196414 dic 1964

    ¿Cuáles son las últimas cuentas de CITY LEASING (MEDWAYSIDE) LIMITED?

    Últimas cuentas
    Últimas cuentas cerradas hasta31 dic 2010

    ¿Cuáles son las últimas presentaciones para CITY LEASING (MEDWAYSIDE) LIMITED?

    Presentaciones
    FechaDescripciónDocumentoTipo

    Gaceta final disuelta tras la liquidación

    1 páginasGAZ2

    Cese del nombramiento de Scott Mckay Barkman como director el 08 oct 2012

    1 páginasTM01

    Devolución de la reunión final en una liquidación voluntaria de miembros

    4 páginas4.71

    Cese del nombramiento de Pamela Hindley Smith como director el 22 jun 2012

    1 páginasTM01

    Cese del nombramiento de Ian Paul Faraday como director el 25 jun 2012

    1 páginasTM01

    Domicilio social registrado cambiado de 23 Great Winchester Street London EC2P 2AX el 19 mar 2012

    2 páginasAD01

    Nombramiento de un liquidador voluntario

    1 páginas600

    Resoluciones

    Resolutions
    1 páginasRESOLUTIONS
    Acuerdos
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    liquidation

    Acuerdo especial para la liquidación el 28 feb 2012

    LRESSP

    Declaración de solvencia

    3 páginas4.70

    legacy

    3 páginasMG02

    legacy

    3 páginasMG02

    legacy

    3 páginasMG02

    legacy

    3 páginasMG02

    Déclaration annuelle établie au 31 ene 2012 avec liste complète des actionnaires

    6 páginasAR01
    Presentaciones asociadas
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    capital16 feb 2012

    Estado de capital el 16 feb 2012

    • Capital: GBP 9
    SH01

    legacy

    1 páginasSH20

    legacy

    1 páginasCAP-SS

    Resoluciones

    Resolutions
    1 páginasRESOLUTIONS
    Acuerdos
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    capital

    Resolución de reducción del capital social emitido

    RES06

    Estado de capital el 20 ene 2012

    • Capital: GBP 9.00
    4 páginasSH19

    Cese del nombramiento de Vaughan Williams como director el 21 sept 2011

    1 páginasTM01

    Cuentas completas preparadas hasta el 31 dic 2010

    12 páginasAA

    Déclaration annuelle établie au 31 ene 2011 avec liste complète des actionnaires

    7 páginasAR01

    Cuentas completas preparadas hasta el 31 dic 2009

    11 páginasAA

    Cambio de datos del director Vaughan Williams el 02 abr 2009

    1 páginasCH01

    Déclaration annuelle établie au 31 ene 2010 avec liste complète des actionnaires

    6 páginasAR01

    Nombramiento de Mr Scott Mckay Barkman como director

    2 páginasAP01

    ¿Quiénes son los directivos de CITY LEASING (MEDWAYSIDE) LIMITED?

    Directivos
    NombreNombrado elRenunció elRolDirecciónIdentificación de la empresaPaís de residenciaNacionalidadFecha de nacimientoOcupaciónNúmero
    RUTHERFORD, Adam Paul
    1 Great Winchester Street
    EC2N 2DB London
    Winchester House
    Secretario
    1 Great Winchester Street
    EC2N 2DB London
    Winchester House
    British70451850004
    BLACK, Nicola Suzanne
    Springfield
    24 Drovers Way
    CM23 4GF Bishops Stortford
    Hertfordshire
    Secretario
    Springfield
    24 Drovers Way
    CM23 4GF Bishops Stortford
    Hertfordshire
    British52160130002
    FLETCHER, Edward Michael
    3 Aldrich Terrace
    SW18 3PU Earlsfield
    Secretario
    3 Aldrich Terrace
    SW18 3PU Earlsfield
    British78572640002
    HATCHER, Michael Roger
    Hunyani Ardleigh Road
    Little Bromley
    CO11 2QA Manningtree
    Essex
    Secretario
    Hunyani Ardleigh Road
    Little Bromley
    CO11 2QA Manningtree
    Essex
    British6759000002
    MASLEN, Frederick Charles Archibald
    69 Hayes Hill
    Hayes
    BR2 7HN Bromley
    Kent
    Secretario
    69 Hayes Hill
    Hayes
    BR2 7HN Bromley
    Kent
    British3770350001
    O'CONNOR, Sharon Noelle
    176 Blagdon Road
    KT3 4AL New Malden
    Surrey
    Secretario
    176 Blagdon Road
    KT3 4AL New Malden
    Surrey
    Irish45487120003
    STAFFORD, Paul Andrew
    85 Roman Road
    IG1 2NZ Ilford
    Essex
    Secretario
    85 Roman Road
    IG1 2NZ Ilford
    Essex
    BritishCompany Secretary48252270001
    BARKMAN, Scott Mckay
    Walden House Road
    CM9 8PJ Great Totham
    1a
    Essex
    United Kingdom
    Director
    Walden House Road
    CM9 8PJ Great Totham
    1a
    Essex
    United Kingdom
    United KingdomNew ZealanderAccountant91404900001
    BRADFORD, Valerie Ann
    Canfield Park Cottage
    Canfield Road, Takeley
    CM22 6ST Bishops Stortford
    Hertfordshire
    Director
    Canfield Park Cottage
    Canfield Road, Takeley
    CM22 6ST Bishops Stortford
    Hertfordshire
    BritishAccountant74285610001
    CUMMING, Andrew John
    305 Mountjoy House
    Barbican
    EC2Y 8BP London
    Director
    305 Mountjoy House
    Barbican
    EC2Y 8BP London
    United KingdomBritishBanker46297770002
    DAVIES, John Anthony
    Westmead Stables
    Weedon
    HP22 4NN Aylesbury
    Buckinghamshire
    Director
    Westmead Stables
    Weedon
    HP22 4NN Aylesbury
    Buckinghamshire
    BritishBanker32423210001
    DAVIES, John Thomas
    2 Hearn Close
    Tylers Green
    HP10 8JT Penn
    Buckinghamshire
    Director
    2 Hearn Close
    Tylers Green
    HP10 8JT Penn
    Buckinghamshire
    BritishBanker2501430001
    DEWDNEY, Andrew David
    Cranfield
    Broad Oak
    TN12 7NN Benchley
    Kent
    Director
    Cranfield
    Broad Oak
    TN12 7NN Benchley
    Kent
    BritishBanker88480180001
    FARADAY, Ian Paul
    Great Winchester Street
    EC2N 2DB London
    Winchester House 1
    Director
    Great Winchester Street
    EC2N 2DB London
    Winchester House 1
    BritishBanker117970910002
    FOAD, Allan Robert
    19 Dukes Orchard
    DA5 2DU Bexley
    Kent
    Director
    19 Dukes Orchard
    DA5 2DU Bexley
    Kent
    BritishBanker40761160001
    FULLELOVE, William Roy
    10 Ennismore Avenue
    GU1 1SP Guildford
    Surrey
    Director
    10 Ennismore Avenue
    GU1 1SP Guildford
    Surrey
    BritishBanker46128130001
    GREEN, Michael Jonathan
    109 Hampstead Way
    NW11 7LR London
    Director
    109 Hampstead Way
    NW11 7LR London
    EnglandBritishBanker141461000001
    HARRISON, David Henry Arnold
    Woodcote Lodge
    West Horsley
    KT24 6ET Leatherhead
    Surrey
    Director
    Woodcote Lodge
    West Horsley
    KT24 6ET Leatherhead
    Surrey
    UkBritishBanker8949580001
    KING, Roger Steuart
    27 Somerset Square
    W14 8EE London
    Director
    27 Somerset Square
    W14 8EE London
    Us CitezenCredit Direcor79713690001
    MILES, Peter Bernard
    Brentwood House
    Winchester Road
    GU32 1JS West Meon
    Hampshire
    Director
    Brentwood House
    Winchester Road
    GU32 1JS West Meon
    Hampshire
    BritishBanker41327480001
    MILES, Peter Bernard
    Brentwood House
    Winchester Road
    GU32 1JS West Meon
    Hampshire
    Director
    Brentwood House
    Winchester Road
    GU32 1JS West Meon
    Hampshire
    BritishBanker41327480001
    MOORE, Alan Edward
    Flat 2, 20 Wigmore Street
    W1U 2RQ London
    Director
    Flat 2, 20 Wigmore Street
    W1U 2RQ London
    BritishBanker71480200001
    O'SULLIVAN, Lee Scott
    1 Great Winchester Street
    EC2N 2DB
    Winchester House
    London
    United Kingdom
    Director
    1 Great Winchester Street
    EC2N 2DB
    Winchester House
    London
    United Kingdom
    BritishChartered Accountant120275570002
    OSBORNE, David Hase
    The Manor House
    Bishops Down Road
    TN4 8XL Tunbridge Wells
    Kent
    Director
    The Manor House
    Bishops Down Road
    TN4 8XL Tunbridge Wells
    Kent
    United KingdomBritishBanker7602680004
    PRITCHARD, David Peter
    17 Thorney Crescent
    SW11 3TT London
    Director
    17 Thorney Crescent
    SW11 3TT London
    EnglandBritishBank Director57244610001
    RIDING, Frederick Michael Peter
    York House
    Clifton Down Road
    BS8 4AG Clifton
    Bristol
    Director
    York House
    Clifton Down Road
    BS8 4AG Clifton
    Bristol
    BritishBanker76317830002
    ROOS, Nicholas Andrew
    2 Claremont Park
    N3 1TH London
    Director
    2 Claremont Park
    N3 1TH London
    BritishBanker88479620001
    SEGGINS, Roger Russell
    Marronwood 4 Kelvedon Avenue
    KT12 5ED Walton On Thames
    Surrey
    Director
    Marronwood 4 Kelvedon Avenue
    KT12 5ED Walton On Thames
    Surrey
    BritishBanker46846030003
    SMITH, Pamela Hindley
    1 Great Winchester Street
    EC2N 2DB
    Winchester House
    London
    United Kingdom
    Director
    1 Great Winchester Street
    EC2N 2DB
    Winchester House
    London
    United Kingdom
    BritishInvestment Banker38994140002
    TWIDALE, Peter Gordon
    12 Baymans Wood
    Shenfield
    CM15 8BT Brentwood
    Essex
    Director
    12 Baymans Wood
    Shenfield
    CM15 8BT Brentwood
    Essex
    BritishManaging Director73077810001
    VOWLES, Anthony Brian
    Hopgardens
    Hopgarden Lane
    TN13 1PX Sevenoaks
    Kent
    Director
    Hopgardens
    Hopgarden Lane
    TN13 1PX Sevenoaks
    Kent
    BritishDirector75134410001
    WILLIAMS, Vaughan
    1 Great Winchester Street
    EC2N 2DB London
    Winchester House
    Director
    1 Great Winchester Street
    EC2N 2DB London
    Winchester House
    BritishMerchant Banker33495830005

    ¿Tiene CITY LEASING (MEDWAYSIDE) LIMITED alguna carga?

    Gravámenes
    ClasificaciónFechasEstadoDetalles
    Deed of covenants
    Creado el 13 abr 1989
    Entregado el 17 abr 1989
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    For further securing all monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of a financial agreement dated 16.9.88 the deed of covenants a charge dated 13.4.89 and any other such documents
    Breve descripción
    Mv 'blackrock' & her engines machinery boats the insurances and her earnings please see doc m 174 for details.
    Personas con derecho
    • Lloyds Bank PLC
    Transacciones
    • 17 abr 1989Registro de una carga
    • 13 feb 2012Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (MG02)
    Statutory mortgage
    Creado el 13 abr 1989
    Entregado el 17 abr 1989
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account current regulated by a financial agreement dated 16.9.88 and a deed of covenants dated 13.4.89.
    Breve descripción
    64/64 shares in mv 'blackrock' register the port of london official no 717140 and in her boats & appurtenances.
    Personas con derecho
    • Lloyds Bank PLC
    Transacciones
    • 17 abr 1989Registro de una carga
    • 13 feb 2012Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (MG02)
    Shipowners agreements
    Creado el 16 sept 1988
    Entregado el 19 sept 1988
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the agreements dated 16.9.88.
    Breve descripción
    Any moneys payable to the company under the terms of clause 9(b) on 15 (b) of the financial agreement dated 16.9.88. (please see form 395).
    Personas con derecho
    • The Secretary of State for Trade and Industry
    Transacciones
    • 19 sept 1988Registro de una carga
    • 04 nov 1997Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Financial agreement
    Creado el 16 sept 1988
    Entregado el 19 sept 1988
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    £2,560,000 and all other monies due or to become due from the company to the chargee not exceeding £2,560,000. under the terms of the financial agreement dated 16.9.88, the building agreement dated 23.5.88 as movated by a movation agreement dated 21.7.88.
    Breve descripción
    All the company's beneficial interest and all its benefits rights and titles under the contract inc the vessel her machinery equipment and materials, all moneys payable. (Please see form 395 for further details).
    Personas con derecho
    • Lloyds Bank PLC
    Transacciones
    • 19 sept 1988Registro de una carga
    • 04 nov 1997Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Trust agreement and agreement supplemental thereto dated 1-8-81
    Creado el 15 abr 1981
    Adquirido el 18 sept 1981
    Entregado el 09 oct 1981
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    Ukd 20,000,000
    Breve descripción
    Property acquired by lloyds international leasing LTD. From seabord coastt line railroad company:- 200 new 100 ton 60 ft 9 in cuf railroad box cares listed in the us official railay equipment register (the 'register') as scl 9550/95749 inclusive and 237 new 100 ton 7000 cu ft railroad woodchip hopper cars listed in the registerer as scl 196475-196711 inclusive.
    Personas con derecho
    • Mercantile Safe Deposit and Trust Company
    Transacciones
    • 09 oct 1981Registro de una carga
    • 30 dic 1996Declaración de que parte o la totalidad de la propiedad de una carga flotante ha sido liberada (403b)
    • 13 feb 2012Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (MG02)
    Trust agreement and agreement supplemental thereto dated 1-8-81
    Creado el 15 abr 1981
    Adquirido el 18 sept 1981
    Entregado el 09 oct 1981
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    Ukd 20,000,000
    Breve descripción
    Property acquired by lloyds international leasing LTD from louisville and nashville railroad company:- 100 new 100 ton 4750 cu. Ft. Covered railroad hopper cars listed in the us official railway equipment register (the 'register') as l & n 242600 - 242699 inclusive; and 489 new 100 ton railroad coal hopper cars listed in the register as l & n 551621 - 552109 inclusive.
    Personas con derecho
    • Mercantile Safe Deposit and Trust Company
    Transacciones
    • 09 oct 1981Registro de una carga
    • 30 dic 1996Declaración de que parte o la totalidad de la propiedad de una carga flotante ha sido liberada (403b)
    • 13 feb 2012Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (MG02)

    ¿Tiene CITY LEASING (MEDWAYSIDE) LIMITED algún caso de insolvencia?

    Número de expedienteFechasTipoProfesionalesOtro
    1
    FechaTipo
    15 abr 2013Fecha de disolución
    28 feb 2012Inicio de la liquidación
    Liquidación voluntaria de socios
    NombreRolDirecciónNombrado elCesado el
    John David Thomas Milsom
    8 Salisbury Square
    EC4Y 8BB London
    Profesional
    8 Salisbury Square
    EC4Y 8BB London
    Jeremy Simon Spratt
    8 Salisbury Square
    EC4Y 8BB London
    Profesional
    8 Salisbury Square
    EC4Y 8BB London

    Fuente de datos

    • Companies House del Reino Unido
      El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros.
    • Licencia: CC0