SOMERFIELD GROUP LIMITED

SOMERFIELD GROUP LIMITED

  • Visión general
  • Resumen
  • Propósito
  • Dirección
  • Nombres anteriores
  • Cuentas
  • Presentaciones
  • Directivos
  • Gravámenes
  • Fuente de datos
  • Visión general

    Nombre de la empresaSOMERFIELD GROUP LIMITED
    Estado de la empresaConvertida/Cerrada
    Forma jurídicaConvertida o cerrada
    Número de empresa 00833416
    JurisdicciónInglaterra/Gales
    Fecha de constitución
    Fecha de cese

    Resumen

    Tiene PSCs súper segurosNo
    Tiene gravámenes
    Tiene historial de insolvenciaNo
    La sede social está en disputaNo

    ¿Cuál es el propósito de SOMERFIELD GROUP LIMITED?

    • (7499) /

    ¿Dónde se encuentra SOMERFIELD GROUP LIMITED?

    Dirección de la sede social
    New Century House
    Corporation Street
    M60 4ES Manchester
    United Kingdom
    Dirección de la sede social no entregableNo

    ¿Cuáles fueron los nombres anteriores de SOMERFIELD GROUP LIMITED?

    Nombres anteriores de la empresa
    Nombre de la empresaDesdeHasta
    GATEWAY STORES LIMITED06 ene 196506 ene 1965

    ¿Cuáles son las últimas cuentas de SOMERFIELD GROUP LIMITED?

    Vencido
    Próximas cuentas
    Próximo período contable finaliza el04 ene 2011
    Próximas cuentas vencen el04 oct 2011
    Últimas cuentas
    Últimas cuentas cerradas hasta02 ene 2010

    ¿Cuáles son las últimas presentaciones para SOMERFIELD GROUP LIMITED?

    Presentaciones
    FechaDescripciónDocumentoTipo

    Certificado de registro de una Sociedad de Socorros Mutuos

    páginasCERTIPS

    Misceláneos

    Forms band z -conversion to I &ps
    páginasMISC

    Resoluciones

    Resolutions
    páginasRESOLUTIONS
    Acuerdos
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    capital

    Resoluciones

    Convert to I & ps 05/10/2010
    RES13

    Nombramiento de Mr Stephen Parry como secretario

    páginasAP03

    Déclaration annuelle établie au 01 sept 2010 avec liste complète des actionnaires

    páginasAR01
    Presentaciones asociadas
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    capital29 sept 2010

    Estado de capital el 29 sept 2010

    • Capital: GBP 120,040,300
    SH01

    Comptes annuels modifiés établis au 02 ene 2010

    páginasAAMD

    Cuentas completas preparadas hasta el 02 ene 2010

    páginasAA

    Cambio de datos del director Mr Stephen Humes el 01 ago 2010

    páginasCH01

    Cambio de datos del director Mr Timothy Hurrell el 01 ago 2010

    páginasCH01

    Cuentas completas preparadas hasta el 02 may 2009

    páginasAA

    Exercice comptable en cours raccourci du 27 abr 2010 au 04 ene 2010

    páginasAA01

    Renuncia del auditor

    páginasAUD

    Domicilio social registrado cambiado de Somerfield House Whitchurch Lane Bristol BS14 0TJ el 20 nov 2009

    páginasAD01

    Cese del nombramiento de William Robson como director

    páginasTM01

    Cese del nombramiento de Emily Martin como secretario

    páginasTM02

    Nombramiento de Mrs Caroline Jane Sellers como secretario

    páginasAP03

    legacy

    páginas363a

    legacy

    páginas403a

    legacy

    páginas288b

    Resoluciones

    Resolutions
    páginasRESOLUTIONS
    Acuerdos
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    capital

    Resoluciones

    Re documents 17/03/2009
    RES13

    legacy

    páginas288a

    legacy

    páginas288b

    legacy

    páginas288b

    legacy

    páginas288b

    legacy

    páginas288a

    ¿Quiénes son los directivos de SOMERFIELD GROUP LIMITED?

    Directivos
    NombreNombrado elRenunció elRolDirecciónIdentificación de la empresaPaís de residenciaNacionalidadFecha de nacimientoOcupaciónNúmero
    PARRY, Stephen
    Corporation Street
    M60 4ES Manchester
    New Century House
    United Kingdom
    Secretario
    Corporation Street
    M60 4ES Manchester
    New Century House
    United Kingdom
    154610860001
    SELLERS, Caroline Jane
    c/o Governance Dept
    Corporation Street
    M60 4ES Manchester
    New Century House
    United Kingdom
    Secretario
    c/o Governance Dept
    Corporation Street
    M60 4ES Manchester
    New Century House
    United Kingdom
    146966510001
    HUMES, Stephen
    5th Floor, New Century House
    Corporation Street
    M60 4ES Manchester
    C/O Governance Department
    Director
    5th Floor, New Century House
    Corporation Street
    M60 4ES Manchester
    C/O Governance Department
    United KingdomBritishFinance Director84087790001
    HURRELL, Timothy
    5th Floor, New Century House
    Corporation Street
    M60 4ES Manchester
    C/O Governance Department
    Director
    5th Floor, New Century House
    Corporation Street
    M60 4ES Manchester
    C/O Governance Department
    United KingdomBritishGeneral Manager - Food Group99724260001
    BROWN, Michael Alfred
    Windrush Great Billing Park
    NN3 9BL Northampton
    Northamptonshire
    Secretario
    Windrush Great Billing Park
    NN3 9BL Northampton
    Northamptonshire
    British50692920001
    EGITTO, Joleen
    3 Abbots Close
    Whitchurch
    BS14 0UD Bristol
    Secretario
    3 Abbots Close
    Whitchurch
    BS14 0UD Bristol
    British61599540001
    GRANT, Stephen Martin
    3 Trelawn Court
    Rodney Road
    GL50 1JJ Cheltenham
    Gloucestershire
    Secretario
    3 Trelawn Court
    Rodney Road
    GL50 1JJ Cheltenham
    Gloucestershire
    British20888800002
    GRANT, Stephen Martin
    2 Beechwood Close
    Battledown
    GL52 6QQ Cheltenham
    Gloucestershire
    Secretario
    2 Beechwood Close
    Battledown
    GL52 6QQ Cheltenham
    Gloucestershire
    British20888800001
    HENSHAW, Stephen Anthony
    Eastleigh Stables
    Bishopstrow
    BA12 9HW Warminster
    Wiltshire
    Secretario
    Eastleigh Stables
    Bishopstrow
    BA12 9HW Warminster
    Wiltshire
    BritishCompany Secretary91828160006
    MARTIN, Emily Louise
    49 Henley Park
    Yatton
    BS49 4JJ Bristol
    Secretario
    49 Henley Park
    Yatton
    BS49 4JJ Bristol
    BritishCompany Secretary115285710001
    ASHTON, Yvonne Margaret
    1 West Dene
    Stoke Bishop
    BS9 2BQ Bristol
    Avon
    Director
    1 West Dene
    Stoke Bishop
    BS9 2BQ Bristol
    Avon
    BritishChartered Accountant45225070002
    BACK, Steven John
    Fennels 119 Bicester Road
    Lower End
    HP18 9EF Long Crendon
    Director
    Fennels 119 Bicester Road
    Lower End
    HP18 9EF Long Crendon
    United KingdomBritishFinance Director85825120001
    BICKERSTAFFE, Katie
    Aston Lodge
    5 Highdale Road
    BS21 7UW Clevedon
    Avon
    Director
    Aston Lodge
    5 Highdale Road
    BS21 7UW Clevedon
    Avon
    BritishCompany Director110621690001
    CHEYNE, David George Thomson
    The Covert 98 Woodlands Road
    Ashurst
    SO40 7AH Southampton
    Hampshire
    Director
    The Covert 98 Woodlands Road
    Ashurst
    SO40 7AH Southampton
    Hampshire
    BritainBritishCompany Director74956170001
    CLELAND, Jonathan Bradley
    70 Andes Close
    Ocean Village
    SO14 3HS Southampton
    Director
    70 Andes Close
    Ocean Village
    SO14 3HS Southampton
    BritishRetail Director111624590001
    COATES, Philip Raymond
    2 Berestede Road
    W6 9NP London
    Director
    2 Berestede Road
    W6 9NP London
    United KingdomBritishChartered Surveyor60114990002
    COOPER, Geoffrey Ian
    Crossways House Old Coach Road
    Cross
    BS26 2EL Axbridge
    Somerset
    Director
    Crossways House Old Coach Road
    Cross
    BS26 2EL Axbridge
    Somerset
    BritishCost & Management Accountant59071930001
    GATTO, Salvatore Martin
    11 Cavendish Lodge
    Cavendish Road
    BA1 2UD Bath
    Avon
    Director
    11 Cavendish Lodge
    Cavendish Road
    BA1 2UD Bath
    Avon
    United KingdomBritishFinance Director37327260002
    GRANT, Stephen Martin
    3 Trelawn Court
    Rodney Road
    GL50 1JJ Cheltenham
    Gloucestershire
    Director
    3 Trelawn Court
    Rodney Road
    GL50 1JJ Cheltenham
    Gloucestershire
    BritishCompany Secretary20888800002
    HARTE, Damien Bernard
    13 Cambridge Park
    Redland
    BS6 6XW Bristol
    Director
    13 Cambridge Park
    Redland
    BS6 6XW Bristol
    BritishCertified Accountant33922420001
    HENSHAW, Stephen Anthony
    2 Ashton Coombe Lower Road
    Bratton
    BA13 4JQ Westbury
    Wiltshire
    Director
    2 Ashton Coombe Lower Road
    Bratton
    BA13 4JQ Westbury
    Wiltshire
    BritishDirector91828160003
    MASON, Paul
    Moor Lane
    Burley Woodhead
    LS29 7SW Ilkley
    Moorlands
    West Yorkshire
    United Kingdom
    Director
    Moor Lane
    Burley Woodhead
    LS29 7SW Ilkley
    Moorlands
    West Yorkshire
    United Kingdom
    United KingdomBritishDirector141310720001
    MITCHELL INNES, Alistair Campbell
    Langton Lodge Station Road
    Sunningdale
    SL5 0QR Ascot
    Berkshire
    Director
    Langton Lodge Station Road
    Sunningdale
    SL5 0QR Ascot
    Berkshire
    BritishChief Executive1386650001
    NELLIST, Robert Henry Harger
    Spooners 28 Park St Lane
    Park Street
    AL2 2JB St Albans
    Hertfordshire
    Director
    Spooners 28 Park St Lane
    Park Street
    AL2 2JB St Albans
    Hertfordshire
    BritishChartered Accountant5435750001
    OAKES, Martin Nicholas
    Oakhurst House
    Fulready, Ettington
    CV37 7PE Stratford-Upon-Avon
    Warwickshire
    Director
    Oakhurst House
    Fulready, Ettington
    CV37 7PE Stratford-Upon-Avon
    Warwickshire
    United KingdomBritishLogistics Director86206380002
    ROBSON, William Henry Mark
    12 Kimble Close
    Knightcote
    CV47 2SJ Southam
    Warwickshire
    Director
    12 Kimble Close
    Knightcote
    CV47 2SJ Southam
    Warwickshire
    EnglandBritishFinance Director57803420002
    SHARP, Ernest Henry
    36 Tufton Court Tufton Street
    Westminster
    SW1P 3QH London
    Director
    36 Tufton Court Tufton Street
    Westminster
    SW1P 3QH London
    BritishChartered Accountant777200001
    SMITH, Alan Frank
    Brambledown Grove Farm
    Droitwich Road Feckenham
    B96 6JA Redditch
    Worcestershire
    Director
    Brambledown Grove Farm
    Droitwich Road Feckenham
    B96 6JA Redditch
    Worcestershire
    BritishDirector46000100003
    SMITH, Colin George
    Tallius
    Jubilee Road, Finchampstead
    RG40 3SR Wokingham
    Berkshire
    Director
    Tallius
    Jubilee Road, Finchampstead
    RG40 3SR Wokingham
    Berkshire
    BritishDirector111628890001
    SMITH, Neil Reynold
    27 Broom Farm Close
    Nailsea
    BS48 4YJ Bristol
    Director
    27 Broom Farm Close
    Nailsea
    BS48 4YJ Bristol
    BritishCompany Director61599510002

    ¿Tiene SOMERFIELD GROUP LIMITED alguna carga?

    Gravámenes
    ClasificaciónFechasEstadoDetalles
    Supplemental debenture
    Creado el 06 mar 2006
    Entregado el 14 mar 2006
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from each obligor to any senior creditor and any pik creditor on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descripción
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • The Royal Bank of Scotland PLC (Security Agent)
    Transacciones
    • 14 mar 2006Registro de un cargo (395)
    • 29 jun 2007Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Debenture
    Creado el 23 dic 2005
    Entregado el 05 ene 2006
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from each obligor to any rcf creditor under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descripción
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • Hsbc Bank PLC
    Transacciones
    • 05 ene 2006Registro de un cargo (395)
    • 24 jul 2009Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    A target group debenture
    Creado el 23 dic 2005
    Entregado el 28 dic 2005
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to any senior creditor and any pik creditor on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descripción
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill uncalled capital buildings fixtures plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • The Royal Bank of Scotland (The Security Agent)
    Transacciones
    • 28 dic 2005Registro de un cargo (395)
    • 29 jun 2007Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Guarantee and debenture
    Creado el 25 oct 1989
    Entregado el 31 oct 1989
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    For full details see certificate
    Breve descripción
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personas con derecho
    • S. G. Warburg & Co Ltdas Agent and Trustee for Itself and for Each Lender (As Defined Therein)
    Transacciones
    • 31 oct 1989Registro de una carga
    • 13 ago 1996Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)

    Fuente de datos

    • Companies House del Reino Unido
      El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros.
    • Licencia: CC0