WISPERS TRUST LIMITED
Visión general
Nombre de la empresa | WISPERS TRUST LIMITED |
---|---|
Estado de la empresa | Activa |
Forma jurídica | Sociedad de responsabilidad limitada por garantía sin capital social |
Número de empresa | 00845837 |
Jurisdicción | Inglaterra/Gales |
Fecha de constitución |
Resumen
Tiene PSCs súper seguros | No |
---|---|
Tiene gravámenes | Sí |
Tiene historial de insolvencia | No |
La sede social está en disputa | No |
¿Cuál es el propósito de WISPERS TRUST LIMITED?
- Educación secundaria general (85310) / Educación
¿Dónde se encuentra WISPERS TRUST LIMITED?
Dirección de la sede social | 38 Newtown Road GU30 7DX Liphook Hampshire |
---|---|
Dirección de la sede social no entregable | No |
¿Cuáles fueron los nombres anteriores de WISPERS TRUST LIMITED?
Nombre de la empresa | Desde | Hasta |
---|---|---|
WISPERS SCHOOL EDUCATIONAL TRUST LIMITED | 14 abr 1965 | 14 abr 1965 |
¿Cuáles son las últimas cuentas de WISPERS TRUST LIMITED?
Vencido | No |
---|---|
Próximas cuentas | |
Próximo período contable finaliza el | 31 ago 2024 |
Próximas cuentas vencen el | 31 may 2025 |
Últimas cuentas | |
Últimas cuentas cerradas hasta | 31 ago 2023 |
¿Cuál es el estado de la última declaración de confirmación para WISPERS TRUST LIMITED?
Última declaración de confirmación cerrada hasta | 21 mar 2025 |
---|---|
Próxima declaración de confirmación vence | 04 abr 2025 |
Última declaración de confirmación | |
Próxima declaración de confirmación cerrada hasta | 21 mar 2024 |
Vencido | No |
¿Cuáles son las últimas presentaciones para WISPERS TRUST LIMITED?
Fecha | Descripción | Documento | Tipo | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cambio de datos del director Mrs Rebecca Warnock el 04 mar 2025 | 2 páginas | CH01 | ||||||||||
Cuentas de exención total completas preparadas hasta el 31 ago 2023 | 15 páginas | AA | ||||||||||
Declaración de confirmación presentada el 21 mar 2024 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||||||||||
Resoluciones Resolutions | 1 páginas | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Memorándum y Estatutos | 20 páginas | MA | ||||||||||
Cese del nombramiento de Emma Louise Thompson como director el 16 jun 2023 | 1 páginas | TM01 | ||||||||||
Cancelación total de la carga 1 | 1 páginas | MR04 | ||||||||||
Cancelación total de la carga 2 | 1 páginas | MR04 | ||||||||||
Cancelación total de la carga 3 | 1 páginas | MR04 | ||||||||||
Cancelación total de la carga 4 | 1 páginas | MR04 | ||||||||||
Cancelación total de la carga 5 | 1 páginas | MR04 | ||||||||||
Cancelación total de la carga 6 | 1 páginas | MR04 | ||||||||||
Cancelación total de la carga 8 | 1 páginas | MR04 | ||||||||||
Cancelación total de la carga 7 | 1 páginas | MR04 | ||||||||||
Cancelación total de la carga 9 | 1 páginas | MR04 | ||||||||||
Cancelación total de la carga 10 | 1 páginas | MR04 | ||||||||||
Cancelación total de la carga 12 | 1 páginas | MR04 | ||||||||||
Cancelación total de la carga 11 | 1 páginas | MR04 | ||||||||||
Cuentas de exención total completas preparadas hasta el 31 ago 2022 | 14 páginas | AA | ||||||||||
Declaración de confirmación presentada el 21 mar 2023 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||||||||||
Nombramiento de Mrs Emma Louise Thompson como director el 27 jun 2022 | 2 páginas | AP01 | ||||||||||
Cuentas de exención total completas preparadas hasta el 31 ago 2021 | 14 páginas | AA | ||||||||||
Declaración de confirmación presentada el 21 mar 2022 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||||||||||
Cuentas de exención total completas preparadas hasta el 31 ago 2020 | 14 páginas | AA | ||||||||||
Declaración de confirmación presentada el 21 mar 2021 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||||||||||
¿Quiénes son los directivos de WISPERS TRUST LIMITED?
Nombre | Nombrado el | Renunció el | Rol | Dirección | Identificación de la empresa | País de residencia | Nacionalidad | Fecha de nacimiento | Ocupación | Número |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BELTRAN, Louis Henry | Director | Easebourne Lane Easebourne GU29 9BN Midhurst 380 West Sussex United Kingdom | United Kingdom | British | Headmaster | 118783730002 | ||||
BELTRAN, Rosemary Ysabel | Director | Easebourne Lane Easebourne GU29 9BN Midhurst 380 West Sussex United Kingdom | United Kingdom | British | Retired Teacher | 147781310001 | ||||
FORBES, Sebastian, Professor | Director | Octave House Boughton Hall Avenue, Send GU23 7DF Woking Surrey | United Kingdom | British | University Professor | 74388920001 | ||||
HOLYOAK, Angela | Director | 668 Chelsea Cloisters Sloane Avenue SW3 London | United Kingdom | British | Principal Of Girls School | 74388990001 | ||||
WARNOCK, Rebecca | Director | 91 Boundstone Road Rowledge GU10 4AS Farnham Nutbourne Surrey England | England | British | Teacher And Former Pupil | 234315230002 | ||||
CASH, Joseph Leo Gabriel | Secretario | Cherrimans Shottermill Haslemere Surrey | British | 41574530002 | ||||||
HART, John Neil | Secretario | 5 East Pallant PO19 1TS Chichester West Sussex | British | 5972420001 | ||||||
ALLEN, Patricia Arlette | Director | 4 Heathfield Gate GU29 9JB Midhurst West Sussex | British | 5972500001 | ||||||
BADDELEY, Hugh Frame | Director | Farn Brakes Rudgwick RH12 3EJ Horsham West Sussex | British | Chartered Accountant | 33956970001 | |||||
BROWN, Gillian Verity Benson | Director | 22 The Paddox OX2 7PN Oxford Oxfordshire | British | Administrative Secretary | 5972430001 | |||||
CLARKE, Alfred Trevor | Director | Red Stack The Close Aldwick PO21 4EP Bognor Regis West Sussex | Uk | British | Gentleman | 153669790001 | ||||
CLARKE, Ann Elizabeth | Director | Red Stack The Close Aldwick PO21 4EP Bognor Regis West Sussex | British | Independent Means | 5972450001 | |||||
COBURN, Sara | Director | 28 Embercourt Road KT7 0LQ Thames Ditton Surrey | British | Journalist | 43490940002 | |||||
DAVEY, Janet | Director | 5 Nutwood GU7 2HG Godalming Surrey | British | Company Secretary | 11292750001 | |||||
FRENCH, Christopher John | Director | Brewer Street Farm Bletchingley RH1 4QP Redhill Surrey | United Kingdom | British | Farmer | 74896220001 | ||||
HANAUER, Brenda | Director | 41 Barlavington Way GU29 9TG Midhurst West Sussex | British | Retired | 56777690001 | |||||
HENSHER, Alan Anthony | Director | Whiteriggs Inval GU27 1AH Haslemere Surrey | British | Director | 4075300001 | |||||
HUNTING, Isobel Marjorie Hannay | Director | Cones Cottage 88 Old Woking Road KT14 6HU West Byfleet Surrey | United Kingdom | British | Independent Means | 5972470003 | ||||
JOHNSON, Timothy Hawkey | Director | Tillington House GU28 0RA Tillington West Sussex | Usa | Textile Director | 112286690001 | |||||
MASON, Robert Stewart | Director | Shadow Lawn Ridgley Road GU8 4QW Chiddingfold Surrey | England | British | Director | 73863590002 | ||||
MOODY, Roy Arthur James | Director | Ashridge 48 Haslemere Road GU30 7BB Liphook Hampshire | British | Retired Headmaster | 60563480001 | |||||
OMAR, Mustapha Kamal, Dr | Director | Friday's Hill Fernhurst GU27 3DY Haslemere Sophers Farm Manor Surrey | United Kingdom | British | Investment Banker | 149886820001 | ||||
PARKER, John Humphrey | Director | Wallops Wood House Droxford SO32 3QY Southampton Hampshire | England | British | Farmer | 17452470001 | ||||
PARKER, John Humphrey | Director | Wallops Wood House Droxford SO32 3QY Southampton Hampshire | England | British | Farmer | 17452470001 | ||||
PEARCE, Julia Kristen | Director | Kings Road SL4 2AH Windsor 52 Berkshire England | England | British | Director | 172236350001 | ||||
ROME, Christopher William | Director | Grattons Dunsfold GU8 4LU Godalming Surrey | British | Company Director | 37425510001 | |||||
SHEAN, Alan | Director | Allington 12 Cannonside KT22 9LE Fetcham Surrey | British | Headteacher Retired | 80269630001 | |||||
SNELLER, Elizabeth Anne | Director | Little Beeches Westside, Tillington GU28 9AL Petworth West Sussex | United Kingdom | British | None | 86316230001 | ||||
SPIER, Ray | Director | 6 Parklands Place Merrow GU1 2PS Guildford Surrey | British | Company Director | 47704590001 | |||||
THOMPSON, Emma Louise | Director | GU27 1PN Haslemere 7 Pitfold Avenue Surrey England | England | British | Teacher | 297669710001 | ||||
WHELAN, Derek Frank | Director | 1 Lynchmere Road Shottermill GU27 Haslemere Surrey | British | Structural Engineer | 5972520001 |
¿Cuáles son las últimas declaraciones sobre personas con control significativo para WISPERS TRUST LIMITED?
Notificado el | Cesado el | Declaración |
---|---|---|
21 abr 2017 | La empresa sabe o tiene motivos razonables para creer que no existe ninguna persona registrable o entidad jurídica relevante registrable en relación con la empresa. |
¿Tiene WISPERS TRUST LIMITED alguna carga?
Clasificación | Fechas | Estado | Detalles | |
---|---|---|---|---|
Legal charge | Creado el 28 jul 2008 Entregado el 13 ago 2008 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Breve descripción The freehold property known as or being oak hall and land adjoining haslemere, surrey t/n sy 381749. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
Debenture | Creado el 28 jul 2008 Entregado el 02 ago 2008 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Breve descripción Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
Legal charge | Creado el 28 mar 2006 Entregado el 05 abr 2006 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Breve descripción F/H oak hill and land adjoining haslemere surrey. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
Legal charge | Creado el 21 nov 1985 Entregado el 04 dic 1985 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever no exceeding sterling pounds 90,500 | |
Breve descripción Oak hall haslemere, surrey and land adjoining title no: 381749. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
Legal charge | Creado el 15 may 1979 Entregado el 30 may 1979 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever not exceeding sterling pounds 100,000 | |
Breve descripción F/H premises known as oak hall, haslemere surrey and land adjoining. Title no sy 381749. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
Legal charge | Creado el 24 may 1976 Entregado el 08 jun 1976 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever not exceeding sterling pounds 15,000 | |
Breve descripción Oak hall haslemere, surrey and land adjoining. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
Legal charge | Creado el 22 sept 1975 Entregado el 03 oct 1975 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Breve descripción Oak hall haslemere surrey, & land. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
Further charge | Creado el 08 may 1972 Entregado el 16 may 1972 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada 10,000 | |
Breve descripción Oak hall haslemere surrey and land adjoining sy 381749. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
Charge | Creado el 15 sept 1971 Entregado el 30 sept 1971 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever net exceading sterling pounds 30,000 | |
Breve descripción Oak hall, haslemere, surrey and land adjoining sy 381749. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
Deed of postponement | Creado el 06 ene 1969 Entregado el 23 ene 1969 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada Which postpones the priority of a series of debentures dated 9TH november 1965 in favour of a charge 6TH january 1969 | |
Breve descripción The company purchased oak hall, haslemere. (See doc 21 for full details). | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
Mortgage | Creado el 06 ene 1969 Entregado el 22 ene 1969 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada Sterling pounds 30,000 | |
Breve descripción All that property comprised in a conveyance dated 6TH january 1965. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
Series of debentures | Creado el 09 nov 1965 Entregado el 18 nov 1965 | Satisfecho en su totalidad | ||
Transacciones
|
Fuente de datos
- Companies House del Reino Unido
El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros. - Licencia: CC0