GLEESON DEVELOPMENTS LIMITED
Visión general
| Nombre de la empresa | GLEESON DEVELOPMENTS LIMITED |
|---|---|
| Estado de la empresa | Activa |
| Forma jurídica | Sociedad de responsabilidad limitada |
| Número de empresa | 00848808 |
| Jurisdicción | Inglaterra/Gales |
| Fecha de constitución |
Resumen
| Tiene PSCs súper seguros | No |
|---|---|
| Tiene gravámenes | No |
| Tiene historial de insolvencia | No |
| La sede social está en disputa | No |
¿Cuál es el propósito de GLEESON DEVELOPMENTS LIMITED?
- Construcción de edificios domésticos (41202) / Construcción
¿Dónde se encuentra GLEESON DEVELOPMENTS LIMITED?
| Dirección de la sede social | 6 Europa Court Sheffield Business Park S9 1XE Sheffield |
|---|---|
| Dirección de la sede social no entregable | No |
¿Cuáles fueron los nombres anteriores de GLEESON DEVELOPMENTS LIMITED?
| Nombre de la empresa | Desde | Hasta |
|---|---|---|
| GLEESON HOMES LIMITED | 13 may 1965 | 13 may 1965 |
¿Cuáles son las últimas cuentas de GLEESON DEVELOPMENTS LIMITED?
| Vencido | No |
|---|---|
| Próximas cuentas | |
| Próximo período contable finaliza el | 30 jun 2026 |
| Próximas cuentas vencen el | 31 mar 2027 |
| Últimas cuentas | |
| Últimas cuentas cerradas hasta | 30 jun 2025 |
¿Cuál es el estado de la última declaración de confirmación para GLEESON DEVELOPMENTS LIMITED?
| Última declaración de confirmación cerrada hasta | 16 oct 2026 |
|---|---|
| Próxima declaración de confirmación vence | 30 oct 2026 |
| Última declaración de confirmación | |
| Próxima declaración de confirmación cerrada hasta | 16 oct 2025 |
| Vencido | No |
¿Cuáles son las últimas presentaciones para GLEESON DEVELOPMENTS LIMITED?
| Fecha | Descripción | Documento | Tipo | |
|---|---|---|---|---|
Cuentas completas preparadas hasta el 30 jun 2025 | 36 páginas | AA | ||
Declaración de confirmación presentada el 16 oct 2025 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||
Cuentas completas preparadas hasta el 30 jun 2024 | 36 páginas | AA | ||
Declaración de confirmación presentada el 16 oct 2024 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||
Cuentas completas preparadas hasta el 30 jun 2023 | 37 páginas | AA | ||
Declaración de confirmación presentada el 16 oct 2023 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||
Nombramiento de Mrs Leanne Johnson como secretario el 01 ene 2023 | 2 páginas | AP03 | ||
Nombramiento de Mr Graham Prothero como director el 01 ene 2023 | 2 páginas | AP01 | ||
Cese del nombramiento de James Michael Douglas Thomson como director el 31 dic 2022 | 1 páginas | TM01 | ||
Cese del nombramiento de Dermot James Gleeson como director el 31 dic 2022 | 1 páginas | TM01 | ||
Cuentas completas preparadas hasta el 30 jun 2022 | 35 páginas | AA | ||
Declaración de confirmación presentada el 16 oct 2022 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||
Registro de la carga 008488080048, creada el 26 ago 2022 | 40 páginas | MR01 | ||
Cuentas completas preparadas hasta el 30 jun 2021 | 33 páginas | AA | ||
Declaración de confirmación presentada el 16 oct 2021 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||
La dirección de inspección del registro se ha cambiado de Elder House St Georges Business Park 207 Brooklands Road Weybridge Surrey KT13 0TS United Kingdom a Highdown House Yeoman Way Worthing West Sussex BN99 3HH | 1 páginas | AD02 | ||
Cancelación total de la carga 008488080022 | 1 páginas | MR04 | ||
Cancelación total de la carga 008488080023 | 1 páginas | MR04 | ||
Registro de la carga 008488080047, creada el 24 mar 2021 | 42 páginas | MR01 | ||
Cancelación total de la carga 15 | 1 páginas | MR04 | ||
Cancelación total de la carga 008488080021 | 1 páginas | MR04 | ||
Cancelación total de la carga 20 | 1 páginas | MR04 | ||
Cancelación total de la carga 19 | 1 páginas | MR04 | ||
Cancelación total de la carga 14 | 2 páginas | MR04 | ||
Cancelación total de la carga 13 | 1 páginas | MR04 | ||
¿Quiénes son los directivos de GLEESON DEVELOPMENTS LIMITED?
| Nombre | Nombrado el | Renunció el | Rol | Dirección | Identificación de la empresa | País de residencia | Nacionalidad | Fecha de nacimiento | Ocupación | Número |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JOHNSON, Leanne | Secretario | Europa Court Sheffield Business Park S9 1XE Sheffield 6 | 303802480001 | |||||||
| ALLANSON, Stefan Peter | Director | Europa Court Sheffield Business Park S9 1XE Sheffield 6 United Kingdom | England | British | 199827230001 | |||||
| PROTHERO, Graham | Director | Europa Court Sheffield Business Park S9 1XE Sheffield 6 | United Kingdom | British | 175527950001 | |||||
| ASHMORE, Justine Inez | Secretario | 62a North Walls SO23 8DP Winchester Hampshire | British | 105482530003 | ||||||
| BALDRY, Joy Elizabeth | Secretario | Talisman Close RG45 6JE Crowthorne Bedrock Berkshire | British | 128661410001 | ||||||
| LAWRIE, Edwin John | Secretario | 25 Downside Road SM2 5HR Sutton Surrey | British | 21957820002 | ||||||
| MARTIN, Alan Christopher | Secretario | Europa Court Sheffield Business Park S9 1XE Sheffield 6 United Kingdom | British | 161308160001 | ||||||
| MCLELLAN, Colin Warnock | Secretario | 50 Clarence Road TW11 0BW Teddington Middlesex | British | 20961750001 | ||||||
| SEYMOUR, Stuart Leslie | Secretario | 44 Reigate Road East Ewell KT17 1PX Epsom Surrey | British | 46760780001 | ||||||
| BRUCE, Winston Stanley | Director | 2 Up Fallow Lychpit RG24 8YW Basingstoke Hampshire | British | 18278470001 | ||||||
| CHAMBERLIN, Scott Arthur | Director | Europa Court Sheffield Business Park S9 1XE Sheffield 6 United Kingdom | United Kingdom | British | 82479330002 | |||||
| DUNLOP, Roger Napier | Director | Setherum House Benham Park Marsh Benham RG20 8LX Newbury Berkshire | United Kingdom | British | 68979710001 | |||||
| EDGINGTON, Richard Alan | Director | Ashleigh Main Road Great Haywood ST18 0SU Stafford | England | British | 81884240001 | |||||
| EYRE, David Alan | Director | Walnut Cottage East Lane KT24 6HQ West Horsley Surrey | British | 20983450001 | ||||||
| FISHER, Howard Linden | Director | Ryecroft 16 Fernlea Bookham KT23 3NN Leatherhead Surrey | British | 62704690001 | ||||||
| GLEESON, Dermot James | Director | Europa Court Sheffield Business Park S9 1XE Sheffield 6 United Kingdom | United Kingdom | British | 20983460001 | |||||
| GLEESON, Dermot James | Director | Hook Farm White Hart Lane Wood Street Village GU3 3EA Guildford Surrey | United Kingdom | British | 20983460001 | |||||
| GLEESON, John Patrick | Director | 4 South Side SW19 4TG London | British | 21434050001 | ||||||
| GLEESON, Patrick Joseph | Director | 160 Sandy Lane Cheam SM2 7ES Sutton Surrey | British | 20961790001 | ||||||
| GREEN, David Martyn Jackson | Director | Little Kingshill HP16 0EL Great Missenden 4 Longfield Bucks | England | British | 139794240001 | |||||
| HARRISON, Jolyon Leonard | Director | Europa Court Sheffield Business Park S9 1XE Sheffield 6 United Kingdom | United Kingdom | British | 58843110002 | |||||
| HOGGETT, William Henry | Director | 2 Juniper Close Silsoe MK45 4EG Bedford Bedfordshire | British | 9860530001 | ||||||
| HOLT, Nicholas Christopher | Director | 1 Dynevor Road TW10 6PF Richmond Upon Thames Surrey | England | British | 10758310003 | |||||
| KEMP, Mark Andrew | Director | 6 Ibworth Lane GU51 1AU Fleet Hampshire | England | British | 90131740004 | |||||
| LAWRIE, Edwin John | Director | 25 Downside Road SM2 5HR Sutton Surrey | United Kingdom | British | 21957820002 | |||||
| LAWRIE, Edwin John | Director | 25 Downside Road SM2 5HR Sutton Surrey | United Kingdom | British | 21957820002 | |||||
| MARTIN, Alan Christopher | Director | Europa Court Sheffield Business Park S9 1XE Sheffield 6 United Kingdom | United Kingdom | British | 89694100002 | |||||
| MASSINGHAM, Terence William | Director | The Triangle Winchester Road SO32 2AJ Durley Hampshire | British | 122371100001 | ||||||
| MCLELLAN, Colin Warnock | Director | 50 Clarence Road TW11 0BW Teddington Middlesex | British | 20961750001 | ||||||
| MUNCEY, Andrew Richard | Director | Foot Tracks Burnt Oak Road TN6 3SJ Crowborough East Sussex | England | British | 104629610001 | |||||
| PETERS, Stephen William | Director | 13 Broomfield Road KT5 9AZ Surbiton Surrey | United Kingdom | British | 65745290001 | |||||
| THOMSON, James Michael Douglas | Director | Europa Court Sheffield Business Park S9 1XE Sheffield 6 United Kingdom | England | British | 71716020002 | |||||
| WALLS, John Finlay | Director | Springfield House GU8 Dunsfold Surrey | British | 32372090001 | ||||||
| WALLWORK, Paul Anthony Hewitt | Director | Spring Barn Main Street Yarwell PE8 6PR Peterborough Cambridgeshire | British | 113014520002 | ||||||
| WILDING, Clive Michael | Director | 16 Mill Drove TN22 5AB Uckfield East Sussex | United Kingdom | British | 32960240002 |
¿Quiénes son las personas con control significativo de GLEESON DEVELOPMENTS LIMITED?
| Nombre | Notificado el | Dirección | Cesado | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mj Gleeson Plc | 06 abr 2016 | Europa Court Sheffield Business Park S9 1XE Sheffield 6 United Kingdom | No | ||||||||||
| |||||||||||||
Naturaleza del control
| |||||||||||||
Fuente de datos
- Companies House del Reino Unido
El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros. - Licencia: CC0