NEWMARKET FOODS LIMITED

NEWMARKET FOODS LIMITED

  • Visión general
  • Resumen
  • Propósito
  • Dirección
  • Nombres anteriores
  • Cuentas
  • Presentaciones
  • Directivos
  • Gravámenes
  • Insolvencia
  • Fuente de datos
  • Visión general

    Nombre de la empresaNEWMARKET FOODS LIMITED
    Estado de la empresaDisuelta
    Forma jurídicaSociedad de responsabilidad limitada
    Número de empresa 00856471
    JurisdicciónInglaterra/Gales
    Fecha de constitución
    Fecha de cese

    Resumen

    Tiene PSCs súper segurosNo
    Tiene gravámenes
    Tiene historial de insolvencia
    La sede social está en disputaNo

    ¿Cuál es el propósito de NEWMARKET FOODS LIMITED?

    • (0111) /
    • (0122) /

    ¿Dónde se encuentra NEWMARKET FOODS LIMITED?

    Dirección de la sede social
    Malton Bacon Factory Hugden Way
    Norton Grove Industrial Estate
    YO17 9HG Malton
    North Yorkshire
    Dirección de la sede social no entregableNo

    ¿Cuáles fueron los nombres anteriores de NEWMARKET FOODS LIMITED?

    Nombres anteriores de la empresa
    Nombre de la empresaDesdeHasta
    ISANDCO FPF REALISATIONS LIMITED07 nov 199607 nov 1996
    FAVOR PARKER FARMS LIMITED27 ene 198727 ene 1987
    FAVOR PARKER PIGS LIMITED17 ago 198417 ago 1984
    BAXTER PARKER LIMITED31 dic 197831 dic 1978
    FAVOR PARKER LIVESTOCK LIMITED11 ago 196511 ago 1965

    ¿Cuáles son las últimas cuentas de NEWMARKET FOODS LIMITED?

    Últimas cuentas
    Últimas cuentas cerradas hasta22 nov 2008

    ¿Cuáles son las últimas presentaciones para NEWMARKET FOODS LIMITED?

    Presentaciones
    FechaDescripciónDocumentoTipo

    Gaceta final disuelta tras la liquidación

    1 páginasGAZ2

    Declaración de recibos y pagos del liquidador hasta 18 abr 2011

    3 páginas4.68

    Devolución de la reunión final en una liquidación voluntaria de miembros

    4 páginas4.71

    Nombramiento de Tmf Corporate Administration Services Limited como secretario

    2 páginasAP04

    Cese del nombramiento de Mawlaw Secretaries Limited como secretario

    1 páginasTM02

    La dirección de inspección del registro se ha cambiado de 201 Bishopsgate London EC2M 3AF

    1 páginasAD02

    Domicilio social registrado cambiado de Malton Bacon Factory Hugden Way Norton Grove Industrial Estate Malton North Yorkshire YO17 9HG el 06 ene 2011

    2 páginasAD01

    Declaración de solvencia

    6 páginas4.70

    Nombramiento de un liquidador voluntario

    1 páginas600

    Resoluciones

    Resolutions
    1 páginasRESOLUTIONS
    Acuerdos
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    liquidation

    Acuerdo especial para la liquidación el 15 dic 2010

    LRESSP

    Déclaration annuelle établie au 08 sept 2010 avec liste complète des actionnaires

    6 páginasAR01
    Presentaciones asociadas
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    capital08 sept 2010

    Estado de capital el 08 sept 2010

    • Capital: GBP 2,000,000
    SH01

    Cese del nombramiento de Antonius Lammers como director

    1 páginasTM01

    Nombramiento de Mr Louis Antoine Maria Vernaus como director

    2 páginasAP01

    Cambio de datos del director Stephen Ronald William Francis el 01 oct 2009

    3 páginasCH01

    Cambio de datos del director Antonius Matheus Maria Lammers el 01 oct 2009

    3 páginasCH01

    La dirección de inspección del registro se ha cambiado

    2 páginasAD02

    legacy

    4 páginas363a

    legacy

    1 páginas225

    Cuentas completas preparadas hasta el 22 nov 2008

    11 páginasAA

    legacy

    1 páginas353

    legacy

    1 páginas288a

    legacy

    1 páginas288c

    legacy

    1 páginas288c

    legacy

    1 páginas288c

    legacy

    1 páginas288c

    ¿Quiénes son los directivos de NEWMARKET FOODS LIMITED?

    Directivos
    NombreNombrado elRenunció elRolDirecciónIdentificación de la empresaPaís de residenciaNacionalidadFecha de nacimientoOcupaciónNúmero
    TMF CORPORATE ADMINISTRATION SERVICES LIMITED
    1st Floor
    9 Cloak Lane
    EC4R 2RU London
    Pellipar House
    United Kingdom
    Secretario corporativo
    1st Floor
    9 Cloak Lane
    EC4R 2RU London
    Pellipar House
    United Kingdom
    Tipo de identificaciónEEE
    Número de registro06902863
    140723560001
    CHRISTIAANSE, Anthony Martin
    3065 Sc Rotterdam
    's-Gravenweg 551
    The Netherlands
    Director
    3065 Sc Rotterdam
    's-Gravenweg 551
    The Netherlands
    Dutch129239540002
    FRANCIS, Stephen Ronald William
    Bain Square
    Kirkton Campus
    EH54 7DQ Livingston
    7
    Director
    Bain Square
    Kirkton Campus
    EH54 7DQ Livingston
    7
    EnglandBritish105961550001
    VERNAUS, Louis Antoine Maria
    Bain Square
    Kirkton Campus
    EH54 7DQ Livingston
    7
    United Kingdom
    Director
    Bain Square
    Kirkton Campus
    EH54 7DQ Livingston
    7
    United Kingdom
    NetherlandsDutch146206430001
    ROXBURGH, Roy
    515 North Deeside Road
    Cults
    AB15 9ES Aberdeen
    Aberdeenshire
    Secretario
    515 North Deeside Road
    Cults
    AB15 9ES Aberdeen
    Aberdeenshire
    British194640001
    TROLLOPE, Barry Desmond
    Orchard House Furlong Road
    Stoke Ferry
    PE33 9SU Kings Lynn
    Norfolk
    Secretario
    Orchard House Furlong Road
    Stoke Ferry
    PE33 9SU Kings Lynn
    Norfolk
    British45609870001
    IAIN SMITH AND COMPANY
    18-20 Queen's Road
    AB15 4ZT Aberdeen
    Grampian
    Secretario corporativo
    18-20 Queen's Road
    AB15 4ZT Aberdeen
    Grampian
    93547510001
    MACLAY MURRAY & SPENS LLP
    66 Queen's Road
    AB15 4YE Aberdeen
    Secretario corporativo
    66 Queen's Road
    AB15 4YE Aberdeen
    119967690001
    MAWLAW SECRETARIES LIMITED
    Bishopsgate
    EC2M 3AF London
    201
    Secretario corporativo
    Bishopsgate
    EC2M 3AF London
    201
    39182980003
    ALLEN, Geoffrey Gordon
    Serenity Wretton Road
    Stoke Ferry
    PE33 9SN Kings Lynn
    Norfolk
    Director
    Serenity Wretton Road
    Stoke Ferry
    PE33 9SN Kings Lynn
    Norfolk
    British15877490001
    COLES, Philip Charles John
    55 West End Crosshill Cottage
    Northwold
    IP26 5LE Thetford
    Norfolk
    Director
    55 West End Crosshill Cottage
    Northwold
    IP26 5LE Thetford
    Norfolk
    British47148220001
    DUNCAN, Alfred John
    Saetra House
    Inchmarlo Road
    AB31 3RR Banchory
    Aberdeenshire
    Director
    Saetra House
    Inchmarlo Road
    AB31 3RR Banchory
    Aberdeenshire
    United KingdomBritish402690001
    HOLMES, William Brian
    3 Cedar Grove
    North Runcton
    PE33 0QY Kings Lynn
    Norfolk
    Director
    3 Cedar Grove
    North Runcton
    PE33 0QY Kings Lynn
    Norfolk
    British15877510001
    IMRAY, Iain Murray
    41 Hammersmith Road
    AB10 6NA Aberdeen
    Aberdeenshire
    Director
    41 Hammersmith Road
    AB10 6NA Aberdeen
    Aberdeenshire
    United KingdomBritish63444910001
    LAMMERS, Antonius Matheus Maria
    7005-7023
    5692 Hb Son En Breugel
    Ekkersrijt
    The Netherlands
    Director
    7005-7023
    5692 Hb Son En Breugel
    Ekkersrijt
    The Netherlands
    Dutch126350570004
    PARIS, Walter Walker
    21 Hillview Road
    AB31 4EG Banchory
    Kincardineshire
    Scotland
    Director
    21 Hillview Road
    AB31 4EG Banchory
    Kincardineshire
    Scotland
    British338220001
    PARKER, Benjamin James
    Gooderstone Manor
    Gooderstone
    PE33 9BP Kings Lynn
    Norfolk
    Director
    Gooderstone Manor
    Gooderstone
    PE33 9BP Kings Lynn
    Norfolk
    British17414200001
    PARKER, John Gordon
    Clavering House
    Oxborough
    PE33 9BL Kings Lynn
    Norfolk
    Director
    Clavering House
    Oxborough
    PE33 9BL Kings Lynn
    Norfolk
    British15877480001
    PARKER, Michael Joseph Bennett
    The Hall
    Stoke Ferry
    PE33 9SE Kings Lynn
    Norfolk
    Director
    The Hall
    Stoke Ferry
    PE33 9SE Kings Lynn
    Norfolk
    British12897020001
    ROCHE, Nicholas James
    Grove Cottage Mellis Road
    Yaxley
    IP23 8DB Eye
    Suffolk
    Director
    Grove Cottage Mellis Road
    Yaxley
    IP23 8DB Eye
    Suffolk
    EnglandBritish15836170001
    STEPHEN, Andrew Michael Duthie
    Speymuir 3 Victoria Street
    AB53 4RE Turriff
    Aberdeenshire
    Scotland
    Director
    Speymuir 3 Victoria Street
    AB53 4RE Turriff
    Aberdeenshire
    Scotland
    ScotlandBritish338210001

    ¿Tiene NEWMARKET FOODS LIMITED alguna carga?

    Gravámenes
    ClasificaciónFechasEstadoDetalles
    An intercreditor and security agreement
    Creado el 30 may 2007
    Entregado el 13 jun 2007
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from any obligor to any restructuring creditor and the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descripción
    All of its right to and title and interest (if any) from time to time to the deposits. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland as Security Trustee
    Transacciones
    • 13 jun 2007Registro de un cargo (395)
    • 25 sept 2008Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Debenture
    Creado el 29 may 2007
    Entregado el 08 jun 2007
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transacciones
    • 08 jun 2007Registro de un cargo (395)
    • 25 sept 2008Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Collateral debenture
    Creado el 24 ago 1987
    Entregado el 01 sept 1987
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from favor parker limited under the terms of the charge to the chargee on any account whatsoever.
    Breve descripción
    Freehold property k/a the foulden estate, foulden, norfolk stock in trade, work in progress pre-payments investments (please see doc for details). Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personas con derecho
    • Investors in Industry PLC
    Transacciones
    • 01 sept 1987Registro de una carga
    • 29 ago 1996Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Single debenture
    Creado el 24 ago 1987
    Entregado el 26 ago 1987
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    Stocks shares other interests. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personas con derecho
    • Lloyds Bank PLC
    Transacciones
    • 26 ago 1987Registro de una carga
    • 29 ago 1996Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Mortgage of agricultural property
    Creado el 24 ago 1987
    Entregado el 26 ago 1987
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    Freehold property known as or being foulden estate foulden norfolk together with certain rights more particularly described in and comprised in a conveyance dated 27/11/86.
    Personas con derecho
    • Lloyds Bank PLC
    Transacciones
    • 26 ago 1987Registro de una carga
    • 29 ago 1996Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Collateral debenture
    Creado el 11 oct 1977
    Entregado el 14 oct 1977
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies advanced to favor parker livestock limited under an agreement dated 11TH october 1977 and all monies due or to become due from the company to the chargee secured by the debenture dated 11TH october 1977
    Breve descripción
    Fixed and floating charge on the undertaking and all property and assets present and future including goodwill & bookdebets & uncalled capital. See doc M29.
    Personas con derecho
    • Industrial and Commercial Finance Corporation Limited
    Transacciones
    • 14 oct 1977Registro de una carga
    • 29 ago 1996Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Single debenture
    Creado el 30 ago 1974
    Entregado el 11 sept 1974
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    F/H and l/h including all fixtures, goodwill and uncalled capital present and future a floating charge.. Undertaking and all property and assets present and future including uncalled capital.
    Personas con derecho
    • Lloyds Bank LTD
    Transacciones
    • 11 sept 1974Registro de una carga
    • 29 ago 1996Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)

    ¿Tiene NEWMARKET FOODS LIMITED algún caso de insolvencia?

    Número de expedienteFechasTipoProfesionalesOtro
    1
    FechaTipo
    12 ago 2011Fecha de disolución
    15 dic 2010Inicio de la liquidación
    Liquidación voluntaria de socios
    NombreRolDirecciónNombrado elCesado el
    Malcolm Cohen
    Bdo Llp 55 Baker Street
    W1U 7EU London
    Profesional
    Bdo Llp 55 Baker Street
    W1U 7EU London

    Fuente de datos

    • Companies House del Reino Unido
      El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros.
    • Licencia: CC0