TH GLOBAL LIMITED
Visión general
Nombre de la empresa | TH GLOBAL LIMITED |
---|---|
Estado de la empresa | Liquidación |
Forma jurídica | Sociedad de responsabilidad limitada |
Número de empresa | 00867281 |
Jurisdicción | Inglaterra/Gales |
Fecha de constitución |
Resumen
Tiene PSCs súper seguros | No |
---|---|
Tiene gravámenes | Sí |
Tiene historial de insolvencia | Sí |
La sede social está en disputa | No |
¿Cuál es el propósito de TH GLOBAL LIMITED?
- Actividades de otras sociedades holding n.c.o.p. (64209) / Actividades financieras y de seguros
¿Dónde se encuentra TH GLOBAL LIMITED?
Dirección de la sede social | Forvis Mazars Llp 30 Old Bailey EC4M 7AU London |
---|---|
Dirección de la sede social no entregable | No |
¿Cuáles fueron los nombres anteriores de TH GLOBAL LIMITED?
Nombre de la empresa | Desde | Hasta |
---|---|---|
TH GLOBAL PLC | 20 mar 2006 | 20 mar 2006 |
KVAERNER PLC | 15 dic 2004 | 15 dic 2004 |
AKER KVAERNER PLC | 17 sept 2003 | 17 sept 2003 |
KVAERNER PLC | 18 sept 1996 | 18 sept 1996 |
TRAFALGAR HOUSE PUBLIC LIMITED COMPANY | 31 dic 1977 | 31 dic 1977 |
TRAFALGAR HOUSE INVESTMENTS LIMITED | 22 dic 1965 | 22 dic 1965 |
¿Cuáles son las últimas cuentas de TH GLOBAL LIMITED?
Vencido | Sí |
---|---|
Próximas cuentas | |
Próximo período contable finaliza el | 31 dic 2017 |
Próximas cuentas vencen el | 30 sept 2018 |
Últimas cuentas | |
Últimas cuentas cerradas hasta | 31 dic 2016 |
¿Cuál es el estado de la última declaración de confirmación para TH GLOBAL LIMITED?
Vencido | Sí |
---|---|
Última declaración de confirmación cerrada hasta | 31 ene 2019 |
Próxima declaración de confirmación vence | 14 feb 2019 |
Última declaración de confirmación | |
Próxima declaración de confirmación cerrada hasta | 31 ene 2018 |
Vencido | Sí |
¿Cuáles son las últimas presentaciones para TH GLOBAL LIMITED?
Fecha | Descripción | Documento | Tipo | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Declaración de recibos y pagos del liquidador hasta 30 sept 2024 | 13 páginas | LIQ03 | ||||||||||
Domicilio social registrado cambiado de 30 Old Bailey London EC4M 7AU a Forvis Mazars Llp 30 Old Bailey London EC4M 7AU el 26 jul 2024 | 4 páginas | AD01 | ||||||||||
Declaración de recibos y pagos del liquidador hasta 30 sept 2023 | 11 páginas | LIQ03 | ||||||||||
Declaración de recibos y pagos del liquidador hasta 30 sept 2022 | 11 páginas | LIQ03 | ||||||||||
Domicilio social registrado cambiado de Tower Bridge House St Katharines Way London E1W 1DD a 30 Old Bailey London EC4M 7AU el 11 may 2022 | 2 páginas | AD01 | ||||||||||
Nombramiento de un liquidador voluntario | 3 páginas | 600 | ||||||||||
Destitución del liquidador por orden judicial | 16 páginas | LIQ10 | ||||||||||
Declaración de recibos y pagos del liquidador hasta 30 sept 2021 | 10 páginas | LIQ03 | ||||||||||
Declaración de recibos y pagos del liquidador hasta 30 sept 2020 | 10 páginas | LIQ03 | ||||||||||
Declaración de recibos y pagos del liquidador hasta 30 sept 2019 | 10 páginas | LIQ03 | ||||||||||
Declaración de asuntos | 15 páginas | LIQ02 | ||||||||||
Nombramiento de un liquidador voluntario | 3 páginas | 600 | ||||||||||
Resoluciones Resolutions | 1 páginas | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Domicilio social registrado cambiado de Betchworth House 57-65 Station Road Redhill Surrey RH1 1DL United Kingdom a Tower Bridge House St Katharines Way London E1W 1DD el 12 sept 2018 | 2 páginas | AD01 | ||||||||||
Declaración de confirmación presentada el 31 ene 2018 con actualizaciones | 13 páginas | CS01 | ||||||||||
Cuentas de exención total completas preparadas hasta el 31 dic 2016 | 14 páginas | AA | ||||||||||
Modification des détails de Spinaker Limited en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 21 ago 2017 | 2 páginas | PSC05 | ||||||||||
Domicilio social registrado cambiado de Surrey House 36-44 High Street Redhill Surrey RH1 1RH a Betchworth House 57-65 Station Road Redhill Surrey RH1 1DL el 31 jul 2017 | 1 páginas | AD01 | ||||||||||
Declaración de confirmación presentada el 31 ene 2017 con actualizaciones | 29 páginas | CS01 | ||||||||||
Cuentas de exención total completas preparadas hasta el 31 dic 2015 | 16 páginas | AA | ||||||||||
Déclaration annuelle établie au 31 ene 2016 avec liste complète des actionnaires | 29 páginas | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Cuentas de exención total completas preparadas hasta el 31 dic 2014 | 17 páginas | AA | ||||||||||
Cambio de datos del director Leif Christian Salomonsen el 14 abr 2015 | 3 páginas | CH01 | ||||||||||
Déclaration annuelle établie au 31 ene 2015 avec liste complète des actionnaires | 26 páginas | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Cuentas de exención total completas preparadas hasta el 31 dic 2013 | 14 páginas | AA | ||||||||||
¿Quiénes son los directivos de TH GLOBAL LIMITED?
Nombre | Nombrado el | Renunció el | Rol | Dirección | Identificación de la empresa | País de residencia | Nacionalidad | Fecha de nacimiento | Ocupación | Número |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LAYCOCK, Rufus | Secretario | 30 Old Bailey EC4M 7AU London Forvis Mazars Llp | British | 7584610001 | ||||||
NILSEN, Runar | Director | 30 Old Bailey EC4M 7AU London Forvis Mazars Llp | Norwegian | President & Ceo | 102391880002 | |||||
SALOMONSEN, Leif Christian | Director | 30 Old Bailey EC4M 7AU London Forvis Mazars Llp | Norway | Norwegian | Non Executive Director | 101624340007 | ||||
WITTUSEN, Dag Fasmer | Director | 30 Old Bailey EC4M 7AU London Forvis Mazars Llp | Norwegian | Company Director | 100360490001 | |||||
ARNKVAERN, Anders | Secretario | 5 Ernle Road SW20 0HH London | Norwegian | 49759930002 | ||||||
ERIKSRUD, Eystein | Secretario | Flat 14 Pier House Cheyne Walk SW3 5HG London | British | 72707990001 | ||||||
FOWLER, Ian | Secretario | 32 Newton Road W2 5LT London | British | 41294100001 | ||||||
HAUGSTAD, Hans | Secretario | 3 Lambourne Avenue SW19 7DW London | Norwegian | Lawyer | 62179360001 | |||||
ALMSKOG, Kjell | Director | 7 Prospect Place SW20 0JP London | Norwegian | President & Chief Executive | 71853090003 | |||||
ANSDELL, John Reginald Wardhaugh | Director | 17 Randolph Avenue W9 1BH London | British | Chartered Accountant | 5094500001 | |||||
BERG JACOBSEN, Finn | Director | Gabelsgate 11 FOREIGN Oslo N 0272 Norway | Norway | Norwegian | Cfo | 78676710001 | ||||
BROWN, Richard | Director | 22 Saint James Road Little Paxton PE19 6QW St. Neots Cambridgeshire | England | British | Evp Human Resources | 105373250001 | ||||
CALVERLEY, David | Director | Four Winds House Pitch Hill Ewhurst GU6 7NL Cranleigh Surrey | British | Chartered Accountant | 4527360001 | |||||
CHARLTON, John Michael | Director | Dunstone 5 Broomfield Ride KT22 0LR Oxshott Surrey | England | British | Cfo | 73081460001 | ||||
CLEMENTS, Alan William | Director | Wildbriar 41 Shirley Hills Road CR0 7HQ Croydon Surrey | British | Company Director | 5575140001 | |||||
EVANS, Richard Harry, Sir | Director | Flat 2 The Byfrons House Boundary Road GU14 6SE Farnborough Hampshire | British | Chief Executive | 6694960003 | |||||
FINNE, Hans Petter | Director | 32 Gloucester Walk W8 4HY London | Norwegian | Company Director | 50130950001 | |||||
FLETCHER, John Wilfred Sword | Director | House B 36 Island Road Deepwater Bay Hong Kong Sar Pr China | British | Civil Engineer | 69869500001 | |||||
FOREID, Steffen | Director | Stensgaten 27 FOREIGN Oslo 0358 Norway | Norwegian | Non Executive Director | 102271580001 | |||||
FORSTER, Archibald William, Sir | Director | Grasmere Easton SO21 1EG Winchester Hampshire | British | Chairman-Esso Uk Plc | 1900030001 | |||||
FOWLER, Ian | Director | 32 Newton Road W2 5LT London | British | Chartered Accountant | 41294100001 | |||||
GAWLER, David | Director | 76 Park Road TW12 1HP Hampton Hill Middlesex | United Kingdom | South African | Finance Director | 167282630001 | ||||
GORMLY, Allan Graham | Director | 56 North Park SL9 8JR Gerrards Cross Buckinghamshire | British | Chartered Accountant | 1308140001 | |||||
GORMLY, Allan Graham | Director | 56 North Park SL9 8JR Gerrards Cross Buckinghamshire | British | Chartered Accountant | 1308140001 | |||||
GREVE, Jan Mathias | Director | The Strawberry Tree Cavendish Road St Georges Hill KT13 0JT Weybridge Surrey Norway | Norwegian | Company Director | 48350840002 | |||||
HEGGELUND, Jan Magne | Director | 126 Silverdale Avenue KT12 1EH Walton On Thames Surrey | British | Company Director | 67742180002 | |||||
HOWELL, David Arthur Russell, Rt Hon Lord | Director | Flat 1 61 Warwick Square SW1V 2AL London | British | Company Director | 5094540003 | |||||
KESWICK, Simon Lindley | Director | Rockcliffe Upper Slaughter GL54 2JW Cheltenham Gloucestershire | England | British | Merchant | 41736630003 | ||||
LEACH, Charles Guy Rodney, Lord | Director | Clarendon Road W11 4JB London 15 | United Kingdom | British | Merchant And Banker | 4247280001 | ||||
MCDERMOTT, Dermot St John | Director | 8 Grange Road W4 4DA London | British | Company Director | 35751350001 | |||||
MISUND, Anders | Director | Niels Juels Gate 38 FOREIGN Oslo 0257 Norway | Norwegian | Non Executive Director | 105847420003 | |||||
MYERS, Barry | Director | Boundless Farm Park Lane Brook GU8 5LF Godalming Surrey | British | Company Director | 33331830001 | |||||
OLSEN, Hans Ebenedict | Director | 65/69 Mount Kellet Road Town House M Hong Kong | British | Business Executive | 78045000002 | |||||
PARKER, Eric Wilson, Sir | Director | Crimbourne House Crimbourne Lane Green Wisborough RH14 0HR Billingshurst West Sussex | England | British | Company Director | 36208980001 | ||||
POWELL OF BAYSWATER, Charles, Lord | Director | 1 Caroline Close W2 4RW London | England | British | Company Director | 69244580004 |
¿Quiénes son las personas con control significativo de TH GLOBAL LIMITED?
Nombre | Notificado el | Dirección | Cesado | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spinaker Limited | 06 abr 2016 | 57-65 Station Road RH1 1DL Redhill Betchworth House Surrey United Kingdom | No | ||||||||||
| |||||||||||||
Naturaleza del control
|
¿Tiene TH GLOBAL LIMITED alguna carga?
Clasificación | Fechas | Estado | Detalles | |
---|---|---|---|---|
Share security agreement | Creado el 07 ene 2002 Adquirido el 31 dic 2003 Entregado el 20 ene 2004 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All monies due or to beome due from the company to the senior finance parties (as defined) under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Breve descripción By way of first fixed charge 2,000,002 ordinary shares of gbp 1 each and 71,000,000 redeemable preference shares of gbp 0.01 each (together shares) in the capital kvaerner international limited and by way of first fixed charge any dividend or interest paid or payable in relation to any shares. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
Deposit agreement and charge on cash deposits | Creado el 30 sept 1998 Entregado el 20 oct 1998 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All monies due or to become due from the company to the chargee under or pursuant to the facility letter dated 4TH september 1998 as amended from time to time in any manner whatsoever and whether alone or jointly with any other person | |
Breve descripción Us$6,000,000 deposited or to be deposited by the company with the bank and all other sums from time to time standing to the credit of the company's account no 248 000 04 00 13 634. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
Charge over book debts. | Creado el 24 oct 1989 Entregado el 07 nov 1989 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada The "subordinated indebtedness" payable by tates cairn tunnel company limited to the shareholders under the provisions of the shareholder support agreement dated 24TH october 1989 and the guarantee agreements as defined therein | |
Breve descripción Book debts constituting the subordinated indebtedness. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
|
¿Tiene TH GLOBAL LIMITED algún caso de insolvencia?
Número de expediente | Fechas | Tipo | Profesionales | Otro | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
| Liquidación voluntaria de acreedores |
|
Fuente de datos
- Companies House del Reino Unido
El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros. - Licencia: CC0