TIBBETT & BRITTEN APPLIED LIMITED
Visión general
| Nombre de la empresa | TIBBETT & BRITTEN APPLIED LIMITED |
|---|---|
| Estado de la empresa | Disuelta |
| Forma jurídica | Sociedad de responsabilidad limitada |
| Número de empresa | 00868498 |
| Jurisdicción | Inglaterra/Gales |
| Fecha de constitución | |
| Fecha de cese |
Resumen
| Tiene PSCs súper seguros | No |
|---|---|
| Tiene gravámenes | Sí |
| Tiene historial de insolvencia | No |
| La sede social está en disputa | No |
¿Cuál es el propósito de TIBBETT & BRITTEN APPLIED LIMITED?
- Transporte de mercancías por carretera (49410) / Transporte y almacenamiento
- Operación de instalaciones de almacenamiento y depósito para actividades de transporte terrestre (52103) / Transporte y almacenamiento
¿Dónde se encuentra TIBBETT & BRITTEN APPLIED LIMITED?
| Dirección de la sede social | Ocean House The Ring RG12 1AN Bracknell Berkshire |
|---|---|
| Dirección de la sede social no entregable | No |
¿Cuáles fueron los nombres anteriores de TIBBETT & BRITTEN APPLIED LIMITED?
| Nombre de la empresa | Desde | Hasta |
|---|---|---|
| APPLIED DISTRIBUTION LIMITED | 03 mar 1989 | 03 mar 1989 |
| GEEST DISTRIBUTION LIMITED | 02 sept 1988 | 02 sept 1988 |
| GROUND'S TRANSPORT (BOSTON) LIMITED | 10 ene 1966 | 10 ene 1966 |
¿Cuáles son las últimas cuentas de TIBBETT & BRITTEN APPLIED LIMITED?
| Últimas cuentas | |
|---|---|
| Últimas cuentas cerradas hasta | 31 dic 2019 |
¿Cuáles son las últimas presentaciones para TIBBETT & BRITTEN APPLIED LIMITED?
| Fecha | Descripción | Documento | Tipo | |
|---|---|---|---|---|
Boletín oficial final disuelto por cancelación voluntaria | 1 páginas | GAZ2(A) | ||
Primer aviso en el boletín oficial para la cancelación voluntaria | 1 páginas | GAZ1(A) | ||
Solicitud de exclusión de la empresa del registro | 1 páginas | DS01 | ||
Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 31 dic 2019 | 3 páginas | AA | ||
Declaración de confirmación presentada el 01 jun 2020 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||
Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 31 dic 2018 | 3 páginas | AA | ||
Declaración de confirmación presentada el 01 jun 2019 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||
Cese del nombramiento de Jane Li como secretario el 31 dic 2018 | 1 páginas | TM02 | ||
Nombramiento de Mr Steven Fink como director el 26 nov 2018 | 2 páginas | AP01 | ||
Cessation de Jane Li en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 26 nov 2018 | 1 páginas | PSC07 | ||
Notification de Exel Holdings Limited en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 06 abr 2016 | 2 páginas | PSC02 | ||
Cese del nombramiento de Jane Li como director el 26 nov 2018 | 1 páginas | TM01 | ||
Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 31 dic 2017 | 8 páginas | AA | ||
Cese del nombramiento de James Edward Gill como director el 13 jun 2018 | 1 páginas | TM01 | ||
Cessation de James Edward Gill en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 13 jun 2018 | 1 páginas | PSC07 | ||
Nombramiento de Thorsten Kuhl como director el 13 jun 2018 | 2 páginas | AP01 | ||
Declaración de confirmación presentada el 01 jun 2018 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||
Cuentas de subsidiaria exentas de auditoría preparadas hasta el 31 dic 2016 | 13 páginas | AA | ||
legacy | 192 páginas | PARENT_ACC | ||
legacy | 3 páginas | GUARANTEE2 | ||
legacy | 1 páginas | AGREEMENT2 | ||
Declaración de confirmación presentada el 01 jun 2017 con actualizaciones | 6 páginas | CS01 | ||
Nombramiento de Mr James Edward Gill como director el 01 abr 2017 | 2 páginas | AP01 | ||
Cese del nombramiento de Keith Roy Smith como director el 31 mar 2017 | 1 páginas | TM01 | ||
Cese del nombramiento de Michael James Trimm como director el 09 dic 2016 | 1 páginas | TM01 | ||
¿Quiénes son los directivos de TIBBETT & BRITTEN APPLIED LIMITED?
| Nombre | Nombrado el | Renunció el | Rol | Dirección | Identificación de la empresa | País de residencia | Nacionalidad | Fecha de nacimiento | Ocupación | Número | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FINK, Steven | Director | Ocean House The Ring RG12 1AN Bracknell Berkshire | England | British | 158324340001 | |||||||||
| KUHL, Thorsten | Director | Ocean House The Ring RG12 1AN Bracknell Berkshire | Germany | German | 247678730001 | |||||||||
| ARROWSMITH, Michael Richard | Secretario | Greenbanks 154 Piccotts End Road HP1 3AU Hemel Hempstead Hertfordshire | British | 64948610002 | ||||||||||
| AUSTIN, Keith James | Secretario | Little Orchard House 41 New Road Tylers Green HP10 8DN High Wycombe Buckinghamshire | British | 69617780001 | ||||||||||
| AUSTIN, Keith James | Secretario | Little Orchard House 41 New Road Tylers Green HP10 8DN High Wycombe Buckinghamshire | British | 69617780001 | ||||||||||
| GRAY, Roderick James | Secretario | 5 Gresham Close RH8 0BH Oxted Surrey | British | 10767150002 | ||||||||||
| LI, Jane | Secretario | Ocean House The Ring RG12 1AN Bracknell Company Secretary Berkshire England | 203503560001 | |||||||||||
| MILLS, John Michael | Secretario | 103 Moffats Lane AL9 7RP Brookmans Park Hertfordshire | British | 193353200001 | ||||||||||
| SMITH, Nicholas Leigh | Secretario | 34 Castle Hill Avenue HP4 1HJ Berkhamsted Hertfordshire | British | 45625440002 | ||||||||||
| STALBOW, Michael Robert | Secretario | 38 St Marys Avenue HA6 3AZ Northwood Middlesex | British | 15165070001 | ||||||||||
| EXEL SECRETARIAL SERVICES LIMITED | Secretario corporativo | The Ring RG12 1AN Bracknell Ocean House Berkshire United Kingdom |
| 32524900007 | ||||||||||
| ARROWSMITH, Michael Richard | Director | Greenbanks 154 Piccotts End Road HP1 3AU Hemel Hempstead Hertfordshire | England | British | 64948610002 | |||||||||
| AUSTIN, Keith James | Director | Little Orchard House 41 New Road Tylers Green HP10 8DN High Wycombe Buckinghamshire | England | British | 69617780001 | |||||||||
| BRABENDER, Murray Robert Malcolm | Director | 19 Phoenix Drive Wateringbury ME18 5DR Maidstone Kent | British | 50169470001 | ||||||||||
| BROWN, David | Director | Dunvegan Devonburn ML11 9PU Lesmahagow Lanarkshire | British | 15524300001 | ||||||||||
| BUMSTEAD, Jonathan Culver | Director | Eastland Cottage Hall Place GU6 8LA Cranleigh Surrey | United Kingdom | British | 72820970001 | |||||||||
| BUTT, Kenneth Thomas John | Director | Hatchfield House Epsom Road, West Horsley KT24 6DX Leatherhead Surrey | United Kingdom | British | 80963930001 | |||||||||
| CAMERON, Ian, Mr. | Director | 66 High Street Stagsden MK43 8SQ Bedford Gamekeepers Cottage England | England | British | 164576100001 | |||||||||
| COOKE, Gordon Leslie | Director | 92 High Street Wrestlingworth SG19 2EJ Sandy Bedfordshire | British | 34718600001 | ||||||||||
| DAVIS, Leonard John | Director | 25 Hathaway Court ME1 1QX Rochester Kent | British | 15524310001 | ||||||||||
| ELLIS, Michael John | Director | Little Trodgers Honor End Lane, Prestwood HP16 9HG Buckinghamshire | England | British | 133791220001 | |||||||||
| FERGUSON, Peter | Director | 39 Pickering Street Loose ME15 9RS Maidstone Kent | British | 15524290001 | ||||||||||
| GILL, James Edward | Director | Ocean House The Ring RG12 1AN Bracknell Berkshire | England | British | 165998750001 | |||||||||
| GRAY, Roderick James | Director | 5 Gresham Close RH8 0BH Oxted Surrey | British | 10767150002 | ||||||||||
| HEAL, Stephen Alan | Director | The Paddocks Drove Road Gamlingay SG19 3NY Sandy Bedfordshire | United Kingdom | British | 42087770001 | |||||||||
| HOWES, David William | Director | Old Walls Birdingbury Road, Leamington Hasting CV23 8EB Rugby Warwickshire | British | 53711750001 | ||||||||||
| LI, Jane | Director | Ocean House The Ring RG12 1AN Bracknell Berkshire | United Kingdom | British | 134292740003 | |||||||||
| MANN, Roger Michael Ewart | Director | Ocean House The Ring RG12 1AN Bracknell Berkshire | United Kingdom | British | 15476780001 | |||||||||
| MATHIAS, Alfred Robert | Director | Trillick Furzedown Lane Amport SP11 8BW Andover Hampshire | British | 9433680001 | ||||||||||
| PALMER, Martin Robert | Director | 9 Maple Road OX9 2BH Thame Oxfordshire | British | 45138540001 | ||||||||||
| ROWLEY, Michael James | Director | 6 The Depository Rock Villa Road TN1 1HA Tunbridge Wells Kent | England | British | 10767160002 | |||||||||
| SEY, Kevin Paul | Director | Ocean House The Ring RG12 1AN Bracknell Berkshire | England | British | 186787040001 | |||||||||
| SMITH, Jamie Robert Mark | Director | Tanglewood 33 Woodend Drive SL5 9BD Sunninghill Berkshire | United Kingdom | British | 74084830002 | |||||||||
| SMITH, Keith Roy | Director | Ocean House The Ring RG12 1AN Bracknell Berkshire | England | British | 140889200001 | |||||||||
| STALBOW, Michael Robert | Director | 38 St Marys Avenue HA6 3AZ Northwood Middlesex | England | British | 15165070001 |
¿Quiénes son las personas con control significativo de TIBBETT & BRITTEN APPLIED LIMITED?
| Nombre | Notificado el | Dirección | Cesado | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mrs Jane Li | 01 jun 2017 | Ocean House The Ring RG12 1AN Bracknell Berkshire | Sí | ||||||||||
Nacionalidad: British País de residencia: United Kingdom | |||||||||||||
Naturaleza del control
| |||||||||||||
| Mr James Edward Gill | 01 jun 2017 | Ocean House The Ring RG12 1AN Bracknell Berkshire | Sí | ||||||||||
Nacionalidad: British País de residencia: England | |||||||||||||
Naturaleza del control
| |||||||||||||
| Exel Holdings Limited | 06 abr 2016 | The Ring RG12 1AN Bracknell Ocean House Berkshire England | No | ||||||||||
| |||||||||||||
Naturaleza del control
| |||||||||||||
¿Tiene TIBBETT & BRITTEN APPLIED LIMITED alguna carga?
| Clasificación | Fechas | Estado | Detalles | |
|---|---|---|---|---|
| Assignment | Creado el 26 abr 1996 Entregado el 01 may 1996 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of an agreement dated 23RD february 1996 numbered 47.170.19.111372 and this assignment | |
Breve descripción All monies due under the "assigned agreements" (as defined). See the mortgage charge document for full details. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
| Debenture | Creado el 22 jun 1994 Entregado el 12 jul 1994 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Breve descripción Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
| Standard security | Creado el 02 mar 1989 Entregado el 14 mar 1989 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of a guarantee dated 14/2/89 and a debenture dated 14/2/89 | |
Breve descripción First fixed charge over all and whole a lease on the north side of old edinburgh road bellshill larnarkshire title no: lan 1159. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
| Debenture | Creado el 14 feb 1989 Entregado el 20 feb 1989 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of a guarantee dated 14.2.89 | |
Breve descripción (See doc. For full details). Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
Fuente de datos
- Companies House del Reino Unido
El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros. - Licencia: CC0