EGERTON HOSPITAL EQUIPMENT LIMITED

EGERTON HOSPITAL EQUIPMENT LIMITED

  • Visión general
  • Resumen
  • Propósito
  • Dirección
  • Cuentas
  • Declaración anual
  • Presentaciones
  • Directivos
  • Gravámenes
  • Fuente de datos
  • Visión general

    Nombre de la empresaEGERTON HOSPITAL EQUIPMENT LIMITED
    Estado de la empresaDisuelta
    Forma jurídicaSociedad de responsabilidad limitada
    Número de empresa 00871878
    JurisdicciónInglaterra/Gales
    Fecha de constitución
    Fecha de cese

    Resumen

    Tiene PSCs súper segurosNo
    Tiene gravámenes
    Tiene historial de insolvenciaNo
    La sede social está en disputaNo

    ¿Cuál es el propósito de EGERTON HOSPITAL EQUIPMENT LIMITED?

    • Compañía no comercial (74990) / Actividades profesionales, científicas y técnicas

    ¿Dónde se encuentra EGERTON HOSPITAL EQUIPMENT LIMITED?

    Dirección de la sede social
    Arjohuntleigh House Houghton Hall Business Park
    Houghton Regis
    LU5 5XF Dunstable
    Bedfordshire
    Dirección de la sede social no entregableNo

    ¿Cuáles son las últimas cuentas de EGERTON HOSPITAL EQUIPMENT LIMITED?

    Últimas cuentas
    Últimas cuentas cerradas hasta31 dic 2013

    ¿Cuál es el estado de la última declaración anual para EGERTON HOSPITAL EQUIPMENT LIMITED?

    Declaración anual
    Última declaración anual

    ¿Cuáles son las últimas presentaciones para EGERTON HOSPITAL EQUIPMENT LIMITED?

    Presentaciones
    FechaDescripciónDocumentoTipo

    Boletín oficial final disuelto por cancelación voluntaria

    1 páginasGAZ2(A)

    Primer aviso en el boletín oficial para la cancelación voluntaria

    1 páginasGAZ1(A)

    Solicitud de exclusión de la empresa del registro

    3 páginasDS01

    legacy

    1 páginasSH20

    Estado de capital el 28 nov 2014

    • Capital: GBP 1
    4 páginasSH19

    legacy

    1 páginasCAP-SS

    Resoluciones

    Resolutions
    1 páginasRESOLUTIONS
    Acuerdos
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    capital

    Resolución de reducción del capital social emitido

    RES06

    Cuentas preparadas hasta el 31 dic 2013

    5 páginasAA

    Déclaration annuelle établie au 31 may 2014 avec liste complète des actionnaires

    4 páginasAR01

    Nombramiento de Mr Christoffer David Erik Franzen como director el 11 jun 2014

    2 páginasAP01

    Nombramiento de Mr Richard Mark Bloom como director el 11 jun 2014

    2 páginasAP01

    Cese del nombramiento de Andrew John Scott Green como director el 11 jun 2014

    1 páginasTM01

    Cuentas preparadas hasta el 31 dic 2012

    5 páginasAA

    Déclaration annuelle établie au 31 may 2013 avec liste complète des actionnaires

    4 páginasAR01

    Cancelación total de la carga 7

    3 páginasMR04

    Cancelación total de la carga 1

    3 páginasMR04

    Cancelación total de la carga 2

    3 páginasMR04

    Cancelación total de la carga 6

    3 páginasMR04

    Cancelación total de la carga 5

    3 páginasMR04

    Nombramiento de Mr Robert Nicolaas Wilko Van Den Belt como director el 01 dic 2012

    2 páginasAP01

    Cese del nombramiento de Leif Erik Martensson como director el 01 dic 2012

    1 páginasTM01

    Cuentas preparadas hasta el 31 dic 2011

    5 páginasAA

    Déclaration annuelle établie au 31 may 2012 avec liste complète des actionnaires

    4 páginasAR01

    Cambio de datos del secretario Richard Mark Bloom el 09 feb 2012

    1 páginasCH03

    Domicilio social registrado cambiado de 310-312 Dallow Road Luton Bedfordshire LU1 1TD el 09 feb 2012

    1 páginasAD01

    ¿Quiénes son los directivos de EGERTON HOSPITAL EQUIPMENT LIMITED?

    Directivos
    NombreNombrado elRenunció elRolDirecciónIdentificación de la empresaPaís de residenciaNacionalidadFecha de nacimientoOcupaciónNúmero
    BLOOM, Richard Mark
    Houghton Hall Business Park
    Houghton Regis
    LU5 5XF Dunstable
    Arjohuntleigh House
    Bedfordshire
    United Kingdom
    Secretario
    Houghton Hall Business Park
    Houghton Regis
    LU5 5XF Dunstable
    Arjohuntleigh House
    Bedfordshire
    United Kingdom
    BritishSolicitor118671260002
    BLOOM, Richard Mark
    Houghton Hall Business Park
    Houghton Regis
    LU5 5XF Dunstable
    Arjohuntleigh House
    Bedfordshire
    United Kingdom
    Director
    Houghton Hall Business Park
    Houghton Regis
    LU5 5XF Dunstable
    Arjohuntleigh House
    Bedfordshire
    United Kingdom
    EnglandBritishLegal Counsel118671260002
    FRANZEN, Christoffer David Erik
    Houghton Hall Business Park
    Houghton Regis
    LU5 5XF Dunstable
    Arjohuntleigh House
    Bedfordshire
    United Kingdom
    Director
    Houghton Hall Business Park
    Houghton Regis
    LU5 5XF Dunstable
    Arjohuntleigh House
    Bedfordshire
    United Kingdom
    EnglandSwedishFinance Director188458510001
    VAN DEN BELT, Robert Nicolaas Wilko
    Houghton Hall Business Park
    Houghton Regis
    LU5 5XF Dunstable
    Arjohuntleigh House
    Bedfordshire
    United Kingdom
    Director
    Houghton Hall Business Park
    Houghton Regis
    LU5 5XF Dunstable
    Arjohuntleigh House
    Bedfordshire
    United Kingdom
    SwedenDutchCfo175232950001
    BANFIELD, Graeme Daryl
    40 Wheatstone Road
    PO4 0HY Southsea
    Hampshire
    Secretario
    40 Wheatstone Road
    PO4 0HY Southsea
    Hampshire
    British66225840001
    SCOTT GREEN, Andrew John
    Oysters Appledram Lane South
    Fishbourne
    PO20 7PE Chichester
    West Sussex
    Secretario
    Oysters Appledram Lane South
    Fishbourne
    PO20 7PE Chichester
    West Sussex
    BritishFinancial Controller75900570003
    WILKINSON, Peter Horace
    4 Hopgarden Road
    TN10 4QS Tonbridge
    Kent
    Secretario
    4 Hopgarden Road
    TN10 4QS Tonbridge
    Kent
    British11531330001
    BRACEY, Nicholas Aidan
    58 Wingfield Road
    BA14 9EW Trowbridge
    Wiltshire
    Director
    58 Wingfield Road
    BA14 9EW Trowbridge
    Wiltshire
    BritishManaging Director86041250002
    COUSINS, Peter John
    Paines Farm
    TN15 6XN Otford
    Kent
    Director
    Paines Farm
    TN15 6XN Otford
    Kent
    EnglandBritishAccountant9841900001
    FLUESTER, Terry Harold Charles
    86 Melody Road
    Biggin Hill
    TN16 3PJ Westerham
    Kent
    Director
    86 Melody Road
    Biggin Hill
    TN16 3PJ Westerham
    Kent
    BritishEngineer68120790001
    FRISTEDT, Stefan Ulf
    26263 Angelholm
    Pannagatan 1
    Sweden
    Director
    26263 Angelholm
    Pannagatan 1
    Sweden
    SwedenSwedishCfo241863330001
    HANNAGAN, Angus Patrick Douglas
    Green Glades
    Droxford Road
    PO17 5AY Wickham
    Hampshire
    Director
    Green Glades
    Droxford Road
    PO17 5AY Wickham
    Hampshire
    BritishDirector74342020001
    LOCK, Robert Francis
    Oak House Priors Frome
    Upper Dormington
    HR1 4EF Hereford
    Director
    Oak House Priors Frome
    Upper Dormington
    HR1 4EF Hereford
    United KingdomBritishFinance Director61939850001
    MARTENSSON, Leif Erik
    Linnegatan 116
    FOREIGN Malmo
    216 18
    Sweden
    Director
    Linnegatan 116
    FOREIGN Malmo
    216 18
    Sweden
    SwedenSwedishAccountant153479400001
    SCOTT GREEN, Andrew John
    Oysters Appledram Lane South
    Fishbourne
    PO20 7PE Chichester
    West Sussex
    Director
    Oysters Appledram Lane South
    Fishbourne
    PO20 7PE Chichester
    West Sussex
    United KingdomBritishFinancial Controller75900570003
    THOMPSON, Martin Stuart
    High Brimstone 176 Worlds End Lane
    Chelsfield Park
    BR6 7SS Orpington
    Kent
    Director
    High Brimstone 176 Worlds End Lane
    Chelsfield Park
    BR6 7SS Orpington
    Kent
    EnglandBritishEngineer11531350001
    WEBB, Martin Barry
    103 St Thomas Avenue
    West Town
    PO11 0EU Hayling Island
    Hampshire
    Director
    103 St Thomas Avenue
    West Town
    PO11 0EU Hayling Island
    Hampshire
    United KingdomBritishCompany Director1914800001
    WOZENCROFT, Andrew John
    Pleasant Stile
    Littledean
    GL14 3NX Cinderford
    Temple Cottage
    Gloucestershire
    Director
    Pleasant Stile
    Littledean
    GL14 3NX Cinderford
    Temple Cottage
    Gloucestershire
    BritishCompany Director16102100001

    ¿Tiene EGERTON HOSPITAL EQUIPMENT LIMITED alguna carga?

    Gravámenes
    ClasificaciónFechasEstadoDetalles
    Debenture
    Creado el 21 dic 1998
    Entregado el 24 dic 1998
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • Midland Bank PLC
    Transacciones
    • 24 dic 1998Registro de un cargo (395)
    • 01 may 2013Satisfacción de una carga (MR04)
    Charge
    Creado el 01 jul 1993
    Entregado el 08 jul 1993
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    Fixed equitable charge all book debts invoice debts accounts notes bills acceptances and/or other forms of obligation and all right title and interest in any goods. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • Griffin Factors Limited
    Transacciones
    • 08 jul 1993Registro de un cargo (395)
    • 19 abr 2013Satisfacción de una carga (MR04)
    Charge
    Creado el 20 nov 1992
    Entregado el 21 nov 1992
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever supplemental to the principal charge dated 19/11/74
    Breve descripción
    Fixed charge on all goodwill and uncalled capital for the time being of the company; and all patents patent applications inventions trade marks trade names etc.
    Personas con derecho
    • Midland Bank PLC
    Transacciones
    • 21 nov 1992Registro de un cargo (395)
    • 19 abr 2013Satisfacción de una carga (MR04)
    Aircraft mortgage
    Creado el 24 jun 1992
    Entregado el 25 jun 1992
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    £82,350 & all other monies due from the company to the chargee
    Breve descripción
    Tb 20 trinidad g-kkdl s/n 1096.
    Personas con derecho
    • Lombard North Central PLC
    Transacciones
    • 25 jun 1992Registro de un cargo (395)
    • 08 may 1998Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Credit agreement entitled "prompt credit application"
    Creado el 24 mar 1992
    Entregado el 09 abr 1992
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    £22,803.20 due from the company to the chargee under the terms of the agreement
    Breve descripción
    All its right title and interest in and to all sums payable under the insurance see doc for details.
    Personas con derecho
    • Close Brothers Limited
    Transacciones
    • 09 abr 1992Registro de un cargo (395)
    • 16 dic 1998Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Charge
    Creado el 10 ago 1982
    Entregado el 13 ago 1982
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    All book debts and other debts.
    Personas con derecho
    • Midland Bank PLC
    Transacciones
    • 13 ago 1982Registro de una carga
    • 19 abr 2013Satisfacción de una carga (MR04)
    Floating charge
    Creado el 19 nov 1974
    Entregado el 04 dic 1974
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    Floating charge. Undertaking and all property and assets present and future including uncalled capital.
    Personas con derecho
    • Midland Bank PLC
    Transacciones
    • 04 dic 1974Registro de una carga
    • 19 abr 2013Satisfacción de una carga (MR04)

    Fuente de datos

    • Companies House del Reino Unido
      El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros.
    • Licencia: CC0