GREENPARK (READING ) LIMITED

GREENPARK (READING ) LIMITED

  • Visión general
  • Resumen
  • Propósito
  • Dirección
  • Nombres anteriores
  • Cuentas
  • Declaración de confirmación
  • Presentaciones
  • Directivos
  • Personas con control significativo
  • Fuente de datos
  • Visión general

    Nombre de la empresaGREENPARK (READING ) LIMITED
    Estado de la empresaActiva
    Forma jurídicaSociedad de responsabilidad limitada
    Número de empresa 00871925
    JurisdicciónInglaterra/Gales
    Fecha de constitución

    Resumen

    Tiene PSCs súper segurosNo
    Tiene gravámenesNo
    Tiene historial de insolvenciaNo
    La sede social está en disputaNo

    ¿Cuál es el propósito de GREENPARK (READING ) LIMITED?

    • Actividades de oficinas centrales (70100) / Actividades profesionales, científicas y técnicas

    ¿Dónde se encuentra GREENPARK (READING ) LIMITED?

    Dirección de la sede social
    4th Floor 140 Aldersgate Street
    EC1A 4HY London
    England
    Dirección de la sede social no entregableNo

    ¿Cuáles fueron los nombres anteriores de GREENPARK (READING ) LIMITED?

    Nombres anteriores de la empresa
    Nombre de la empresaDesdeHasta
    READING BUSINESS PARK LIMITED21 sept 199021 sept 1990
    SETCREST LIMITED21 feb 196621 feb 1966

    ¿Cuáles son las últimas cuentas de GREENPARK (READING ) LIMITED?

    VencidoNo
    Próximas cuentas
    Próximo período contable finaliza el31 mar 2026
    Próximas cuentas vencen el31 dic 2026
    Últimas cuentas
    Últimas cuentas cerradas hasta31 mar 2025

    ¿Cuál es el estado de la última declaración de confirmación para GREENPARK (READING ) LIMITED?

    Última declaración de confirmación cerrada hasta28 may 2026
    Próxima declaración de confirmación vence11 jun 2026
    Última declaración de confirmación
    Próxima declaración de confirmación cerrada hasta28 may 2025
    VencidoNo

    ¿Cuáles son las últimas presentaciones para GREENPARK (READING ) LIMITED?

    Presentaciones
    FechaDescripciónDocumentoTipo

    Cuentas completas preparadas hasta el 31 mar 2025

    18 páginasAA

    Cambio de datos del director Mr Rory John Carson el 24 mar 2022

    2 páginasCH01

    Declaración de confirmación presentada el 28 may 2025 sin actualizaciones

    3 páginasCS01

    Cuentas completas preparadas hasta el 31 mar 2024

    18 páginasAA

    Cambio de datos del secretario Apex Group Secretaries (Uk) Limited el 18 nov 2024

    1 páginasCH04

    Domicilio social registrado cambiado de 6th Floor 125 London Wall London EC2Y 5AS England a 4th Floor 140 Aldersgate Street London EC1A 4HY el 26 nov 2024

    1 páginasAD01

    Nombramiento de Ms Sim Sin Ying como director el 27 sept 2024

    2 páginasAP01

    Cese del nombramiento de Christine Kang Hwee como director el 27 sept 2024

    1 páginasTM01

    Declaración de confirmación presentada el 28 may 2024 sin actualizaciones

    3 páginasCS01

    Cuentas completas preparadas hasta el 31 mar 2023

    18 páginasAA

    Cambio de datos del secretario Sanne Group Secretaries (Uk) Limited el 16 ene 2023

    1 páginasCH04

    Declaración de confirmación presentada el 28 may 2023 sin actualizaciones

    3 páginasCS01

    Cuentas completas preparadas hasta el 31 mar 2022

    18 páginasAA

    Declaración de confirmación presentada el 28 may 2022 sin actualizaciones

    3 páginasCS01

    Cuentas completas preparadas hasta el 31 mar 2021

    18 páginasAA

    Declaración de confirmación presentada el 28 may 2021 sin actualizaciones

    3 páginasCS01

    Cuentas completas preparadas hasta el 31 mar 2020

    17 páginasAA

    Nombramiento de Ms Christine Kang Hwee como director el 30 nov 2020

    2 páginasAP01

    Cese del nombramiento de Koh Lay Keng como director el 30 nov 2020

    1 páginasTM01

    Cambio de datos del secretario Sanne Group Secretaries (Uk) Limited el 10 ago 2020

    1 páginasCH04

    Domicilio social registrado cambiado de The Asticus Building, 21 Palmer Street London SW1H 0AD England a 6th Floor 125 London Wall London EC2Y 5AS el 17 ago 2020

    1 páginasAD01

    Declaración de confirmación presentada el 28 may 2020 sin actualizaciones

    3 páginasCS01

    Cuentas completas preparadas hasta el 31 mar 2019

    18 páginasAA

    Declaración de confirmación presentada el 28 may 2019 sin actualizaciones

    3 páginasCS01

    Cuentas completas preparadas hasta el 31 mar 2018

    16 páginasAA

    ¿Quiénes son los directivos de GREENPARK (READING ) LIMITED?

    Directivos
    NombreNombrado elRenunció elRolDirecciónIdentificación de la empresaPaís de residenciaNacionalidadFecha de nacimientoOcupaciónNúmero
    APEX GROUP SECRETARIES (UK) LIMITED
    140 Aldersgate Street
    EC1A 4HY London
    4th Floor
    England
    Secretario corporativo
    140 Aldersgate Street
    EC1A 4HY London
    4th Floor
    England
    Tipo de identificaciónSociedad limitada del Reino Unido
    Número de registro8334728
    175738460002
    CARSON, Rory John
    140 Aldersgate Street
    EC1A 4HY London
    4th Floor
    England
    Director
    140 Aldersgate Street
    EC1A 4HY London
    4th Floor
    England
    EnglandBritish131949830006
    YING, Sim Sin
    140 Aldersgate Street
    EC1A 4HY London
    4th Floor
    England
    Director
    140 Aldersgate Street
    EC1A 4HY London
    4th Floor
    England
    SingaporeSingaporean328227320001
    LOWE, Hilary Anne
    40 Mill Lane
    Cheshunt
    EN8 0JH Hertfordshire
    Secretario
    40 Mill Lane
    Cheshunt
    EN8 0JH Hertfordshire
    British95034760001
    MACDONALD, Kerryn Lynn
    19 Levendale Road
    SE23 2TP London
    Secretario
    19 Levendale Road
    SE23 2TP London
    British97523250001
    MOLLOY, Fiona Jane
    64 Old Fold View
    EN5 4EB Barnet
    Hertfordshire
    Secretario
    64 Old Fold View
    EN5 4EB Barnet
    Hertfordshire
    British75464460002
    PILKINGTON, Richard
    45 Seymour Street
    W1H 7LX London
    York House
    United Kingdom
    Secretario
    45 Seymour Street
    W1H 7LX London
    York House
    United Kingdom
    165102770001
    RUTHERFORD, Adam Paul
    12 Pilgrims Close
    LU5 6LX Harlington
    Bedfordshire
    Secretario
    12 Pilgrims Close
    LU5 6LX Harlington
    Bedfordshire
    British70451850001
    WELLARD, Tracey Lee
    21 Davenport Road
    Albany Park
    DA14 4PN Sidcup
    Kent
    Secretario
    21 Davenport Road
    Albany Park
    DA14 4PN Sidcup
    Kent
    British11445390001
    WINDRIDGE, Susan Doreen
    The Ferns
    157 Southwood Lane
    N6 5TA London
    Secretario
    The Ferns
    157 Southwood Lane
    N6 5TA London
    British6617760002
    M&G MANAGEMENT SERVICES LIMITED
    Laurence Pountney Hill
    EC4R 0HH London
    Secretario corporativo
    Laurence Pountney Hill
    EC4R 0HH London
    150456660001
    STATE STREET SECRETARIES (UK) LIMITED
    Churchill Place
    E14 5HJ Canary Wharf
    20
    London
    United Kingdom
    Secretario corporativo
    Churchill Place
    E14 5HJ Canary Wharf
    20
    London
    United Kingdom
    Tipo de identificaciónEEE
    Número de registro3691921
    108845150006
    BENNETT, Charles Anthony Howson
    Laurence Pountney Hill
    EC4R 0HH London
    Laurence Pountney Hill
    England
    Director
    Laurence Pountney Hill
    EC4R 0HH London
    Laurence Pountney Hill
    England
    EnglandBritish81459180003
    BIRCH, Adam Daniel
    Laurence Pountney Hill
    EC4R 0HH London
    Laurence Pountney Hill
    England
    Director
    Laurence Pountney Hill
    EC4R 0HH London
    Laurence Pountney Hill
    England
    United KingdomBritish125809000001
    BRUNDAGE, Paul Arthur
    Churchill Place
    Canary Wharf
    E14 5HJ London
    20
    United Kingdom
    Director
    Churchill Place
    Canary Wharf
    E14 5HJ London
    20
    United Kingdom
    United KingdomCanadian138945210001
    CARTER KEALL, Christopher Philip
    New Street Square
    12th Floor, New Fetter Lane
    EC4A 3BF London
    6
    England
    Director
    New Street Square
    12th Floor, New Fetter Lane
    EC4A 3BF London
    6
    England
    EnglandBritish153912870001
    CHEONG HIN, Tan
    Palmer Street
    SW1H 0AD London
    The Asticus Building, 21
    England
    Director
    Palmer Street
    SW1H 0AD London
    The Asticus Building, 21
    England
    SingaporeSingaporean208439750001
    CUNLIFFE, Matthew Christopher Myles
    109 Clapham Common Northside
    SW4 9SH London
    Director
    109 Clapham Common Northside
    SW4 9SH London
    United KingdomBritish104765910001
    DAVIS, Timothy John Alexander
    Red Cow House
    Stoke Row
    RG9 5NY Henley On Thames
    Oxfordshire
    Director
    Red Cow House
    Stoke Row
    RG9 5NY Henley On Thames
    Oxfordshire
    United KingdomBritish106069400004
    DUXBURY, Sian Elizabeth
    4 Oakhurst Grove
    East Dulwich
    SE22 9AQ London
    Director
    4 Oakhurst Grove
    East Dulwich
    SE22 9AQ London
    British81224640001
    FOO, Pei Teng
    Palmer Street
    SW1H 0AD London
    The Asticus Building, 21
    England
    Director
    Palmer Street
    SW1H 0AD London
    The Asticus Building, 21
    England
    SingaporeSingaporean210698050001
    GORDON, Ian Robert
    7 Dene Tye
    Pound Hill
    RH10 7TS Crawley
    West Sussex
    Director
    7 Dene Tye
    Pound Hill
    RH10 7TS Crawley
    West Sussex
    British11134370001
    KANG HWEE, Christine
    125 London Wall
    EC2Y 5AS London
    6th Floor
    England
    Director
    125 London Wall
    EC2Y 5AS London
    6th Floor
    England
    SingaporeSingaporean279413000001
    KENG, Koh Lay
    125 London Wall
    EC2Y 5AS London
    6th Floor
    England
    Director
    125 London Wall
    EC2Y 5AS London
    6th Floor
    England
    SingaporeSingaporean235935180001
    LAMBERT, Alison Jane
    New Street Square
    New Fetter Lane
    EC4A 3BF London
    6
    England
    Director
    New Street Square
    New Fetter Lane
    EC4A 3BF London
    6
    England
    United KingdomBritish167798150001
    LOWE, Philip John
    Laurence Pountney Hill
    EC4R 0HH London
    Laurence Pountney Hill
    England
    Director
    Laurence Pountney Hill
    EC4R 0HH London
    Laurence Pountney Hill
    England
    United KingdomBritish137475230002
    MARRIOTT, Simon Crosbie
    Floor Phoenix House
    18 King William Street
    EC4N 7BP London
    1st
    United Kingdom
    Director
    Floor Phoenix House
    18 King William Street
    EC4N 7BP London
    1st
    United Kingdom
    EnglandBritish116100370001
    PARKER, Gary Frank
    2 Woodfield Avenue
    Ealing
    W5 1PA London
    Director
    2 Woodfield Avenue
    Ealing
    W5 1PA London
    British60727990001
    PHILLIPS, Ian Sinclair
    38 Aldbourne Avenue
    Earley
    RG6 2DB Reading
    Berkshire
    Director
    38 Aldbourne Avenue
    Earley
    RG6 2DB Reading
    Berkshire
    British48679850001
    PILKINGTON, Richard Michael
    c/o Sanne
    10 Cork Street
    W1S 3NP London
    Pollen House
    England
    Director
    c/o Sanne
    10 Cork Street
    W1S 3NP London
    Pollen House
    England
    United KingdomBritish163766760001
    PROCTOR, John Simon
    113 Copers Cope Road
    BR3 1NY Beckenham
    Kent
    Director
    113 Copers Cope Road
    BR3 1NY Beckenham
    Kent
    United KingdomBritish48680000001
    RADLEY, Robert
    126 Fairview Road
    SG1 2NS Stevenage
    Hertfordshire
    Director
    126 Fairview Road
    SG1 2NS Stevenage
    Hertfordshire
    British48679930001
    ROLLS, Michael Garnet
    4 Cooper House
    Ravens Lane
    HP4 2DX Berkhamsted
    Hertfordshire
    Director
    4 Cooper House
    Ravens Lane
    HP4 2DX Berkhamsted
    Hertfordshire
    United KingdomBritish118426900001
    SCALLY, Steven Antony
    c/o Sanne
    10 Cork Street
    W1S 3NP London
    Pollen House
    England
    Director
    c/o Sanne
    10 Cork Street
    W1S 3NP London
    Pollen House
    England
    United KingdomBritish129486460001
    TAY BEE HONG, Shirley
    Palmer Street
    SW1H 0AD London
    The Asticus Building, 21
    England
    Director
    Palmer Street
    SW1H 0AD London
    The Asticus Building, 21
    England
    SingaporeSingaporean208438220001

    ¿Quiénes son las personas con control significativo de GREENPARK (READING ) LIMITED?

    Personas con control significativo
    NombreNotificado elDirecciónCesado
    Palmer Street
    SW1H 0AD London
    Asticus Building, 21
    England
    06 abr 2016
    Palmer Street
    SW1H 0AD London
    Asticus Building, 21
    England
    No
    Forma jurídicaLimited Liability Partnership
    País de registroEngland
    Autoridad legalLimited Liability Partnership Act 2000
    Lugar de registroCompanies House
    Número de registroOc369634
    Naturaleza del control
    • La persona posee, directa o indirectamente, más del 75% de las acciones de la compañía.
    • La persona tiene el derecho de ejercer, o ejerce realmente, una influencia o control significativo sobre las actividades de un fideicomiso, y los fiduciarios de ese fideicomiso (en su calidad como tales) poseen, directa o indirectamente, más del 75% de los derechos de voto en la empresa.
    • La persona tiene el derecho, directa o indirectamente, de nombrar o destituir a la mayoría de la junta directiva de la empresa.

    Fuente de datos

    • Companies House del Reino Unido
      El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros.
    • Licencia: CC0