GREENPARK (READING ) LIMITED
Visión general
| Nombre de la empresa | GREENPARK (READING ) LIMITED |
|---|---|
| Estado de la empresa | Activa |
| Forma jurídica | Sociedad de responsabilidad limitada |
| Número de empresa | 00871925 |
| Jurisdicción | Inglaterra/Gales |
| Fecha de constitución |
Resumen
| Tiene PSCs súper seguros | No |
|---|---|
| Tiene gravámenes | No |
| Tiene historial de insolvencia | No |
| La sede social está en disputa | No |
¿Cuál es el propósito de GREENPARK (READING ) LIMITED?
- Actividades de oficinas centrales (70100) / Actividades profesionales, científicas y técnicas
¿Dónde se encuentra GREENPARK (READING ) LIMITED?
| Dirección de la sede social | 4th Floor 140 Aldersgate Street EC1A 4HY London England |
|---|---|
| Dirección de la sede social no entregable | No |
¿Cuáles fueron los nombres anteriores de GREENPARK (READING ) LIMITED?
| Nombre de la empresa | Desde | Hasta |
|---|---|---|
| READING BUSINESS PARK LIMITED | 21 sept 1990 | 21 sept 1990 |
| SETCREST LIMITED | 21 feb 1966 | 21 feb 1966 |
¿Cuáles son las últimas cuentas de GREENPARK (READING ) LIMITED?
| Vencido | No |
|---|---|
| Próximas cuentas | |
| Próximo período contable finaliza el | 31 mar 2026 |
| Próximas cuentas vencen el | 31 dic 2026 |
| Últimas cuentas | |
| Últimas cuentas cerradas hasta | 31 mar 2025 |
¿Cuál es el estado de la última declaración de confirmación para GREENPARK (READING ) LIMITED?
| Última declaración de confirmación cerrada hasta | 28 may 2026 |
|---|---|
| Próxima declaración de confirmación vence | 11 jun 2026 |
| Última declaración de confirmación | |
| Próxima declaración de confirmación cerrada hasta | 28 may 2025 |
| Vencido | No |
¿Cuáles son las últimas presentaciones para GREENPARK (READING ) LIMITED?
| Fecha | Descripción | Documento | Tipo | |
|---|---|---|---|---|
Cuentas completas preparadas hasta el 31 mar 2025 | 18 páginas | AA | ||
Cambio de datos del director Mr Rory John Carson el 24 mar 2022 | 2 páginas | CH01 | ||
Declaración de confirmación presentada el 28 may 2025 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||
Cuentas completas preparadas hasta el 31 mar 2024 | 18 páginas | AA | ||
Cambio de datos del secretario Apex Group Secretaries (Uk) Limited el 18 nov 2024 | 1 páginas | CH04 | ||
Domicilio social registrado cambiado de 6th Floor 125 London Wall London EC2Y 5AS England a 4th Floor 140 Aldersgate Street London EC1A 4HY el 26 nov 2024 | 1 páginas | AD01 | ||
Nombramiento de Ms Sim Sin Ying como director el 27 sept 2024 | 2 páginas | AP01 | ||
Cese del nombramiento de Christine Kang Hwee como director el 27 sept 2024 | 1 páginas | TM01 | ||
Declaración de confirmación presentada el 28 may 2024 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||
Cuentas completas preparadas hasta el 31 mar 2023 | 18 páginas | AA | ||
Cambio de datos del secretario Sanne Group Secretaries (Uk) Limited el 16 ene 2023 | 1 páginas | CH04 | ||
Declaración de confirmación presentada el 28 may 2023 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||
Cuentas completas preparadas hasta el 31 mar 2022 | 18 páginas | AA | ||
Declaración de confirmación presentada el 28 may 2022 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||
Cuentas completas preparadas hasta el 31 mar 2021 | 18 páginas | AA | ||
Declaración de confirmación presentada el 28 may 2021 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||
Cuentas completas preparadas hasta el 31 mar 2020 | 17 páginas | AA | ||
Nombramiento de Ms Christine Kang Hwee como director el 30 nov 2020 | 2 páginas | AP01 | ||
Cese del nombramiento de Koh Lay Keng como director el 30 nov 2020 | 1 páginas | TM01 | ||
Cambio de datos del secretario Sanne Group Secretaries (Uk) Limited el 10 ago 2020 | 1 páginas | CH04 | ||
Domicilio social registrado cambiado de The Asticus Building, 21 Palmer Street London SW1H 0AD England a 6th Floor 125 London Wall London EC2Y 5AS el 17 ago 2020 | 1 páginas | AD01 | ||
Declaración de confirmación presentada el 28 may 2020 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||
Cuentas completas preparadas hasta el 31 mar 2019 | 18 páginas | AA | ||
Declaración de confirmación presentada el 28 may 2019 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||
Cuentas completas preparadas hasta el 31 mar 2018 | 16 páginas | AA | ||
¿Quiénes son los directivos de GREENPARK (READING ) LIMITED?
| Nombre | Nombrado el | Renunció el | Rol | Dirección | Identificación de la empresa | País de residencia | Nacionalidad | Fecha de nacimiento | Ocupación | Número | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| APEX GROUP SECRETARIES (UK) LIMITED | Secretario corporativo | 140 Aldersgate Street EC1A 4HY London 4th Floor England |
| 175738460002 | ||||||||||
| CARSON, Rory John | Director | 140 Aldersgate Street EC1A 4HY London 4th Floor England | England | British | 131949830006 | |||||||||
| YING, Sim Sin | Director | 140 Aldersgate Street EC1A 4HY London 4th Floor England | Singapore | Singaporean | 328227320001 | |||||||||
| LOWE, Hilary Anne | Secretario | 40 Mill Lane Cheshunt EN8 0JH Hertfordshire | British | 95034760001 | ||||||||||
| MACDONALD, Kerryn Lynn | Secretario | 19 Levendale Road SE23 2TP London | British | 97523250001 | ||||||||||
| MOLLOY, Fiona Jane | Secretario | 64 Old Fold View EN5 4EB Barnet Hertfordshire | British | 75464460002 | ||||||||||
| PILKINGTON, Richard | Secretario | 45 Seymour Street W1H 7LX London York House United Kingdom | 165102770001 | |||||||||||
| RUTHERFORD, Adam Paul | Secretario | 12 Pilgrims Close LU5 6LX Harlington Bedfordshire | British | 70451850001 | ||||||||||
| WELLARD, Tracey Lee | Secretario | 21 Davenport Road Albany Park DA14 4PN Sidcup Kent | British | 11445390001 | ||||||||||
| WINDRIDGE, Susan Doreen | Secretario | The Ferns 157 Southwood Lane N6 5TA London | British | 6617760002 | ||||||||||
| M&G MANAGEMENT SERVICES LIMITED | Secretario corporativo | Laurence Pountney Hill EC4R 0HH London | 150456660001 | |||||||||||
| STATE STREET SECRETARIES (UK) LIMITED | Secretario corporativo | Churchill Place E14 5HJ Canary Wharf 20 London United Kingdom |
| 108845150006 | ||||||||||
| BENNETT, Charles Anthony Howson | Director | Laurence Pountney Hill EC4R 0HH London Laurence Pountney Hill England | England | British | 81459180003 | |||||||||
| BIRCH, Adam Daniel | Director | Laurence Pountney Hill EC4R 0HH London Laurence Pountney Hill England | United Kingdom | British | 125809000001 | |||||||||
| BRUNDAGE, Paul Arthur | Director | Churchill Place Canary Wharf E14 5HJ London 20 United Kingdom | United Kingdom | Canadian | 138945210001 | |||||||||
| CARTER KEALL, Christopher Philip | Director | New Street Square 12th Floor, New Fetter Lane EC4A 3BF London 6 England | England | British | 153912870001 | |||||||||
| CHEONG HIN, Tan | Director | Palmer Street SW1H 0AD London The Asticus Building, 21 England | Singapore | Singaporean | 208439750001 | |||||||||
| CUNLIFFE, Matthew Christopher Myles | Director | 109 Clapham Common Northside SW4 9SH London | United Kingdom | British | 104765910001 | |||||||||
| DAVIS, Timothy John Alexander | Director | Red Cow House Stoke Row RG9 5NY Henley On Thames Oxfordshire | United Kingdom | British | 106069400004 | |||||||||
| DUXBURY, Sian Elizabeth | Director | 4 Oakhurst Grove East Dulwich SE22 9AQ London | British | 81224640001 | ||||||||||
| FOO, Pei Teng | Director | Palmer Street SW1H 0AD London The Asticus Building, 21 England | Singapore | Singaporean | 210698050001 | |||||||||
| GORDON, Ian Robert | Director | 7 Dene Tye Pound Hill RH10 7TS Crawley West Sussex | British | 11134370001 | ||||||||||
| KANG HWEE, Christine | Director | 125 London Wall EC2Y 5AS London 6th Floor England | Singapore | Singaporean | 279413000001 | |||||||||
| KENG, Koh Lay | Director | 125 London Wall EC2Y 5AS London 6th Floor England | Singapore | Singaporean | 235935180001 | |||||||||
| LAMBERT, Alison Jane | Director | New Street Square New Fetter Lane EC4A 3BF London 6 England | United Kingdom | British | 167798150001 | |||||||||
| LOWE, Philip John | Director | Laurence Pountney Hill EC4R 0HH London Laurence Pountney Hill England | United Kingdom | British | 137475230002 | |||||||||
| MARRIOTT, Simon Crosbie | Director | Floor Phoenix House 18 King William Street EC4N 7BP London 1st United Kingdom | England | British | 116100370001 | |||||||||
| PARKER, Gary Frank | Director | 2 Woodfield Avenue Ealing W5 1PA London | British | 60727990001 | ||||||||||
| PHILLIPS, Ian Sinclair | Director | 38 Aldbourne Avenue Earley RG6 2DB Reading Berkshire | British | 48679850001 | ||||||||||
| PILKINGTON, Richard Michael | Director | c/o Sanne 10 Cork Street W1S 3NP London Pollen House England | United Kingdom | British | 163766760001 | |||||||||
| PROCTOR, John Simon | Director | 113 Copers Cope Road BR3 1NY Beckenham Kent | United Kingdom | British | 48680000001 | |||||||||
| RADLEY, Robert | Director | 126 Fairview Road SG1 2NS Stevenage Hertfordshire | British | 48679930001 | ||||||||||
| ROLLS, Michael Garnet | Director | 4 Cooper House Ravens Lane HP4 2DX Berkhamsted Hertfordshire | United Kingdom | British | 118426900001 | |||||||||
| SCALLY, Steven Antony | Director | c/o Sanne 10 Cork Street W1S 3NP London Pollen House England | United Kingdom | British | 129486460001 | |||||||||
| TAY BEE HONG, Shirley | Director | Palmer Street SW1H 0AD London The Asticus Building, 21 England | Singapore | Singaporean | 208438220001 |
¿Quiénes son las personas con control significativo de GREENPARK (READING ) LIMITED?
| Nombre | Notificado el | Dirección | Cesado | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Green Park Reading No.1 Llp | 06 abr 2016 | Palmer Street SW1H 0AD London Asticus Building, 21 England | No | ||||||||||
| |||||||||||||
Naturaleza del control
| |||||||||||||
Fuente de datos
- Companies House del Reino Unido
El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros. - Licencia: CC0