H.P.L.C. TECHNOLOGY COMPANY LIMITED
Visión general
Nombre de la empresa | H.P.L.C. TECHNOLOGY COMPANY LIMITED |
---|---|
Estado de la empresa | Disuelta |
Forma jurídica | Sociedad de responsabilidad limitada |
Número de empresa | 00880655 |
Jurisdicción | Inglaterra/Gales |
Fecha de constitución | |
Fecha de cese |
Resumen
Tiene PSCs súper seguros | No |
---|---|
Tiene gravámenes | Sí |
Tiene historial de insolvencia | No |
La sede social está en disputa | No |
¿Cuál es el propósito de H.P.L.C. TECHNOLOGY COMPANY LIMITED?
- Compañía no comercial (74990) / Actividades profesionales, científicas y técnicas
¿Dónde se encuentra H.P.L.C. TECHNOLOGY COMPANY LIMITED?
Dirección de la sede social | 3rd Floor, 1 Ashley Road WA14 2DT Altrincham Cheshire |
---|---|
Dirección de la sede social no entregable | No |
¿Cuáles fueron los nombres anteriores de H.P.L.C. TECHNOLOGY COMPANY LIMITED?
Nombre de la empresa | Desde | Hasta |
---|---|---|
PEEK MEASUREMENT LIMITED | 03 jun 1992 | 03 jun 1992 |
SARASOTA AUTOMATION LIMITED | 02 ago 1982 | 02 ago 1982 |
¿Cuáles son las últimas cuentas de H.P.L.C. TECHNOLOGY COMPANY LIMITED?
Últimas cuentas | |
---|---|
Últimas cuentas cerradas hasta | 31 dic 2012 |
¿Cuál es el estado de la última declaración anual para H.P.L.C. TECHNOLOGY COMPANY LIMITED?
Declaración anual |
|
---|
¿Cuáles son las últimas presentaciones para H.P.L.C. TECHNOLOGY COMPANY LIMITED?
Fecha | Descripción | Documento | Tipo | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Boletín oficial final disuelto por cancelación voluntaria | 1 páginas | GAZ2(A) | ||||||||||
Cese del nombramiento de Nicola Jane Ward como secretario el 18 dic 2014 | 1 páginas | TM02 | ||||||||||
Primer aviso en el boletín oficial para la cancelación voluntaria | 1 páginas | GAZ1(A) | ||||||||||
Solicitud de exclusión de la empresa del registro | 3 páginas | DS01 | ||||||||||
Déclaration annuelle établie au 13 ago 2014 avec liste complète des actionnaires | 4 páginas | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Estado de capital el 09 jun 2014
| 4 páginas | SH19 | ||||||||||
legacy | 1 páginas | SH20 | ||||||||||
legacy | 1 p áginas | CAP-SS | ||||||||||
Resoluciones Resolutions | 1 páginas | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Cese del nombramiento de Lucie Mary Katja Grant como director el 10 mar 2014 | 1 páginas | TM01 | ||||||||||
Cese del nombramiento de Katie Rose Wright como director el 10 mar 2014 | 1 páginas | TM01 | ||||||||||
Los registros se han trasladado a la dirección del domicilio social registrado | 1 páginas | AD04 | ||||||||||
Domicilio social registrado cambiado de , Solaar House, 19 Mercers Row, Cambridge, CB5 8BZ el 07 mar 2014 | 1 páginas | AD01 | ||||||||||
Cambio de datos del secretario Nicola Jane Ward el 01 oct 2009 | 1 páginas | CH03 | ||||||||||
Cambio de datos del director Katie Rose Wright el 03 mar 2014 | 2 páginas | CH01 | ||||||||||
Cambio de datos del director Kevin Neil Wheeler el 03 mar 2014 | 2 páginas | CH01 | ||||||||||
Cambio de datos del director Lucie Mary Katja Grant el 03 mar 2014 | 2 páginas | CH01 | ||||||||||
Cuentas preparadas hasta el 31 dic 2012 | 1 páginas | AA | ||||||||||
Déclaration annuelle établie au 13 ago 2013 avec liste complète des actionnaires | 6 páginas | AR01 | ||||||||||
La dirección de inspección del registro se ha cambiado de Webber House 26-28 Market Street Altrincham Cheshire WA14 1PF | 1 páginas | AD02 | ||||||||||
Cambio de datos del secretario Oakwood Corporate Secretary Limited el 13 ago 2013 | 2 páginas | CH04 | ||||||||||
Cambio de datos del director Lucie Mary Katja Grant el 10 jul 2013 | 2 páginas | CH01 | ||||||||||
Nombramiento de Lucie Mary Katja Grant como director el 07 feb 2013 | 2 páginas | AP01 | ||||||||||
Cese del nombramiento de Iain Alasdair Keith Moodie como director el 07 feb 2013 | 1 páginas | TM01 | ||||||||||
Déclaration annuelle établie au 13 ago 2012 avec liste complète des actionnaires | 5 páginas | AR01 | ||||||||||
¿Quiénes son los directivos de H.P.L.C. TECHNOLOGY COMPANY LIMITED?
Nombre | Nombrado el | Renunció el | Rol | Dirección | Identificación de la empresa | País de residencia | Nacionalidad | Fecha de nacimiento | Ocupación | Número | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OAKWOOD CORPORATE SECRETARY LIMITED | Secretario corporativo | Floor 1 Ashley Road WA14 2DT Altrincham 3rd Cheshire |
| 146358090001 | ||||||||||
WHEELER, Kevin Neil | Director | WA14 2DT Altrincham 3rd Floor, 1 Ashley Road Cheshire England | United Kingdom | British | Tax Manager | 80845970007 | ||||||||
CHALLEN, Robert John | Secretario | 16 Hill Meadow Overton RG25 3JD Basingstoke Hampshire | British | 46308620001 | ||||||||||
GRAHAM, Alan William | Secretario | 32 Coles Mede Otterbourne SO21 2EG Winchester Hampshire | British | 57287700001 | ||||||||||
JENKINS, Mark Andrew | Secretario | Elba House Goosey SN7 8PA Farringdon Oxfordshire | British | 96552770001 | ||||||||||
KERRY, Tony Sidney | Secretario | 76 Holtspur Top Lane HP9 1DT Beaconsfield Buckinghamshire | British | 813240001 | ||||||||||
NEWTON, Roger James | Secretario | Holmelea Sonning Lane Sonning RG4 6ST Reading Berkshire | British | 82462930001 | ||||||||||
TABBERER, Gary Michael | Secretario | 7 Witton Hill SO24 9PT Alresford Hampshire | British | 59565250001 | ||||||||||
WARD, Nicola Jane | Secretario | 19 Mercers Row CB5 8BZ Cambridge Solaar House England | British | 68596390003 | ||||||||||
A G SECRETARIAL LIMITED | Secretario corporativo | 100 Barbirolli Square M2 3AB Manchester | 90084920001 | |||||||||||
BETTS, Christopher Thomas | Director | Tanglewood The Ride Ifold RH14 0TF Bilinghurst West Sussex | British | Manager | 87626190001 | |||||||||
COLEY, James Robert Ewen | Director | 19 Mercers Row CB5 8BZ Cambridge Solaar House United Kingdom | United Kingdom | British | Solicitor | 68949300008 | ||||||||
DUARTE, Cornelius Richard | Director | 3730 Stocksbridge Sugar Land 77479 Texas Usa | American | President & Ceo | 34913620001 | |||||||||
GRANT, Lucie Mary Katja | Director | WA14 2DT Altrincham 3rd Floor, 1 Ashley Road Cheshire England | United Kingdom | British | Solicitor | 175111280003 | ||||||||
INGRAM, Gerald Vaughan | Director | 74 Lanbourne Drive Locks Heath SO3 Southampton Hants | British | Company Director | 29674830001 | |||||||||
MCARDLE, Eamonn | Director | Brookfields Little London Road RG7 2PP Silchester Berkshire | United Kingdom | British | Director | 112644970001 | ||||||||
MOODIE, Iain Alasdair Keith | Director | 19 Mercers Row CB5 8BZ Cambridge Solaar House United Kingdom | England | British | Solicitor | 226426120003 | ||||||||
NEAME, Michael John Henry, Dr | Director | 13b Central Street Ludgershall SP11 9RA Andover Hampshire | British | General Manager | 34126010003 | |||||||||
PERKINS, James Ian | Director | 21 Almond Way LE17 4XJ Lutterworth Leicestershire | British | General Manager | 38242790001 | |||||||||
PORTER, Simon | Director | 48 Blenheim Road Caversham RG4 7RS Reading Berkshire | British | Finance Director | 55262300001 | |||||||||
SANGER, James Gerald | Director | Moreton House High Road Brightwell Cum Sotwell OX10 0PT Wallingford Oxfordshire | England | United Kingdom | Finance Director | 13748460001 | ||||||||
SMITH, Kenneth E | Director | 4118 Clayhead Road 77469 Richmond Texas Usa | American | Company Director | 45434480001 | |||||||||
STANDLEY, Allen Frederick | Director | 5 Lambridge Wood Road RG9 3BP Henley On Thames Northlands Oxfordshire | British | Chief Executive | 34174780003 | |||||||||
WHEELER, Kevin Neil | Director | 4 Vicarage Farm Yard Abbotsley PE19 6US St Neots Cambridgeshire | British | Tax Manager | 80845970001 | |||||||||
WRIGHT, Katie Rose | Director | WA14 2DT Altrincham 3rd Floor, 1 Ashley Road Cheshire England | United Kingdom | British | Accountant | 156438380002 |
¿Tiene H.P.L.C. TECHNOLOGY COMPANY LIMITED alguna carga?
Clasificación | Fechas | Estado | Detalles | |
---|---|---|---|---|
Trust deed | Creado el 01 abr 1982 Entregado el 16 abr 1982 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada Debenture stock of bidgold limited amounting to £1,200,000 variable rate debenture stock 1987/91 | |
Breve descripción Fixed & floating charges undertaking andll property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital all buildings fixtures (inc. Trade fixtures) fixed plant & machinery. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
Guarantee & debenture | Creado el 01 abr 1982 Entregado el 13 abr 1982 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All monies due or to become due from the company and/or bidgold limited to the chargee on any account whatsoever. | |
Breve descripción Fixed & floating charges undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital. With all buildings fixtures (incl. Trade fixtures) fixed plant & machinery. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
Guarantee & debenture | Creado el 01 abr 1982 Entregado el 13 abr 1982 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All monies due or to become due from the company and/or bidgold limited to the chargee on any account whatsoever. | |
Breve descripción Fixed & floating charges undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts & uncalled capital. With all buildings fixtures (and trade fixtures) fixed plant & machinery. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
Supplemental trust deed | Creado el 29 ene 1981 Entregado el 16 feb 1981 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada £4,536,211 (see doc ,45) | |
Breve descripción Floating charge over. Undertaking and all property and assets present and future including uncalled capital. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
|
Fuente de datos
- Companies House del Reino Unido
El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros. - Licencia: CC0