H.P.L.C. TECHNOLOGY COMPANY LIMITED

H.P.L.C. TECHNOLOGY COMPANY LIMITED

  • Visión general
  • Resumen
  • Propósito
  • Dirección
  • Nombres anteriores
  • Cuentas
  • Declaración anual
  • Presentaciones
  • Directivos
  • Gravámenes
  • Fuente de datos
  • Visión general

    Nombre de la empresaH.P.L.C. TECHNOLOGY COMPANY LIMITED
    Estado de la empresaDisuelta
    Forma jurídicaSociedad de responsabilidad limitada
    Número de empresa 00880655
    JurisdicciónInglaterra/Gales
    Fecha de constitución
    Fecha de cese

    Resumen

    Tiene PSCs súper segurosNo
    Tiene gravámenes
    Tiene historial de insolvenciaNo
    La sede social está en disputaNo

    ¿Cuál es el propósito de H.P.L.C. TECHNOLOGY COMPANY LIMITED?

    • Compañía no comercial (74990) / Actividades profesionales, científicas y técnicas

    ¿Dónde se encuentra H.P.L.C. TECHNOLOGY COMPANY LIMITED?

    Dirección de la sede social
    3rd Floor, 1 Ashley Road
    WA14 2DT Altrincham
    Cheshire
    Dirección de la sede social no entregableNo

    ¿Cuáles fueron los nombres anteriores de H.P.L.C. TECHNOLOGY COMPANY LIMITED?

    Nombres anteriores de la empresa
    Nombre de la empresaDesdeHasta
    PEEK MEASUREMENT LIMITED03 jun 199203 jun 1992
    SARASOTA AUTOMATION LIMITED02 ago 198202 ago 1982

    ¿Cuáles son las últimas cuentas de H.P.L.C. TECHNOLOGY COMPANY LIMITED?

    Últimas cuentas
    Últimas cuentas cerradas hasta31 dic 2012

    ¿Cuál es el estado de la última declaración anual para H.P.L.C. TECHNOLOGY COMPANY LIMITED?

    Declaración anual
    Última declaración anual

    ¿Cuáles son las últimas presentaciones para H.P.L.C. TECHNOLOGY COMPANY LIMITED?

    Presentaciones
    FechaDescripciónDocumentoTipo

    Boletín oficial final disuelto por cancelación voluntaria

    1 páginasGAZ2(A)

    Cese del nombramiento de Nicola Jane Ward como secretario el 18 dic 2014

    1 páginasTM02

    Primer aviso en el boletín oficial para la cancelación voluntaria

    1 páginasGAZ1(A)

    Solicitud de exclusión de la empresa del registro

    3 páginasDS01

    Déclaration annuelle établie au 13 ago 2014 avec liste complète des actionnaires

    4 páginasAR01
    Presentaciones asociadas
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    capital13 ago 2014

    Estado de capital el 13 ago 2014

    • Capital: GBP 1
    SH01

    Estado de capital el 09 jun 2014

    • Capital: GBP 1
    4 páginasSH19

    legacy

    1 páginasSH20

    legacy

    1 páginasCAP-SS

    Resoluciones

    Resolutions
    1 páginasRESOLUTIONS
    Acuerdos
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    capital

    Resolución de reducción del capital social emitido

    RES06

    Cese del nombramiento de Lucie Mary Katja Grant como director el 10 mar 2014

    1 páginasTM01

    Cese del nombramiento de Katie Rose Wright como director el 10 mar 2014

    1 páginasTM01

    Los registros se han trasladado a la dirección del domicilio social registrado

    1 páginasAD04

    Domicilio social registrado cambiado de , Solaar House, 19 Mercers Row, Cambridge, CB5 8BZ el 07 mar 2014

    1 páginasAD01

    Cambio de datos del secretario Nicola Jane Ward el 01 oct 2009

    1 páginasCH03

    Cambio de datos del director Katie Rose Wright el 03 mar 2014

    2 páginasCH01

    Cambio de datos del director Kevin Neil Wheeler el 03 mar 2014

    2 páginasCH01

    Cambio de datos del director Lucie Mary Katja Grant el 03 mar 2014

    2 páginasCH01

    Cuentas preparadas hasta el 31 dic 2012

    1 páginasAA

    Déclaration annuelle établie au 13 ago 2013 avec liste complète des actionnaires

    6 páginasAR01

    La dirección de inspección del registro se ha cambiado de Webber House 26-28 Market Street Altrincham Cheshire WA14 1PF

    1 páginasAD02

    Cambio de datos del secretario Oakwood Corporate Secretary Limited el 13 ago 2013

    2 páginasCH04

    Cambio de datos del director Lucie Mary Katja Grant el 10 jul 2013

    2 páginasCH01

    Nombramiento de Lucie Mary Katja Grant como director el 07 feb 2013

    2 páginasAP01

    Cese del nombramiento de Iain Alasdair Keith Moodie como director el 07 feb 2013

    1 páginasTM01

    Déclaration annuelle établie au 13 ago 2012 avec liste complète des actionnaires

    5 páginasAR01

    ¿Quiénes son los directivos de H.P.L.C. TECHNOLOGY COMPANY LIMITED?

    Directivos
    NombreNombrado elRenunció elRolDirecciónIdentificación de la empresaPaís de residenciaNacionalidadFecha de nacimientoOcupaciónNúmero
    OAKWOOD CORPORATE SECRETARY LIMITED
    Floor 1 Ashley Road
    WA14 2DT Altrincham
    3rd
    Cheshire
    Secretario corporativo
    Floor 1 Ashley Road
    WA14 2DT Altrincham
    3rd
    Cheshire
    Tipo de identificaciónEEE
    Número de registro7038430
    146358090001
    WHEELER, Kevin Neil
    WA14 2DT Altrincham
    3rd Floor, 1 Ashley Road
    Cheshire
    England
    Director
    WA14 2DT Altrincham
    3rd Floor, 1 Ashley Road
    Cheshire
    England
    United KingdomBritishTax Manager80845970007
    CHALLEN, Robert John
    16 Hill Meadow
    Overton
    RG25 3JD Basingstoke
    Hampshire
    Secretario
    16 Hill Meadow
    Overton
    RG25 3JD Basingstoke
    Hampshire
    British46308620001
    GRAHAM, Alan William
    32 Coles Mede
    Otterbourne
    SO21 2EG Winchester
    Hampshire
    Secretario
    32 Coles Mede
    Otterbourne
    SO21 2EG Winchester
    Hampshire
    British57287700001
    JENKINS, Mark Andrew
    Elba House
    Goosey
    SN7 8PA Farringdon
    Oxfordshire
    Secretario
    Elba House
    Goosey
    SN7 8PA Farringdon
    Oxfordshire
    British96552770001
    KERRY, Tony Sidney
    76 Holtspur Top Lane
    HP9 1DT Beaconsfield
    Buckinghamshire
    Secretario
    76 Holtspur Top Lane
    HP9 1DT Beaconsfield
    Buckinghamshire
    British813240001
    NEWTON, Roger James
    Holmelea
    Sonning Lane Sonning
    RG4 6ST Reading
    Berkshire
    Secretario
    Holmelea
    Sonning Lane Sonning
    RG4 6ST Reading
    Berkshire
    British82462930001
    TABBERER, Gary Michael
    7
    Witton Hill
    SO24 9PT Alresford
    Hampshire
    Secretario
    7
    Witton Hill
    SO24 9PT Alresford
    Hampshire
    British59565250001
    WARD, Nicola Jane
    19 Mercers Row
    CB5 8BZ Cambridge
    Solaar House
    England
    Secretario
    19 Mercers Row
    CB5 8BZ Cambridge
    Solaar House
    England
    British68596390003
    A G SECRETARIAL LIMITED
    100 Barbirolli Square
    M2 3AB Manchester
    Secretario corporativo
    100 Barbirolli Square
    M2 3AB Manchester
    90084920001
    BETTS, Christopher Thomas
    Tanglewood
    The Ride Ifold
    RH14 0TF Bilinghurst
    West Sussex
    Director
    Tanglewood
    The Ride Ifold
    RH14 0TF Bilinghurst
    West Sussex
    BritishManager87626190001
    COLEY, James Robert Ewen
    19 Mercers Row
    CB5 8BZ Cambridge
    Solaar House
    United Kingdom
    Director
    19 Mercers Row
    CB5 8BZ Cambridge
    Solaar House
    United Kingdom
    United KingdomBritishSolicitor68949300008
    DUARTE, Cornelius Richard
    3730 Stocksbridge
    Sugar Land
    77479 Texas
    Usa
    Director
    3730 Stocksbridge
    Sugar Land
    77479 Texas
    Usa
    AmericanPresident & Ceo34913620001
    GRANT, Lucie Mary Katja
    WA14 2DT Altrincham
    3rd Floor, 1 Ashley Road
    Cheshire
    England
    Director
    WA14 2DT Altrincham
    3rd Floor, 1 Ashley Road
    Cheshire
    England
    United KingdomBritishSolicitor175111280003
    INGRAM, Gerald Vaughan
    74 Lanbourne Drive
    Locks Heath
    SO3 Southampton
    Hants
    Director
    74 Lanbourne Drive
    Locks Heath
    SO3 Southampton
    Hants
    BritishCompany Director29674830001
    MCARDLE, Eamonn
    Brookfields Little London Road
    RG7 2PP Silchester
    Berkshire
    Director
    Brookfields Little London Road
    RG7 2PP Silchester
    Berkshire
    United KingdomBritishDirector112644970001
    MOODIE, Iain Alasdair Keith
    19 Mercers Row
    CB5 8BZ Cambridge
    Solaar House
    United Kingdom
    Director
    19 Mercers Row
    CB5 8BZ Cambridge
    Solaar House
    United Kingdom
    EnglandBritishSolicitor226426120003
    NEAME, Michael John Henry, Dr
    13b Central Street
    Ludgershall
    SP11 9RA Andover
    Hampshire
    Director
    13b Central Street
    Ludgershall
    SP11 9RA Andover
    Hampshire
    BritishGeneral Manager34126010003
    PERKINS, James Ian
    21 Almond Way
    LE17 4XJ Lutterworth
    Leicestershire
    Director
    21 Almond Way
    LE17 4XJ Lutterworth
    Leicestershire
    BritishGeneral Manager38242790001
    PORTER, Simon
    48 Blenheim Road
    Caversham
    RG4 7RS Reading
    Berkshire
    Director
    48 Blenheim Road
    Caversham
    RG4 7RS Reading
    Berkshire
    BritishFinance Director55262300001
    SANGER, James Gerald
    Moreton House
    High Road Brightwell Cum Sotwell
    OX10 0PT Wallingford
    Oxfordshire
    Director
    Moreton House
    High Road Brightwell Cum Sotwell
    OX10 0PT Wallingford
    Oxfordshire
    EnglandUnited KingdomFinance Director13748460001
    SMITH, Kenneth E
    4118 Clayhead Road
    77469 Richmond
    Texas
    Usa
    Director
    4118 Clayhead Road
    77469 Richmond
    Texas
    Usa
    AmericanCompany Director45434480001
    STANDLEY, Allen Frederick
    5 Lambridge Wood Road
    RG9 3BP Henley On Thames
    Northlands
    Oxfordshire
    Director
    5 Lambridge Wood Road
    RG9 3BP Henley On Thames
    Northlands
    Oxfordshire
    BritishChief Executive34174780003
    WHEELER, Kevin Neil
    4 Vicarage Farm Yard
    Abbotsley
    PE19 6US St Neots
    Cambridgeshire
    Director
    4 Vicarage Farm Yard
    Abbotsley
    PE19 6US St Neots
    Cambridgeshire
    BritishTax Manager80845970001
    WRIGHT, Katie Rose
    WA14 2DT Altrincham
    3rd Floor, 1 Ashley Road
    Cheshire
    England
    Director
    WA14 2DT Altrincham
    3rd Floor, 1 Ashley Road
    Cheshire
    England
    United KingdomBritishAccountant156438380002

    ¿Tiene H.P.L.C. TECHNOLOGY COMPANY LIMITED alguna carga?

    Gravámenes
    ClasificaciónFechasEstadoDetalles
    Trust deed
    Creado el 01 abr 1982
    Entregado el 16 abr 1982
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    Debenture stock of bidgold limited amounting to £1,200,000 variable rate debenture stock 1987/91
    Breve descripción
    Fixed & floating charges undertaking andll property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital all buildings fixtures (inc. Trade fixtures) fixed plant & machinery.
    Personas con derecho
    • Cin Industrial Finance Limited
    Transacciones
    • 16 abr 1982Registro de una carga
    Guarantee & debenture
    Creado el 01 abr 1982
    Entregado el 13 abr 1982
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company and/or bidgold limited to the chargee on any account whatsoever.
    Breve descripción
    Fixed & floating charges undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital. With all buildings fixtures (incl. Trade fixtures) fixed plant & machinery.
    Personas con derecho
    • Barclays Bank PLC
    Transacciones
    • 13 abr 1982Registro de una carga
    Guarantee & debenture
    Creado el 01 abr 1982
    Entregado el 13 abr 1982
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company and/or bidgold limited to the chargee on any account whatsoever.
    Breve descripción
    Fixed & floating charges undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts & uncalled capital. With all buildings fixtures (and trade fixtures) fixed plant & machinery.
    Personas con derecho
    • Barclays Merchant Bank LTD
    Transacciones
    • 13 abr 1982Registro de una carga
    Supplemental trust deed
    Creado el 29 ene 1981
    Entregado el 16 feb 1981
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    £4,536,211 (see doc ,45)
    Breve descripción
    Floating charge over. Undertaking and all property and assets present and future including uncalled capital.
    Personas con derecho
    • Alliance Assurance Company LTD
    Transacciones
    • 16 feb 1981Registro de una carga

    Fuente de datos

    • Companies House del Reino Unido
      El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros.
    • Licencia: CC0