DRAKE & SCULL PROPERTIES

DRAKE & SCULL PROPERTIES

  • Visión general
  • Resumen
  • Propósito
  • Dirección
  • Nombres anteriores
  • Cuentas
  • Declaración anual
  • Presentaciones
  • Directivos
  • Gravámenes
  • Fuente de datos
  • Visión general

    Nombre de la empresaDRAKE & SCULL PROPERTIES
    Estado de la empresaDisuelta
    Forma jurídicaSociedad privada sin límite de capital
    Número de empresa 00905382
    JurisdicciónInglaterra/Gales
    Fecha de constitución
    Fecha de cese

    Resumen

    Tiene PSCs súper segurosNo
    Tiene gravámenes
    Tiene historial de insolvenciaNo
    La sede social está en disputaNo

    ¿Cuál es el propósito de DRAKE & SCULL PROPERTIES?

    • Actividades de oficinas centrales (70100) / Actividades profesionales, científicas y técnicas

    ¿Dónde se encuentra DRAKE & SCULL PROPERTIES?

    Dirección de la sede social
    1 The Crescent
    KT6 4BN Surbiton
    Surrey
    United Kingdom
    Dirección de la sede social no entregableNo

    ¿Cuáles fueron los nombres anteriores de DRAKE & SCULL PROPERTIES?

    Nombres anteriores de la empresa
    Nombre de la empresaDesdeHasta
    JWP LEASING LIMITED16 ago 199316 ago 1993
    JWP INFORMATION SERVICES LIMITED20 feb 199220 feb 1992
    BUSINESSLAND (UK) LIMITED01 nov 198701 nov 1987
    GRANADA MICROCOMPUTER SERVICES LIMITED25 ene 198325 ene 1983

    ¿Cuáles son las últimas cuentas de DRAKE & SCULL PROPERTIES?

    Últimas cuentas
    Últimas cuentas cerradas hasta31 dic 2012

    ¿Cuál es el estado de la última declaración anual para DRAKE & SCULL PROPERTIES?

    Declaración anual
    Última declaración anual

    ¿Cuáles son las últimas presentaciones para DRAKE & SCULL PROPERTIES?

    Presentaciones
    FechaDescripciónDocumentoTipo

    Boletín oficial final disuelto por cancelación voluntaria

    1 páginasGAZ2(A)

    Primer aviso en el boletín oficial para la cancelación voluntaria

    GAZ1(A)

    Solicitud de exclusión de la empresa del registro

    3 páginasDS01

    Déclaration annuelle établie au 21 sept 2013 avec liste complète des actionnaires

    5 páginasAR01
    Presentaciones asociadas
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    capital25 sept 2013

    Estado de capital el 25 sept 2013

    • Capital: GBP 100
    SH01
    Anotaciones
    FechaAnotación
    20 dic 2021Other The address of any individual marked (#) was replaced with a service address or partially redacted on 20/12/2021 under section 1088 of the Companies Act 2006

    Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 31 dic 2012

    4 páginasAA

    Nombramiento de Mr Christopher John Howse como director

    2 páginasAP01

    Domicilio social registrado cambiado de , 1 Thameside Centre, Kew Bridge Road, Kew Bridge, Middlesex, TW8 0HF el 03 dic 2012

    1 páginasAD01

    Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 31 dic 2011

    4 páginasAA

    Déclaration annuelle établie au 21 sept 2012 avec liste complète des actionnaires

    5 páginasAR01
    Anotaciones
    FechaAnotación
    20 dic 2021Other The address of any individual marked (#) was replaced with a service address or partially redacted on 20/12/2021 under section 1088 of the Companies Act 2006

    Cese del nombramiento de John Matthews como director

    1 páginasTM01

    Cese del nombramiento de Frank Macinnis como director

    1 páginasTM01

    Nombramiento de Mr Anthony J Guzzi como director

    2 páginasAP01

    Resoluciones

    Resolutions
    3 páginasRESOLUTIONS
    Acuerdos
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    incorporation

    Resolución del Memorándum de Asociación

    RES01

    Déclaration annuelle établie au 21 sept 2011 avec liste complète des actionnaires

    6 páginasAR01
    Anotaciones
    FechaAnotación
    20 dic 2021Other The address of any individual marked (#) was replaced with a service address or partially redacted on 20/12/2021 under section 1088 of the Companies Act 2006

    Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 31 dic 2010

    4 páginasAA

    Déclaration annuelle établie au 21 sept 2010 avec liste complète des actionnaires

    6 páginasAR01
    Anotaciones
    FechaAnotación
    20 dic 2021Other The address of any individual marked (#) was replaced with a service address or partially redacted on 20/12/2021 under section 1088 of the Companies Act 2006

    Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 31 dic 2009

    4 páginasAA

    legacy

    3 páginasMG04

    legacy

    3 páginasMG04

    Déclaration annuelle établie au 16 sept 2009 avec liste complète des actionnaires

    10 páginasAR01
    Anotaciones
    FechaAnotación
    20 dic 2021Other The address of any individual marked (#) was replaced with a service address or partially redacted on 20/12/2021 under section 1088 of the Companies Act 2006

    legacy

    1 páginas288a

    Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 31 dic 2008

    7 páginasAA

    legacy

    1 páginas288b

    legacy

    7 páginas363s
    Anotaciones
    FechaAnotación
    20 dic 2021Other The address of any individual marked (#) was replaced with a service address or partially redacted on 20/12/2021 under section 1088 of the Companies Act 2006

    Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 31 dic 2007

    4 páginasAA

    ¿Quiénes son los directivos de DRAKE & SCULL PROPERTIES?

    Directivos
    NombreNombrado elRenunció elRolDirecciónIdentificación de la empresaPaís de residenciaNacionalidadFecha de nacimientoOcupaciónNúmero
    WALKER, Michael Lawrence
    159 Court Lane
    Dulwich
    SE21 7EE London
    Secretario
    159 Court Lane
    Dulwich
    SE21 7EE London
    British33962790001
    CHANTER, Keith
    KT23
    Director
    KT23
    United KingdomBritish126079170001
    GUZZI, Anthony J
    The Crescent
    KT6 4BN Surbiton
    1
    Surrey
    United Kingdom
    Director
    The Crescent
    KT6 4BN Surbiton
    1
    Surrey
    United Kingdom
    United StatesAmerican167510820001
    HOWSE, Christopher John
    The Crescent
    KT6 4BN Surbiton
    1
    Surrey
    United Kingdom
    Director
    The Crescent
    KT6 4BN Surbiton
    1
    Surrey
    United Kingdom
    United KingdomBritish58746330001
    ROUSOU, James
    20 Daws Hill Lane
    HP11 1PW High Wycombe
    Buckinghamshire
    Secretario
    20 Daws Hill Lane
    HP11 1PW High Wycombe
    Buckinghamshire
    British75634630001
    THACKRAH, Kevin Paul
    The Spinney Elm Lane
    Lower Earley
    RG6 5UQ Reading
    Berkshire
    Secretario
    The Spinney Elm Lane
    Lower Earley
    RG6 5UQ Reading
    Berkshire
    British46486190001
    BRITTON, Graham
    Millstream
    Lower Peover
    WA16 9QD Knutsford
    Cheshire
    Director
    Millstream
    Lower Peover
    WA16 9QD Knutsford
    Cheshire
    British34559340001
    CRITCHLOW, Norman James
    19 Danehurst Close
    TW20 9PX Egham
    Surrey
    Director
    19 Danehurst Close
    TW20 9PX Egham
    Surrey
    United KingdomBritish67957920001
    CROWELL, Robert Jeryl
    115 Warpole Street
    Dover
    Massachusetts
    02030
    Usa
    Director
    115 Warpole Street
    Dover
    Massachusetts
    02030
    Usa
    American52328890002
    DAVIES, Brian John
    11 Woodlands Glade
    HP9 1JZ Beaconsfield
    Buckinghamshire
    Director
    11 Woodlands Glade
    HP9 1JZ Beaconsfield
    Buckinghamshire
    British30176020003
    DAVIS, Martin Kennett
    212 Clive Road
    West Dulwich
    SE21 8BS London
    Director
    212 Clive Road
    West Dulwich
    SE21 8BS London
    United KingdomBritish16398050001
    DEPHIN, Pierre
    50 Rue De Gometz
    FOREIGN Bures 91440
    France
    Director
    50 Rue De Gometz
    FOREIGN Bures 91440
    France
    French31603810001
    DWYER, Andrew Thompson
    532 Catitoe Road
    FOREIGN Bedford
    New York
    Usa
    Director
    532 Catitoe Road
    FOREIGN Bedford
    New York
    Usa
    American16258580001
    GAY, Andrew
    Bircham Dyson Bell
    50 Broadway
    SW1H 0BL London
    Director
    Bircham Dyson Bell
    50 Broadway
    SW1H 0BL London
    United KingdomBritish73774260004
    GOSCOMB, Christopher Roderick John
    Chichele Cottage
    11 Chichele Road
    RH8 0AE Oxted
    Surrey
    Director
    Chichele Cottage
    11 Chichele Road
    RH8 0AE Oxted
    Surrey
    UkBritish1610330001
    GRENDI, Ernest Walter
    57 Harbor Hill Drive
    FOREIGN Lloyd Harbor
    New York 11743
    Usa
    Director
    57 Harbor Hill Drive
    FOREIGN Lloyd Harbor
    New York 11743
    Usa
    American13328320001
    KORNFELD, Stephen
    17 Chapel Street
    SW1X 7BY London
    Director
    17 Chapel Street
    SW1X 7BY London
    British35561690002
    MACINNIS, Frank Thomas
    7 Sturges Hollow
    IRISH Westport
    Connecticut 06880
    Usa
    Director
    7 Sturges Hollow
    IRISH Westport
    Connecticut 06880
    Usa
    UsaCanadian40058020001
    MATTHEWS, John
    Springhill Cottage
    Foxlydiate Lane Webheath
    B97 5PB Redditch
    Worcestershire
    Director
    Springhill Cottage
    Foxlydiate Lane Webheath
    B97 5PB Redditch
    Worcestershire
    EnglandBritish93708330001
    MCCHESNEY, Brookes
    1001 Ridder Park Drive
    FOREIGN San Jose
    California 95131
    Usa
    Director
    1001 Ridder Park Drive
    FOREIGN San Jose
    California 95131
    Usa
    American31603800001
    MOORE, Clive Alan
    239 Bedford Hill
    SW16 1LB London
    Director
    239 Bedford Hill
    SW16 1LB London
    British37447250001
    NORMAN, David Arthur
    16101 Greenwood Road
    FOREIGN Monte Sereno
    California 95030
    Usa
    Director
    16101 Greenwood Road
    FOREIGN Monte Sereno
    California 95030
    Usa
    American25351470001
    PAUL, Dennis Kent
    14711 Viekery Place
    Saratdea
    California 900700
    Usa
    Director
    14711 Viekery Place
    Saratdea
    California 900700
    Usa
    American31603830001
    ROUSOU, James
    20 Daws Hill Lane
    HP11 1PW High Wycombe
    Buckinghamshire
    Director
    20 Daws Hill Lane
    HP11 1PW High Wycombe
    Buckinghamshire
    British75634630001
    WEST, John Vaughan Chanler
    63 Pasture Road
    SG6 3LS Letchworth
    Hertfordshire
    Director
    63 Pasture Road
    SG6 3LS Letchworth
    Hertfordshire
    United KingdomBritish30124410001
    WHALE, Anthony Roger
    Hadleigh 8 Beechwood Road
    HP9 1HP Beaconsfield
    Buckinghamshire
    Director
    Hadleigh 8 Beechwood Road
    HP9 1HP Beaconsfield
    Buckinghamshire
    British41878460001

    ¿Tiene DRAKE & SCULL PROPERTIES alguna carga?

    Gravámenes
    ClasificaciónFechasEstadoDetalles
    Debenture
    Creado el 12 ene 2006
    Entregado el 24 ene 2006
    Pendiente
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee and the lenders under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descripción
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill uncalled capital fixtures plant and machinery,. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • Harris N.A. as Agent and Security Trustee for the Lenders (The Security Trustee)
    Transacciones
    • 24 ene 2006Registro de un cargo (395)
    • 21 abr 2010Declaración de que parte o la totalidad de la propiedad gravada ha sido liberada (MG04)
    Debenture
    Creado el 05 nov 2002
    Entregado el 07 nov 2002
    Pendiente
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descripción
    Assigns all the plant, machinery, fixtures and fittings now and in the future belonging to the chargor and all right, title and interest of the chargor under any agreements now and in the future relating to the purchase, lease or hire purchase of the same, subject to reassignment on redemption... See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • Harris Trust and Savings Bank as Agent and Security Trustee for the Lenders
    Transacciones
    • 07 nov 2002Registro de un cargo (395)
    • 21 abr 2010Declaración de que parte o la totalidad de la propiedad gravada ha sido liberada (MG04)
    Supplemental mortgage
    Creado el 31 mar 2000
    Entregado el 13 abr 2000
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies and liabilities due or to become due from the borrowers (as defined) to the chargee under the credit agreement and the company under a guarantee dated 29TH october 1997
    Breve descripción
    Land and buildings lying to the east of thurston road, great barton. T/no. SK113189. Redcliffe house, whitehouse street, bedminster. T/no. AV63756 and BL16664. Together with all buildings, fixtures and other fixed plant and machinery. Specific charge all the income and rights relating thereto.
    Personas con derecho
    • Harris Trust and Savings Bank as Agent for the Lenders
    Transacciones
    • 13 abr 2000Registro de un cargo (395)
    • 27 ago 2003Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Deed of reaffirmation and accession
    Creado el 22 dic 1998
    Entregado el 07 ene 1999
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the borrowers (as therein defined) to the chargee under the credit agreement dated 19 june 1996 and all sums due under a guarantee dated 29 october 1997
    Breve descripción
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • Harris Trust & Savings Bank(As Agent)
    Transacciones
    • 07 ene 1999Registro de un cargo (395)
    • 27 ago 2003Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    General debenture
    Creado el 29 oct 1997
    Entregado el 30 oct 1997
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies and liabilities due or to become due from the borrowers (as defined therein) to the chargee under a credit agreement dated 19TH june 1997
    Breve descripción
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • Harris Trust & Savings Bank (As Agent for the Lenders) as Collateral Agent
    Transacciones
    • 30 oct 1997Registro de un cargo (395)
    • 27 ago 2003Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Letter of charge
    Creado el 03 abr 1997
    Entregado el 08 abr 1997
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    All monies now or at any time standing to the credit of any account or accounts of the company in the books of the bank.
    Personas con derecho
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transacciones
    • 08 abr 1997Registro de un cargo (395)
    • 05 abr 2006Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Deed of charge over credit balances
    Creado el 29 oct 1996
    Entregado el 04 nov 1996
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    Barclays bank PLC re jwp leasing LTD gts deposit deal no 86994899. see the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • Barclays Bank PLC
    Transacciones
    • 04 nov 1996Registro de un cargo (395)
    • 28 sept 2002Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Deed of charge over credit balances
    Creado el 11 oct 1996
    Entregado el 17 oct 1996
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    Fixed charge over all the "deposit(s)" into charged deposit with barclays bank PLC re:- jwp leasing limited gts deposit deal number :-64754577. see the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • Barclays Bank PLC
    Transacciones
    • 17 oct 1996Registro de un cargo (395)
    • 27 feb 1997Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Debenture
    Creado el 20 sept 1993
    Entregado el 28 sept 1993
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • Seaboard Surety Company
    Transacciones
    • 28 sept 1993Registro de un cargo (395)
    • 16 oct 1997Declaración de que parte o la totalidad de la propiedad de una carga flotante ha sido liberada (403b)
    • 16 may 2007Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Debenture
    Creado el 20 sept 1993
    Entregado el 27 sept 1993
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • Barclays Bank PLC
    Transacciones
    • 27 sept 1993Registro de un cargo (395)
    • 27 feb 1997Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)

    Fuente de datos

    • Companies House del Reino Unido
      El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros.
    • Licencia: CC0