COLONNADE INSURANCE BROKERS
Visión general
| Nombre de la empresa | COLONNADE INSURANCE BROKERS |
|---|---|
| Estado de la empresa | Disuelta |
| Forma jurídica | Sociedad privada sin límite de capital |
| Número de empresa | 00909558 |
| Jurisdicción | Inglaterra/Gales |
| Fecha de constitución | |
| Fecha de cese |
Resumen
| Tiene PSCs súper seguros | No |
|---|---|
| Tiene gravámenes | Sí |
| Tiene historial de insolvencia | No |
| La sede social está en disputa | No |
¿Cuál es el propósito de COLONNADE INSURANCE BROKERS?
- Compañía no comercial (74990) / Actividades profesionales, científicas y técnicas
¿Dónde se encuentra COLONNADE INSURANCE BROKERS?
| Dirección de la sede social | Embankment West Tower 101 Cathedral Approach M3 7FB Salford United Kingdom |
|---|---|
| Dirección de la sede social no entregable | No |
¿Cuáles fueron los nombres anteriores de COLONNADE INSURANCE BROKERS?
| Nombre de la empresa | Desde | Hasta |
|---|---|---|
| COLONNADE INSURANCE BROKERS | 09 jul 2008 | 09 jul 2008 |
| COLONNADE INSURANCE BROKERS LIMITED | 31 dic 1976 | 31 dic 1976 |
| EDWARD LUMLEY LIFE & PENSIONS (MIDLANDS) LIMITED | 29 jun 1967 | 29 jun 1967 |
¿Cuáles son las últimas cuentas de COLONNADE INSURANCE BROKERS?
| Últimas cuentas | |
|---|---|
| Últimas cuentas cerradas hasta | 31 dic 2019 |
¿Cuáles son las últimas presentaciones para COLONNADE INSURANCE BROKERS?
| Fecha | Descripción | Documento | Tipo | |
|---|---|---|---|---|
Boletín oficial final disuelto por cancelación voluntaria | 1 páginas | GAZ2(A) | ||
Primer aviso en el boletín oficial para la cancelación voluntaria | 1 páginas | GAZ1(A) | ||
Solicitud de exclusión de la empresa del registro | 3 páginas | DS01 | ||
Cancelación total de la carga 2 | 1 páginas | MR04 | ||
Cancelación total de la carga 3 | 1 páginas | MR04 | ||
Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 31 dic 2019 | 5 páginas | AA | ||
Declaración de confirmación presentada el 16 oct 2020 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||
Nombramiento de Mr Ian James Donaldson como director el 31 dic 2019 | 2 páginas | AP01 | ||
Cese del nombramiento de Scott Stewart Kennedy como director el 30 dic 2019 | 1 páginas | TM01 | ||
Cese del nombramiento de Janice Deakin como director el 30 dic 2019 | 1 páginas | TM01 | ||
Declaración de confirmación presentada el 16 oct 2019 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||
Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 31 dic 2018 | 5 páginas | AA | ||
Cese del nombramiento de Annabel Felicity Wilson como secretario el 31 dic 2018 | 1 páginas | TM02 | ||
Cese del nombramiento de David Robert Harding como director el 31 dic 2018 | 1 páginas | TM01 | ||
Nombramiento de Mr Craig David Ball como director el 31 dic 2018 | 2 páginas | AP01 | ||
Nombramiento de Dean Clarke como secretario el 31 dic 2018 | 2 páginas | AP03 | ||
Nombramiento de Ms Janice Deakin como director el 31 dic 2018 | 2 páginas | AP01 | ||
Nombramiento de Mr Scott Stewart Kennedy como director el 31 dic 2018 | 2 páginas | AP01 | ||
Declaración de confirmación presentada el 16 oct 2018 con actualizaciones | 4 páginas | CS01 | ||
Cese del nombramiento de Gilles Normand como director el 03 oct 2018 | 1 páginas | TM01 | ||
Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 31 dic 2017 | 5 páginas | AA | ||
Todo el bien o empresa ha sido liberado y ya no forma parte de la carga 2 | 5 páginas | MR05 | ||
Declaración de confirmación presentada el 12 oct 2017 con actualizaciones | 4 páginas | CS01 | ||
Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 31 dic 2016 | 5 páginas | AA | ||
Todo el bien o empresa ha sido liberado y ya no forma parte de la carga 3 | 2 páginas | MR05 | ||
¿Quiénes son los directivos de COLONNADE INSURANCE BROKERS?
| Nombre | Nombrado el | Renunció el | Rol | Dirección | Identificación de la empresa | País de residencia | Nacionalidad | Fecha de nacimiento | Ocupación | Número |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CLARKE, Dean | Secretario | 101 Cathedral Approach M3 7FB Salford Embankment West Tower United Kingdom | 255362570001 | |||||||
| BALL, Craig David | Director | 101 Cathedral Approach M3 7FB Salford Embankment West Tower United Kingdom | England | British | 109298830003 | |||||
| DONALDSON, Ian James | Director | 101 Cathedral Approach M3 7FB Salford Embankment West Tower United Kingdom | England | British | 253784440001 | |||||
| DESRAY, Georges | Secretario | 6 Great Marlborough Street M1 5SW Manchester Swinton House United Kingdom | 169859350001 | |||||||
| HARGREAVES, Sally Anne | Secretario | Swinton House 6 Great Marlborough Street M1 5SW Manchester Greater Manchester | English | 1778900007 | ||||||
| MARSHALL SMITH, Rosamond Joy | Secretario | Colonnade Sunbridge Road BD1 2LQ Bradford West Yorkshire | British | 17986770001 | ||||||
| PLUMER, Christian Charles | Secretario | 6 Great Marlborough Street M1 5SW Manchester Swinton House United Kingdom | 189559820001 | |||||||
| VEVERS, Peter Anthony | Secretario | 35 New Close Road Nab Wood BD18 4AU Shipley West Yorkshire | British | 32573450001 | ||||||
| WILSON, Annabel Felicity | Secretario | RG1 8DA Reading Norman Place United Kingdom | 196024110001 | |||||||
| BARDET, Christophe Marie Fred | Director | 6 Great Marlborough Street M1 5SW Manchester Swinton House United Kingdom | United Kingdom | French | 165770320001 | |||||
| BELL, Howard James | Director | 2 Five Oaks Baildon BD17 5DF Shipley West Yorkshire | British | 8909130001 | ||||||
| BELLRINGER, Charles Albert John | Director | 6 Great Marlborough Street M1 5SW Manchester Swinton House United Kingdom | United Kingdom | British | 132720300001 | |||||
| BULLOCK, Ian Jeffrey | Director | 2 Conisborough Close Burley In Wharfedale LS29 7BN Ilkley West Yorkshire | England | British | 121645010001 | |||||
| BUTCHER, Edward Herbert | Director | Horton 43 Gill Bank Road LS29 0AU Ilkley West Yorkshire | British | 8906110001 | ||||||
| CHIPPENDALE, Ian Hugh | Director | 10 Ambleside Drive Walton WF2 6TJ Wakefield West Yorkshire | British | 10033650001 | ||||||
| CLARE, Anthony Peter | Director | 6 Great Marlborough Street M1 5SW Manchester Swinton House | United Kingdom | British | 51441260002 | |||||
| DEAKIN, Janice | Director | Eclipse Park Sittingbourne Road ME14 3EN Maidstone Towergate House United Kingdom | England | British | 238355920001 | |||||
| DESRAY, Georges | Director | 6 Great Marlborough Street M1 5SW Manchester Swinton House United Kingdom | England | French | 167333040002 | |||||
| EKINS, Martin | Director | Green Lane House Hedge Top Lane HX3 7ER Halifax West Yorkshire | British | 56361880002 | ||||||
| FRYER, Peter Roger | Director | 10 St Margarets Drive Horsforth LS18 5BQ Leeds West Yorkshire | British | 8929730001 | ||||||
| GLEN, Robert John | Director | 5 High Meadows Firth Lane Wilsden BD15 0HN Bradford West Yorkshire | England | United Kingdom | 87214920001 | |||||
| HALPIN, Peter Joseph | Director | Swinton House 6 Great Marlborough Street M1 5SW Manchester Greater Manchester | United Kingdom | British | 38789050002 | |||||
| HARDING, David Robert | Director | 101 Cathedral Approach M3 7FB Salford Embankment West Tower United Kingdom | United Kingdom | British | 196407900002 | |||||
| HAZELDINE, Adrian Mark | Director | Swinton House 6 Great Marlborough Street M1 5SW Manchester Greater Manchester | United Kingdom | British | 55020250002 | |||||
| HOLT, Gillian Mary | Director | Clough Cottage Midgley HX2 6XB Halifax West Yorkshire | British | 27359820001 | ||||||
| HUTTON, Michael | Director | Woodland House 8 The Orchards, Lady Lane BD16 4AZ Bingley | British | 78423980001 | ||||||
| JACKSON, Andrew Edwin | Director | Whipps Farmhouse Whipps Lane Fundenhall NR16 1DT Norwich Norfolk | British | 83473970001 | ||||||
| JACKSON, Colin William | Director | 4 Woodlands Grove Baildon BD17 5BD Shipley West Yorkshire | British | 40718570002 | ||||||
| JOHNSTONE, Christopher Charles | Director | Calverstones 21 Sandyfoot Barkisland HX4 0JA Halifax West Yorkshire | British | 53747580001 | ||||||
| KENNEDY, Scott Stewart | Director | 101 Cathedral Approach M3 7FB Salford Embankment West Tower United Kingdom | England | British | 211745270001 | |||||
| LOMAS, John | Director | Flat 7 67 Leylands Lane BD9 5QT Bradford | British | 83783920001 | ||||||
| NORMAND, Gilles | Director | 101 Cathedral Approach M3 7FB Salford Embankment West Tower United Kingdom | United Kingdom | French | 175288680002 | |||||
| ORDISH, Jackie | Director | Swinton House 6 Great Marlborough Street M1 5SW Manchester Greater Manchester | United Kingdom | British | 77859180001 | |||||
| PLUMER, Christian Charles | Director | 6 Great Marlborough Street M1 5SW Manchester Swinton House United Kingdom | United Kingdom | British | 130813500001 | |||||
| POTTS, Nicholas | Director | 4 Ringstone Kromlin Barkisland HX4 0EU Halifax | England | British | 64059360004 |
¿Quiénes son las personas con control significativo de COLONNADE INSURANCE BROKERS?
| Nombre | Notificado el | Dirección | Cesado | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Walmsley Insurance Brokers Limited | 06 abr 2016 | 101 Cathedral Approach M3 7FB Salford Embankment West Tower United Kingdom | No | ||||||||||
| |||||||||||||
Naturaleza del control
| |||||||||||||
¿Tiene COLONNADE INSURANCE BROKERS alguna carga?
| Clasificación | Fechas | Estado | Detalles | |
|---|---|---|---|---|
| Deed of admission to an omnibus guarantee and set-off agreement dated 26 may 2006 | Creado el 08 ene 2009 Entregado el 14 ene 2009 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All monies due or to become due from the company and/or all or any of the companies named therein to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Breve descripción Any sum or sums for the time being standing to the credit of any one or more of any present or future accounts of the companies or any of them with the bank (including any accounts held in the bank's name with any designation which includes the name(s) of the companies or any of them) whether such accounts be denominated in sterling or in a currency or currencies other than sterling. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
| Deed of admission to an omnibus guarantee and set-off agreement dated 26TH may 2006 and | Creado el 10 mar 2008 Entregado el 15 mar 2008 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All monies due or to become due from the company and/or all or any of the companies named therein to the chargee on any account whatsoever | |
Breve descripción Any sum or sums for the time being standing to the credit of any present or future account of the company with the bank. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
| Debenture | Creado el 29 may 2002 Entregado el 12 jun 2002 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Breve descripción Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
Fuente de datos
- Companies House del Reino Unido
El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros. - Licencia: CC0