BAILEY NEWSPAPER GROUP LIMITED
Visión general
| Nombre de la empresa | BAILEY NEWSPAPER GROUP LIMITED |
|---|---|
| Estado de la empresa | Disuelta |
| Forma jurídica | Sociedad de responsabilidad limitada |
| Número de empresa | 00913599 |
| Jurisdicción | Inglaterra/Gales |
| Fecha de constitución | |
| Fecha de cese |
Resumen
| Tiene PSCs súper seguros | No |
|---|---|
| Tiene gravámenes | Sí |
| Tiene historial de insolvencia | No |
| La sede social está en disputa | No |
¿Cuál es el propósito de BAILEY NEWSPAPER GROUP LIMITED?
- Compañía no comercial (74990) / Actividades profesionales, científicas y técnicas
¿Dónde se encuentra BAILEY NEWSPAPER GROUP LIMITED?
| Dirección de la sede social | Loudwater Mill Station Road HP10 9TY High Wycombe Buckinghamshire |
|---|---|
| Dirección de la sede social no entregable | No |
¿Cuáles fueron los nombres anteriores de BAILEY NEWSPAPER GROUP LIMITED?
| Nombre de la empresa | Desde | Hasta |
|---|---|---|
| F. BAILEY & SON (HOLDINGS) LIMITED | 31 dic 1980 | 31 dic 1980 |
| F. BAILEY AND SON DURSLEY (HOLDINGS) LIMITED | 21 ago 1967 | 21 ago 1967 |
¿Cuáles son las últimas cuentas de BAILEY NEWSPAPER GROUP LIMITED?
| Últimas cuentas | |
|---|---|
| Últimas cuentas cerradas hasta | 25 dic 2016 |
¿Cuáles son las últimas presentaciones para BAILEY NEWSPAPER GROUP LIMITED?
| Fecha | Descripción | Documento | Tipo | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Boletín oficial final disuelto por cancelación voluntaria | 1 páginas | GAZ2(A) | ||||||||||
Primer aviso en el boletín oficial para la cancelación voluntaria | 1 páginas | GAZ1(A) | ||||||||||
Solicitud de exclusión de la empresa del registro | 3 páginas | DS01 | ||||||||||
Estado de capital el 29 mar 2017
| 5 páginas | SH19 | ||||||||||
legacy | 1 páginas | SH20 | ||||||||||
legacy | 1 páginas | CAP-SS | ||||||||||
Resoluciones Resolutions | 1 páginas | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 25 dic 2016 | 6 páginas | AA | ||||||||||
Declaración de confirmación presentada el 08 sept 2016 con actualizaciones | 5 páginas | CS01 | ||||||||||
Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 27 dic 2015 | 6 páginas | AA | ||||||||||
Cambio de datos del director Mr Paul Anthony Hunter el 26 nov 2015 | 2 páginas | CH01 | ||||||||||
Déclaration annuelle établie au 08 sept 2015 avec liste complète des actionnaires | 6 páginas | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 28 dic 2014 | 7 páginas | AA | ||||||||||
Cambio de datos del director Henry Kennedy Faure Walker el 13 ene 2015 | 2 páginas | CH01 | ||||||||||
Cambio de datos del secretario Mr Neil Edward Carpenter el 13 ene 2015 | 1 páginas | CH03 | ||||||||||
Cambio de datos del secretario Simon Alton Westrop el 13 ene 2015 | 1 páginas | CH03 | ||||||||||
Cambio de datos del director Mr Paul Anthony Hunter el 13 ene 2015 | 2 páginas | CH01 | ||||||||||
Los registros se han trasladado a la ubicación de inspección registrada 9Th and 10Th Floors Quadrant House Sutton Surrey SM2 5AS | 1 páginas | AD03 | ||||||||||
La dirección de inspección del registro se ha cambiado a 9Th and 10Th Floors Quadrant House Sutton Surrey SM2 5AS | 1 páginas | AD02 | ||||||||||
Domicilio social registrado cambiado de 58 Church Street Weybridge Surrey KT13 8DP a Loudwater Mill Station Road High Wycombe Buckinghamshire HP10 9TY el 11 dic 2014 | 1 páginas | AD01 | ||||||||||
Cese del nombramiento de Paul Davidson como director el 11 nov 2014 | 1 páginas | TM01 | ||||||||||
Déclaration annuelle établie au 08 sept 2014 avec liste complète des actionnaires | 6 páginas | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Nombramiento de Henry Kennedy Faure Walker como director | 2 páginas | AP01 | ||||||||||
Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 29 dic 2013 | 7 páginas | AA | ||||||||||
Déclaration annuelle établie au 08 sept 2013 avec liste complète des actionnaires | 5 páginas | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
¿Quiénes son los directivos de BAILEY NEWSPAPER GROUP LIMITED?
| Nombre | Nombrado el | Renunció el | Rol | Dirección | Identificación de la empresa | País de residencia | Nacionalidad | Fecha de nacimiento | Ocupación | Número |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CARPENTER, Neil Edward | Secretario | Quadrant House The Quadrant SM2 5AS Sutton 9th And 10th Floors Surrey United Kingdom | British | 90209080001 | ||||||
| WESTROP, Simon Alton | Secretario | Station Road HP10 9TY High Wycombe Loudwater Mill Buckinghamshire United Kingdom | British | 109662340001 | ||||||
| FAURE WALKER, Henry Kennedy | Director | Station Road HP10 9TY High Wycombe Loudwater Mill Buckinghamshire United Kingdom | England | British | 187012370001 | |||||
| HUNTER, Paul Anthony | Director | Station Road HP10 9TY High Wycombe Loudwater Mill Buckinghamshire United Kingdom | England | English | 69320190004 | |||||
| BAILEY, Michael Frederick | Secretario | 38 Champions Court Henlow Drive GL11 4BE Dursley Gloucestershire | British | 16554690002 | ||||||
| HEDGER, Simon Christopher | Secretario | 21 Brook Avenue North BH25 5HE New Milton Hampshire | British | 1808600002 | ||||||
| HUNTER, Paul Anthony | Secretario | 15 Downs Way KT18 5LU Epsom Surrey | British | 69320190002 | ||||||
| WOOLDRIDGE, Malcolm John | Secretario | 1 Tollgate Close Oakley RG23 7BH Basingstoke Hampshire | British | 49675610001 | ||||||
| BAILEY, Michael Frederick | Director | 38 Champions Court Henlow Drive GL11 4BE Dursley Gloucestershire | Great Britain | British | 16554690002 | |||||
| BAILEY, Peter David | Director | The Glen 11 Twinberrow Lane Woodmancote GL11 4AP Dursley Gloucestershire | England | British | 16554700001 | |||||
| BAILEY, Rachel Margaret | Director | Tudor House Oaksey SN16 9TD Malmesbury Wiltshire | British | 56001150001 | ||||||
| BROWN, James Thomson | Director | Eyhurst Hall 8 Manor House Eyhurst Park Outwood Lane KT20 6JP Kingswood Surrey | British | 4154210013 | ||||||
| CROOK, Anthony Russell | Director | The Old Vicarage The Plain Whiteshill GL6 6AA Stroud Gloucestershire | British | 60115620001 | ||||||
| DAVIDSON, Paul | Director | Church Street KT13 8DP Weybridge 58 Surrey United Kingdom | United Kingdom | British | 46356560004 | |||||
| HARRIS, Anthony Beauchamp | Director | 1 Norland Road Clifton BS8 3LP Bristol Avon | United Kingdom | British | 10913260001 | |||||
| JONES, Alan | Director | Welling House Skippetts Lane East RG21 3AT Basingstoke Hampshire | British | 18218140002 | ||||||
| PFEIL, John Christopher | Director | 148 High Street ME19 6NE West Malling Kent | England | British | 93412530001 | |||||
| PRIEST, Nicholas | Director | Ashmead House Ashmead Green GL11 5EN Dursley Gloucestershire | England | British | 28134790006 | |||||
| PRIEST, Sarah Elisabeth | Director | Ashmead House Ashmead Green Cam GL11 5EN Dursley Gloucestershire | England | British | 30824790003 | |||||
| ROWLEY, Colin | Director | Meadow Spring Undershore Road Walhampton SO41 5SB Lymington Hampshire | British | 9681300002 | ||||||
| WILLIAMS, Martyn Courtney Bailey | Director | 9 Chadlington Road OX2 6SY Oxford | England | British | 37614850003 | |||||
| SECRETARIAL CO (1996) LIMITED | Director corporativo | Newspaper House Test Lane Redbridge SO16 9JX Southampton Hampshire | 48416440001 |
¿Quiénes son las personas con control significativo de BAILEY NEWSPAPER GROUP LIMITED?
| Nombre | Notificado el | Dirección | Cesado | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Newsquest Media (Southern) Limited | 06 abr 2016 | Station Road Loudwater HP10 9TY High Wycombe Loudwater Mill England | No | ||||||||||
| |||||||||||||
Naturaleza del control
| |||||||||||||
¿Tiene BAILEY NEWSPAPER GROUP LIMITED alguna carga?
| Clasificación | Fechas | Estado | Detalles | |
|---|---|---|---|---|
| Credit agreement | Creado el 15 jul 1993 Entregado el 23 jul 1993 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada £72,146.63 due from the company to the chargee under the terms of the charge | |
Breve descripción All right title and interest in and to all sums payable under the insurance. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
| Guarantee & debenture | Creado el 11 mar 1991 Entregado el 19 mar 1991 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever | |
Breve descripción Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
| Legal charge | Creado el 24 may 1990 Entregado el 04 jun 1990 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Breve descripción Reliance house, long street dursley, gloucestershire. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
| Legal charge | Creado el 06 abr 1987 Entregado el 23 abr 1987 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All monies due or to become due from the company to the chargees under the terms of an agreement dated 6/4/87 | |
Breve descripción F/H property situate at and k/a no 6 lansdowne, stroud gloucestershire. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
| Legal charge | Creado el 06 abr 1987 Entregado el 23 abr 1987 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All monies due or to become due from the company to the chargees under the terms of an agreement dated 6/4/87 | |
Breve descripción F/H land and premises k/a chapel house fronting on to digbeth street, stow-on-the-wold, gloucestershire. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
| Legal mortgage | Creado el 12 ago 1985 Entregado el 20 ago 1985 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Breve descripción F/H reliance house and adjoining land at long street dursley gloucester and or the proceeds of sale. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
Fuente de datos
- Companies House del Reino Unido
El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros. - Licencia: CC0