ICELAND FOODSTORES LIMITED

ICELAND FOODSTORES LIMITED

  • Visión general
  • Resumen
  • Propósito
  • Dirección
  • Nombres anteriores
  • Cuentas
  • Presentaciones
  • Directivos
  • Personas con control significativo
  • Gravámenes
  • Fuente de datos
  • Visión general

    Nombre de la empresaICELAND FOODSTORES LIMITED
    Estado de la empresaDisuelta
    Forma jurídicaSociedad de responsabilidad limitada
    Número de empresa 00917394
    JurisdicciónInglaterra/Gales
    Fecha de constitución
    Fecha de cese

    Resumen

    Tiene PSCs súper segurosNo
    Tiene gravámenes
    Tiene historial de insolvenciaNo
    La sede social está en disputaNo

    ¿Cuál es el propósito de ICELAND FOODSTORES LIMITED?

    • Compañía no comercial (74990) / Actividades profesionales, científicas y técnicas

    ¿Dónde se encuentra ICELAND FOODSTORES LIMITED?

    Dirección de la sede social
    Second Avenue
    Deeside Industrial Park
    CH5 2NW Deeside
    Flintshire
    Dirección de la sede social no entregableNo

    ¿Cuáles fueron los nombres anteriores de ICELAND FOODSTORES LIMITED?

    Nombres anteriores de la empresa
    Nombre de la empresaDesdeHasta
    BEJAM PROPERTIES LIMITED03 sept 198703 sept 1987
    HOME TRADING POST LIMITED31 dic 198131 dic 1981
    BEJAM PRODUCE LIMITED06 oct 196706 oct 1967

    ¿Cuáles son las últimas cuentas de ICELAND FOODSTORES LIMITED?

    Últimas cuentas
    Últimas cuentas cerradas hasta24 mar 2017

    ¿Cuáles son las últimas presentaciones para ICELAND FOODSTORES LIMITED?

    Presentaciones
    FechaDescripciónDocumentoTipo

    Boletín oficial final disuelto por cancelación voluntaria

    1 páginasGAZ2(A)

    Primer aviso en el boletín oficial para la cancelación voluntaria

    1 páginasGAZ1(A)

    Solicitud de exclusión de la empresa del registro

    3 páginasDS01

    Declaración de confirmación presentada el 24 may 2018 sin actualizaciones

    3 páginasCS01

    Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 24 mar 2017

    6 páginasAA

    Declaración de confirmación presentada el 24 may 2017 con actualizaciones

    5 páginasCS01

    Cuentas completas preparadas hasta el 25 mar 2016

    15 páginasAA

    Déclaration annuelle établie au 24 may 2016 avec liste complète des actionnaires

    4 páginasAR01
    Presentaciones asociadas
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    capital15 jun 2016

    Estado de capital el 15 jun 2016

    • Capital: GBP 1
    SH01

    Cambio de datos del director Mr Duncan Andrew Vaughan el 16 abr 2016

    2 páginasCH01

    Cuentas completas preparadas hasta el 27 mar 2015

    11 páginasAA

    Déclaration annuelle établie au 24 may 2015 avec liste complète des actionnaires

    4 páginasAR01
    Presentaciones asociadas
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    capital17 jun 2015

    Estado de capital el 17 jun 2015

    • Capital: GBP 1
    SH01

    legacy

    1 páginasSH20

    Estado de capital el 23 dic 2014

    • Capital: GBP 1
    4 páginasSH19

    legacy

    1 páginasCAP-SS

    Resoluciones

    Resolutions
    RESOLUTIONS
    Acuerdos
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    capital

    Resolución de reducción del capital social emitido

    RES06

    Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 28 mar 2014

    7 páginasAA

    Cese del nombramiento de Jayne Katherine Burrell como secretario el 12 dic 2014

    1 páginasTM02

    Nombramiento de Mr Duncan Andrew Vaughan como secretario el 12 dic 2014

    2 páginasAP03

    Nombramiento de Mr Duncan Andrew Vaughan como director el 12 dic 2014

    2 páginasAP01

    Cese del nombramiento de Jayne Katherine Burrell como director el 12 dic 2014

    1 páginasTM01

    Cancelación total de la carga 4

    4 páginasMR04

    Déclaration annuelle établie au 24 may 2014 avec liste complète des actionnaires

    4 páginasAR01
    Presentaciones asociadas
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    capital18 jun 2014

    Estado de capital el 18 jun 2014

    • Capital: GBP 5,005,000
    SH01

    Déclaration annuelle établie au 24 may 2013 avec liste complète des actionnaires

    4 páginasAR01

    Cuentas completas preparadas hasta el 29 mar 2013

    12 páginasAA

    Cuentas completas preparadas hasta el 30 mar 2012

    12 páginasAA

    ¿Quiénes son los directivos de ICELAND FOODSTORES LIMITED?

    Directivos
    NombreNombrado elRenunció elRolDirecciónIdentificación de la empresaPaís de residenciaNacionalidadFecha de nacimientoOcupaciónNúmero
    VAUGHAN, Duncan Andrew
    Deeside Industrial Park
    CH5 2NW Deeside
    Second Avenue
    Flintshire
    Secretario
    Deeside Industrial Park
    CH5 2NW Deeside
    Second Avenue
    Flintshire
    193427820001
    DHALIWAL, Tarsem Singh
    Deeside Industrial Park
    CH5 2NW Deeside
    Second Avenue
    Flintshire
    Director
    Deeside Industrial Park
    CH5 2NW Deeside
    Second Avenue
    Flintshire
    United KingdomBritish151680990001
    VAUGHAN, Duncan Andrew
    Deeside Industrial Park
    CH5 2NW Deeside
    Second Avenue
    Flintshire
    Director
    Deeside Industrial Park
    CH5 2NW Deeside
    Second Avenue
    Flintshire
    United KingdomBritish132416950002
    BERRY, John Graham
    The Poplars Darland Lane Lavister
    Rossett
    LL12 0BA Wrexham
    Secretario
    The Poplars Darland Lane Lavister
    Rossett
    LL12 0BA Wrexham
    British10711650001
    BERRY, John Graham
    The Poplars Darland Lane Lavister
    Rossett
    LL12 0BA Wrexham
    Secretario
    The Poplars Darland Lane Lavister
    Rossett
    LL12 0BA Wrexham
    British10711650001
    BURRELL, Jayne Katherine
    Deeside Industrial Park
    CH5 2NW Deeside
    Second Avenue
    Flintshire
    Secretario
    Deeside Industrial Park
    CH5 2NW Deeside
    Second Avenue
    Flintshire
    159123960001
    CHASE, Suzanne Gabrielle
    Linden Gardens
    Chiswick
    W4 2EW London
    68
    United Kingdom
    Secretario
    Linden Gardens
    Chiswick
    W4 2EW London
    68
    United Kingdom
    British135246350001
    SIGURDSSON, Gunnar
    4 Greenlink Walk
    Kew Riverside
    TW9 4AF Richmond Upon Thames
    London
    Secretario
    4 Greenlink Walk
    Kew Riverside
    TW9 4AF Richmond Upon Thames
    London
    Icelandic114179720001
    BERRY, John Graham
    The Poplars Darland Lane Lavister
    Rossett
    LL12 0BA Wrexham
    Director
    The Poplars Darland Lane Lavister
    Rossett
    LL12 0BA Wrexham
    WalesBritish10711650001
    BOOKER, Paul
    3 Suffolk Close
    BH21 2TX Wimborne
    Dorset
    Director
    3 Suffolk Close
    BH21 2TX Wimborne
    Dorset
    British50732080001
    BROWN, David Charles
    Portal Lodge Forest Road
    CW6 0HX Tarporley
    Cheshire
    Director
    Portal Lodge Forest Road
    CW6 0HX Tarporley
    Cheshire
    British39013930002
    BURRELL, Jayne Katherine
    Deeside Industrial Park
    CH5 2NW Deeside
    Second Avenue
    Flintshire
    Director
    Deeside Industrial Park
    CH5 2NW Deeside
    Second Avenue
    Flintshire
    EnglandBritish167879930001
    CHASE, Suzanne Gabrielle
    Linden Gardens
    Chiswick
    W4 2EW London
    68
    United Kingdom
    Director
    Linden Gardens
    Chiswick
    W4 2EW London
    68
    United Kingdom
    United KingdomBritish135246350001
    CLARKE, Andrew James
    Old Rectory
    High Street Whitwell
    S80 4RE Nottingham
    Director
    Old Rectory
    High Street Whitwell
    S80 4RE Nottingham
    United KingdomBritish141323810001
    COUPE, Michael Andrew
    Riverside The Terrace
    LS23 6AH Boston Spa
    West Yorkshire
    Director
    Riverside The Terrace
    LS23 6AH Boston Spa
    West Yorkshire
    British59022790001
    DHALIWAL, Tarsem Singh
    6 Cumbrae Drive
    Stanney Oaks
    CH65 9JX Ellesmere Port
    Cheshire
    Director
    6 Cumbrae Drive
    Stanney Oaks
    CH65 9JX Ellesmere Port
    Cheshire
    United KingdomBritish112657600001
    EVANS, Dennis
    21 Bickerton Way
    CW9 8FZ Northwich
    Cheshire
    Director
    21 Bickerton Way
    CW9 8FZ Northwich
    Cheshire
    British74051840001
    HARALDSSON, Palmi
    Solvallargata 4
    FOREIGN 101 Reykjavik
    Iceland
    Director
    Solvallargata 4
    FOREIGN 101 Reykjavik
    Iceland
    IcelandIcelandic98086060001
    HARRIS, Nicholas Edward
    10 Primrose Road
    Allerton
    L18 2HE Liverpool
    Director
    10 Primrose Road
    Allerton
    L18 2HE Liverpool
    British74483900001
    HOSKINS, William John
    3 Homewood Road
    AL1 4BE St. Albans
    Hertfordshire
    Director
    3 Homewood Road
    AL1 4BE St. Albans
    Hertfordshire
    British49295070002
    KNOX, Kevin Douglas
    3 Periwinkle Close
    Lindford
    GU35 0YQ Bordon
    Hampshire
    Director
    3 Periwinkle Close
    Lindford
    GU35 0YQ Bordon
    Hampshire
    British96370150001
    LEIGH, James Bernard
    22 Curzon Park North
    CH4 8AR Chester
    Cheshire
    Director
    22 Curzon Park North
    CH4 8AR Chester
    Cheshire
    British76713530001
    LEIGH, James Bernard
    22 Curzon Park North
    CH4 8AR Chester
    Cheshire
    Director
    22 Curzon Park North
    CH4 8AR Chester
    Cheshire
    British76713530001
    PRITCHARD, Andrew Simon
    Deeside Industrial Park
    CH5 2NW Deeside
    Second Avenue
    Flintshire
    Director
    Deeside Industrial Park
    CH5 2NW Deeside
    Second Avenue
    Flintshire
    United KingdomBritish42467790003
    PRITCHARD, Andrew Simon
    Kidnal Grange
    Kidnal
    SY14 7DJ Malpas
    Cheshire
    Director
    Kidnal Grange
    Kidnal
    SY14 7DJ Malpas
    Cheshire
    United KingdomBritish42467790003
    SIGURDSSON, Gunnar
    4 Greenlink Walk
    Kew Riverside
    TW9 4AF Richmond Upon Thames
    London
    Director
    4 Greenlink Walk
    Kew Riverside
    TW9 4AF Richmond Upon Thames
    London
    EnglandIcelandic114179720001
    WALKER, Malcolm Conrad, Sir
    Broxton Old Hall
    Broxton
    CH5 9EF Chester
    Cheshire
    Director
    Broxton Old Hall
    Broxton
    CH5 9EF Chester
    Cheshire
    United KingdomBritish,161541770001

    ¿Quiénes son las personas con control significativo de ICELAND FOODSTORES LIMITED?

    Personas con control significativo
    NombreNotificado elDirecciónCesado
    Iceland Midco Limited
    Deeside Industrial Parl
    Deeside
    CH5 2NW Flintshire
    Second Avenue
    United Kingdom
    06 abr 2016
    Deeside Industrial Parl
    Deeside
    CH5 2NW Flintshire
    Second Avenue
    United Kingdom
    No
    Forma jurídicaPrivate Company Limited By Shares
    Autoridad legalCompanies Act 2006
    Naturaleza del control
    • La persona posee, directa o indirectamente, más del 75% de las acciones de la compañía.
    • La persona posee, directa o indirectamente, más del 75% de los derechos de voto en la empresa.
    • La persona tiene el derecho, directa o indirectamente, de nombrar o destituir a la mayoría de la junta directiva de la empresa.

    ¿Tiene ICELAND FOODSTORES LIMITED alguna carga?

    Gravámenes
    ClasificaciónFechasEstadoDetalles
    Debenture
    Creado el 05 abr 2012
    Entregado el 13 abr 2012
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company or any member of the group to the chargee or any of the other secured parties on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descripción
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Personas con derecho
    • The Royal Bank of Scotland PLC (As Security Agent)
    Transacciones
    • 13 abr 2012Registro de un cargo (MG01)
    • 22 jul 2014Satisfacción de una carga (MR04)
    A deed of accession
    Creado el 11 abr 2007
    Entregado el 26 abr 2007
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee and/or the other security beneficiaries (or any of them) on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descripción
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • Deutsche Bank Ag London Branch (The Security Trustee)
    Transacciones
    • 26 abr 2007Registro de un cargo (395)
    • 15 abr 2010Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (MG02)
    Deed of accession
    Creado el 31 mar 2006
    Entregado el 13 abr 2006
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee and/or the other security beneficiaries (or any of them) on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descripción
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • Landsbanki Islands Hf (The Security Trustee)
    Transacciones
    • 13 abr 2006Registro de un cargo (395)
    • 12 jun 2007Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    An accession deed
    Creado el 23 ago 2005
    Entregado el 01 sept 2005
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the security trustee and or the other security beneficiaries (or any of them) on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descripción
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • Landsbanki Islands Hf (The Security Trustee)
    Transacciones
    • 01 sept 2005Registro de un cargo (395)
    • 16 mar 2007Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)

    Fuente de datos

    • Companies House del Reino Unido
      El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros.
    • Licencia: CC0