AAH RETAIL PHARMACY LIMITED

AAH RETAIL PHARMACY LIMITED

  • Visión general
  • Resumen
  • Propósito
  • Dirección
  • Nombres anteriores
  • Cuentas
  • Presentaciones
  • Directivos
  • Personas con control significativo
  • Gravámenes
  • Fuente de datos
  • Visión general

    Nombre de la empresaAAH RETAIL PHARMACY LIMITED
    Estado de la empresaDisuelta
    Forma jurídicaSociedad de responsabilidad limitada
    Número de empresa 00917620
    JurisdicciónInglaterra/Gales
    Fecha de constitución
    Fecha de cese

    Resumen

    Tiene PSCs súper segurosNo
    Tiene gravámenes
    Tiene historial de insolvenciaNo
    La sede social está en disputaNo

    ¿Cuál es el propósito de AAH RETAIL PHARMACY LIMITED?

    • Compañía no comercial (74990) / Actividades profesionales, científicas y técnicas

    ¿Dónde se encuentra AAH RETAIL PHARMACY LIMITED?

    Dirección de la sede social
    Sapphire Court
    Walsgrave Triangle
    CV2 2TX Coventry
    Dirección de la sede social no entregableNo

    ¿Cuáles fueron los nombres anteriores de AAH RETAIL PHARMACY LIMITED?

    Nombres anteriores de la empresa
    Nombre de la empresaDesdeHasta
    LLOYDS PHARMACY LIMITED30 ene 199830 ene 1998
    ELLIOTTS PHARMACY LIMITED09 oct 196709 oct 1967

    ¿Cuáles son las últimas cuentas de AAH RETAIL PHARMACY LIMITED?

    Últimas cuentas
    Últimas cuentas cerradas hasta31 mar 2016

    ¿Cuáles son las últimas presentaciones para AAH RETAIL PHARMACY LIMITED?

    Presentaciones
    FechaDescripciónDocumentoTipo

    Boletín oficial final disuelto por cancelación voluntaria

    1 páginasGAZ2(A)

    La acción de exclusión voluntaria ha sido suspendida

    1 páginasSOAS(A)

    Primer aviso en el boletín oficial para la cancelación voluntaria

    1 páginasGAZ1(A)

    Solicitud de exclusión de la empresa del registro

    3 páginasDS01

    Declaración de confirmación presentada el 03 feb 2017 con actualizaciones

    6 páginasCS01

    Nombramiento de Hanns Martin Lipp como director el 21 dic 2016

    2 páginasAP01

    Cese del nombramiento de Thorsten Beer como director el 21 dic 2016

    1 páginasTM01

    Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 31 mar 2016

    3 páginasAA

    Déclaration annuelle établie au 01 feb 2016 avec liste complète des actionnaires

    4 páginasAR01
    Presentaciones asociadas
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    capital03 feb 2016

    Estado de capital el 03 feb 2016

    • Capital: GBP 1,550
    SH01

    Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 31 mar 2015

    3 páginasAA

    Déclaration annuelle établie au 01 feb 2015 avec liste complète des actionnaires

    4 páginasAR01
    Presentaciones asociadas
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    capital04 feb 2015

    Estado de capital el 04 feb 2015

    • Capital: GBP 1,550
    SH01

    Exercice comptable en cours prolongé du 31 dic 2014 au 31 mar 2015

    1 páginasAA01

    Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 31 dic 2013

    3 páginasAA

    Cancelación total de la carga 20

    4 páginasMR04

    Déclaration annuelle établie au 01 feb 2014 avec liste complète des actionnaires

    4 páginasAR01
    Presentaciones asociadas
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    capital18 mar 2014

    Estado de capital el 18 mar 2014

    • Capital: GBP 1,550
    SH01

    Nombramiento de Mrs Wendy Margaret Hall como director

    2 páginasAP01

    Cese del nombramiento de William Shepherd como director

    1 páginasTM01

    Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 31 dic 2012

    3 páginasAA

    Déclaration annuelle établie au 01 feb 2013 avec liste complète des actionnaires

    4 páginasAR01

    Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 31 dic 2011

    3 páginasAA

    Nombramiento de Mr Thorsten Beer como director

    2 páginasAP01

    Cese del nombramiento de Andrew Willetts como director

    1 páginasTM01

    Nombramiento de Mrs Nichola Louise Legg como secretario

    1 páginasAP03

    Cese del nombramiento de Jennifer Brierley como secretario

    1 páginasTM02

    Déclaration annuelle établie au 01 feb 2012 avec liste complète des actionnaires

    3 páginasAR01

    ¿Quiénes son los directivos de AAH RETAIL PHARMACY LIMITED?

    Directivos
    NombreNombrado elRenunció elRolDirecciónIdentificación de la empresaPaís de residenciaNacionalidadFecha de nacimientoOcupaciónNúmero
    LEGG, Nichola Louise
    Sapphire Court
    Walsgrave Triangle
    CV2 2TX Coventry
    Secretario
    Sapphire Court
    Walsgrave Triangle
    CV2 2TX Coventry
    163214890001
    HALL, Wendy Margaret
    Sapphire Court
    Walsgrave Triangle
    CV2 2TX Coventry
    Director
    Sapphire Court
    Walsgrave Triangle
    CV2 2TX Coventry
    EnglandBritishSolicitor172979860001
    LIPP, Hanns Martin
    Sapphire Court
    Walsgrave Triangle
    CV2 2TX Coventry
    Director
    Sapphire Court
    Walsgrave Triangle
    CV2 2TX Coventry
    United KingdomGermanFinance Director220582440001
    BRIERLEY, Jennifer Anne
    Sapphire Court
    Walsgrave Triangle
    CV2 2TX Coventry
    Sapphire Court
    England
    Secretario
    Sapphire Court
    Walsgrave Triangle
    CV2 2TX Coventry
    Sapphire Court
    England
    British118563210001
    DAVIES, John Richard Bridge
    Amberley
    5 Primrose Hill Waste Lane
    CW6 0PE Kelsall
    Cheshire
    Secretario
    Amberley
    5 Primrose Hill Waste Lane
    CW6 0PE Kelsall
    Cheshire
    British51554100001
    HEATON, Janet Ruth
    7 Hunters Row
    Portland Street
    LE9 1TQ Cosby
    Leicestershire
    Secretario
    7 Hunters Row
    Portland Street
    LE9 1TQ Cosby
    Leicestershire
    British81228260001
    MORDE, Diane
    6 Karen Drive
    Backwell
    BS19 3JT Bristol
    Avon
    Secretario
    6 Karen Drive
    Backwell
    BS19 3JT Bristol
    Avon
    BritishPersonal Assistant8059410001
    MURPHY, Francis Joseph
    Oakmere Murieston Road
    WA15 9SU Hale
    Cheshire
    Secretario
    Oakmere Murieston Road
    WA15 9SU Hale
    Cheshire
    British32866430003
    SMERDON, Peter
    40 Stoneton Crescent
    Balsall Common
    CV7 7QG Coventry
    Warwickshire
    Secretario
    40 Stoneton Crescent
    Balsall Common
    CV7 7QG Coventry
    Warwickshire
    British16898700002
    STEWART, Brian
    12 Fulwell Park Avenue
    TW2 5HQ Twickenham
    Middlesex
    Secretario
    12 Fulwell Park Avenue
    TW2 5HQ Twickenham
    Middlesex
    BritishAccountant980530001
    BEER, Thorsten
    Sapphire Court
    Walsgrave Triangle
    CV2 2TX Coventry
    Director
    Sapphire Court
    Walsgrave Triangle
    CV2 2TX Coventry
    United KingdomGermanCfo172030260001
    ENGLAND, Philip Nicholas
    5 Park Avenue
    Peper Harrow Park
    GU8 6BA Godalming
    Surrey
    Director
    5 Park Avenue
    Peper Harrow Park
    GU8 6BA Godalming
    Surrey
    BritishMarketing Director43835770003
    GREENHALGH, Gary
    Washdyke Farm
    Lincoln Road
    NG32 3HY Fulbeck
    Lincolnshire
    Director
    Washdyke Farm
    Lincoln Road
    NG32 3HY Fulbeck
    Lincolnshire
    United KingdomBritishCompany Director1192810001
    HOOD, John
    27 Medina House, Diglis Dock Road
    WR5 3DD Worcester
    Director
    27 Medina House, Diglis Dock Road
    WR5 3DD Worcester
    BritishFinance Director39644740002
    KERSHAW, Graham Anthony
    Selsley House
    Westhorpe
    LE16 9UL Sibbertoft
    Leicestershire
    Director
    Selsley House
    Westhorpe
    LE16 9UL Sibbertoft
    Leicestershire
    United KingdomBritishDirector8991780003
    MAJOR, Michael Evelyn
    1 Frobisher Gardens
    GU1 2NT Guildford
    Surrey
    Director
    1 Frobisher Gardens
    GU1 2NT Guildford
    Surrey
    BritishBusiness Development Dir31230890001
    MEISTER, Stefan Mario
    Rosengartenstrasse 19
    70184 Stuttgart
    Germany
    Director
    Rosengartenstrasse 19
    70184 Stuttgart
    Germany
    SwissCompany Director43550520003
    MISCHKE, Gerhard Viktor
    Whitehill Farmhouse
    Alderminster
    CV37 8BW Stratford Upon Avon
    Warwickshire
    Director
    Whitehill Farmhouse
    Alderminster
    CV37 8BW Stratford Upon Avon
    Warwickshire
    GermanyChief Finance Officer62107000001
    ORME, Allan Cameron
    Cornerstones Lime Walk
    Dibden Purlieu
    SO4 5RB Southampton
    Hampshire
    Director
    Cornerstones Lime Walk
    Dibden Purlieu
    SO4 5RB Southampton
    Hampshire
    BritishManaging Director1271730001
    ROTHERY, Brian Hilton
    12 Eaves Brow Road
    Croft
    WA3 7LF Warrington
    Cheshire
    Director
    12 Eaves Brow Road
    Croft
    WA3 7LF Warrington
    Cheshire
    BritishPharmacist12851670001
    SHEPHERD, William
    Walsgrave Triangle
    CV2 2TX Coventry
    Sapphire Court
    England
    Director
    Walsgrave Triangle
    CV2 2TX Coventry
    Sapphire Court
    England
    Great BritainBritishSolicitor162873980001
    SMERDON, Peter
    Walsgrave Triangle
    CV2 2TX Coventry
    Sapphire Court
    England
    Director
    Walsgrave Triangle
    CV2 2TX Coventry
    Sapphire Court
    England
    EnglandBritishCompany Secretary16898700002
    STEWART, Brian
    12 Fulwell Park Avenue
    TW2 5HQ Twickenham
    Middlesex
    Director
    12 Fulwell Park Avenue
    TW2 5HQ Twickenham
    Middlesex
    EnglandBritishFinance Director980530001
    TAYLOR, David Leslie
    Woodbank Wilmslow Park
    SK9 2BA Wilmslow
    Cheshire
    Director
    Woodbank Wilmslow Park
    SK9 2BA Wilmslow
    Cheshire
    Gb-EngBritishPharmacist10776940001
    VIZARD, Ronald Charles, Harold
    Fieldfare
    Pigeon Green, Snitterfield
    CV37 OLP Stratford-Upon-Avon
    Warwickshire
    Director
    Fieldfare
    Pigeon Green, Snitterfield
    CV37 OLP Stratford-Upon-Avon
    Warwickshire
    BritishChartered Accountant122881190001
    WICKS, David Frederick
    8 Gloucester Drive
    Kempshott Rise
    RG22 4PH Basingstoke
    Hampshire
    Director
    8 Gloucester Drive
    Kempshott Rise
    RG22 4PH Basingstoke
    Hampshire
    BritishDirector1257240001
    WILLETTS, Andrew John
    Walsgrave Triangle
    CV2 2TX Coventry
    Sapphire Court
    England
    Director
    Walsgrave Triangle
    CV2 2TX Coventry
    Sapphire Court
    England
    EnglandBritishChartered Accountant120451550002

    ¿Quiénes son las personas con control significativo de AAH RETAIL PHARMACY LIMITED?

    Personas con control significativo
    NombreNotificado elDirecciónCesado
    Walsgrave Triangle
    CV2 2TX Coventry
    Sapphire Court
    England
    06 abr 2016
    Walsgrave Triangle
    CV2 2TX Coventry
    Sapphire Court
    England
    No
    Forma jurídicaPrivate Company Limited By Shares
    País de registroGreat Britain
    Autoridad legalCompanies Act 1985
    Lugar de registroCompanies House
    Número de registro244282
    Naturaleza del control
    • La persona tiene derecho a ejercer, o ejerce efectivamente, una influencia o control significativo sobre las actividades de una sociedad civil que, según la ley que la rige, no es una persona jurídica; y los miembros de esa sociedad civil (en esa calidad) poseen, directamente o indirectamente, más del 75% de las acciones de la compañía.

    ¿Tiene AAH RETAIL PHARMACY LIMITED alguna carga?

    Gravámenes
    ClasificaciónFechasEstadoDetalles
    Legal charge
    Creado el 20 dic 1989
    Entregado el 09 ene 1990
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    152 bell hill road st. George, bristol avon, title no av 58555.
    Personas con derecho
    • Barclays Bank PLC
    Transacciones
    • 09 ene 1990Registro de una carga
    • 17 sept 2014Satisfacción de una carga (MR04)
    Legal charge
    Creado el 23 jun 1988
    Entregado el 04 jul 1988
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    103 st. Marks road, easton bristol avon, tn bl 22853.
    Personas con derecho
    • Barclays Bank PLC
    Transacciones
    • 04 jul 1988Registro de una carga
    • 06 nov 1998Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Legal charge
    Creado el 23 jun 1988
    Entregado el 04 jul 1988
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    182 gloucester road bristol, avon, tn. Av 52666.
    Personas con derecho
    • Barclays Bank PLC
    Transacciones
    • 04 jul 1988Registro de una carga
    • 06 nov 1998Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Legal charge
    Creado el 20 may 1988
    Entregado el 27 may 1988
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    58 whiteladies road cilfton, bristol, avon.
    Personas con derecho
    • Barclays Bank PLC
    Transacciones
    • 27 may 1988Registro de una carga
    • 06 nov 1998Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Legal charge
    Creado el 20 may 1988
    Entregado el 27 may 1988
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    308 wells road, knowle bristol, avon.
    Personas con derecho
    • Barclays Bank PLC
    Transacciones
    • 27 may 1988Registro de una carga
    • 06 nov 1998Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Legal charge
    Creado el 20 may 1988
    Entregado el 27 may 1988
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    Arch house, victoria square, bristol, avon.
    Personas con derecho
    • Barclays Bank PLC
    Transacciones
    • 27 may 1988Registro de una carga
    • 06 nov 1998Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Legal charge
    Creado el 20 may 1988
    Entregado el 27 may 1988
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    62 ridingleaze, lawrence weston, bristol, avon.
    Personas con derecho
    • Barclays Bank PLC
    Transacciones
    • 27 may 1988Registro de una carga
    • 06 nov 1998Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Legal charge
    Creado el 20 may 1988
    Entregado el 27 may 1988
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    20 north street, bedminster, bristol, avon.
    Personas con derecho
    • Barclays Bank PLC
    Transacciones
    • 27 may 1988Registro de una carga
    • 06 nov 1998Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Debenture
    Creado el 08 abr 1988
    Entregado el 20 abr 1988
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    (Including trade fixtures). Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personas con derecho
    • Barclays Bank PLC
    Transacciones
    • 20 abr 1988Registro de una carga
    • 06 nov 1998Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Legal mortgage
    Creado el 07 ago 1987
    Entregado el 20 ago 1987
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    182 gloucester road horfield bristol title no av 52666 and the proceeds of sale thereof.. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Personas con derecho
    • National Westminster Bank PLC
    Transacciones
    • 20 ago 1987Registro de una carga
    Legal charge
    Creado el 25 sept 1986
    Entregado el 08 oct 1986
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    "Wendover" 112 weston road long ashton, bristol.
    Personas con derecho
    • Barclays Bank PLC
    Transacciones
    • 08 oct 1986Registro de una carga
    • 06 nov 1998Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Mortgage debenture
    Creado el 04 abr 1985
    Entregado el 17 abr 1985
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    A specific equitable charge on the companys f/h & l/h property and or the proceeds of sale fixed and floating charge over undertaking and all property and assets present and future including bookdebts goodwill uncalled capital.
    Personas con derecho
    • National Westminster Bank PLC
    Transacciones
    • 17 abr 1985Registro de una carga
    Legal mortgage
    Creado el 24 ene 1983
    Entregado el 31 ene 1983
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    L/H 58 whiteladies road clifton, bristol and/or the proceeds of sale thereof. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Personas con derecho
    • National Westminster Bank PLC
    Transacciones
    • 31 ene 1983Registro de una carga
    Legal mortgage
    Creado el 10 may 1982
    Entregado el 13 may 1982
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    L/H property known as ground floor shop 20 north street bedminster bristol. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Personas con derecho
    • National Westminster Bank PLC
    Transacciones
    • 13 may 1982Registro de una carga
    Legal mortgage
    Creado el 12 mar 1981
    Entregado el 17 mar 1981
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    L/H 308 wells road, knowle, bristol.. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Personas con derecho
    • National Westminster Bank PLC
    Transacciones
    • 17 mar 1981Registro de una carga
    Legal mortgage
    Creado el 22 dic 1980
    Entregado el 30 dic 1980
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    L/H 62 ridingleaze lawrence weston bristol. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Personas con derecho
    • National Westminster Bank PLC
    Transacciones
    • 30 dic 1980Registro de una carga
    Legal mortgage
    Creado el 23 may 1980
    Entregado el 29 may 1980
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    L/H arch house, boyce avenue clifton bristol. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Personas con derecho
    • National Westminster Bank PLC
    Transacciones
    • 29 may 1980Registro de una carga
    Legal mortgage
    Creado el 23 may 1980
    Entregado el 29 may 1980
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    L/H ground floor shop 20 north street bedminster bristol. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Personas con derecho
    • National Westminster Bank PLC
    Transacciones
    • 29 may 1980Registro de una carga
    Legal mortgage
    Creado el 23 may 1980
    Entregado el 29 may 1980
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    L/H 58 whiteladies rd clifton bristol. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Personas con derecho
    • National Westminster Bank PLC
    Transacciones
    • 29 may 1980Registro de una carga
    Assignment
    Creado el 20 jun 1978
    Entregado el 06 jul 1978
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    All payments now due or to become due & payable to elliotts pharmacy LTD by the N.H.S. executive council for avon braches at :- 20 north st., Bedminster bristol. 95 east dundry rd. Whitchurch bristol. 103 st. Marks rd bristol. The arch pharmacy, victoria sq. Bristol. & 58 whiteladies rd., Clifton bristol.
    Personas con derecho
    • Vestric Limited
    Transacciones
    • 06 jul 1978Registro de una carga
    • 06 nov 1998Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)

    Fuente de datos

    • Companies House del Reino Unido
      El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros.
    • Licencia: CC0