LOGICAL COMMERCE LIMITED
Visión general
| Nombre de la empresa | LOGICAL COMMERCE LIMITED |
|---|---|
| Estado de la empresa | Disuelta |
| Forma jurídica | Sociedad de responsabilidad limitada |
| Número de empresa | 00919643 |
| Jurisdicción | Inglaterra/Gales |
| Fecha de constitución | |
| Fecha de cese |
Resumen
| Tiene PSCs súper seguros | No |
|---|---|
| Tiene gravámenes | Sí |
| Tiene historial de insolvencia | Sí |
| La sede social está en disputa | No |
¿Cuál es el propósito de LOGICAL COMMERCE LIMITED?
- Compañía no comercial (74990) / Actividades profesionales, científicas y técnicas
¿Dónde se encuentra LOGICAL COMMERCE LIMITED?
| Dirección de la sede social | 30 Finsbury Square EC2P 2YU London |
|---|---|
| Dirección de la sede social no entregable | No |
¿Cuáles fueron los nombres anteriores de LOGICAL COMMERCE LIMITED?
| Nombre de la empresa | Desde | Hasta |
|---|---|---|
| DIAMOND PLATFORMS LIMITED | 08 nov 1995 | 08 nov 1995 |
| EXETER HIRE CENTRE LIMITED | 25 oct 1967 | 25 oct 1967 |
¿Cuáles son las últimas cuentas de LOGICAL COMMERCE LIMITED?
| Últimas cuentas | |
|---|---|
| Últimas cuentas cerradas hasta | 31 dic 2017 |
¿Cuáles son las últimas presentaciones para LOGICAL COMMERCE LIMITED?
| Fecha | Descripción | Documento | Tipo | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gaceta final disuelta tras la liquidación | 1 páginas | GAZ2 | ||||||||||
Devolución de la reunión final en una liquidación voluntaria de miembros | 8 páginas | LIQ13 | ||||||||||
Cese del nombramiento de Jerome Sarragozi como secretario el 30 abr 2019 | 1 páginas | TM02 | ||||||||||
Domicilio social registrado cambiado de 15 Midland Court Central Park Lutterworth Leicestershire LE17 4PN England a 30 Finsbury Square London EC2P 2YU el 25 ene 2019 | 2 páginas | AD01 | ||||||||||
Declaración de solvencia | 5 páginas | LIQ01 | ||||||||||
Nombramiento de un liquidador voluntario | 4 páginas | 600 | ||||||||||
Resoluciones Resolutions | 1 páginas | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Declaración de confirmación presentada el 05 dic 2018 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||||||||||
Cuentas completas preparadas hasta el 31 dic 2017 | 16 páginas | AA | ||||||||||
Declaración de confirmación presentada el 02 dic 2017 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||||||||||
Nombramiento de Mr Jerome Sarragozi como secretario el 28 jul 2017 | 2 páginas | AP03 | ||||||||||
Cese del nombramiento de Richard Andrew Cole como secretario el 28 jul 2017 | 1 páginas | TM02 | ||||||||||
Cambio de datos del director Mr Donald Thomas Kenny el 24 jul 2017 | 2 páginas | CH01 | ||||||||||
Cuentas completas preparadas hasta el 31 dic 2016 | 16 páginas | AA | ||||||||||
Nombramiento de Mr Thomas Anthony Murray como director el 01 jul 2017 | 2 páginas | AP01 | ||||||||||
Cese del nombramiento de Alan Stuart Merrell como director el 30 jun 2017 | 1 páginas | TM01 | ||||||||||
Cancelación total de la carga 13 | 1 páginas | MR04 | ||||||||||
Cese del nombramiento de Jeremy Peter Fish como director el 28 feb 2017 | 1 páginas | TM01 | ||||||||||
Declaración de confirmación presentada el 02 dic 2016 con actualizaciones | 5 páginas | CS01 | ||||||||||
Renuncia del auditor | 1 páginas | AUD | ||||||||||
Domicilio social registrado cambiado de 145-157 st. John Street London EC1V 4PY a 15 Midland Court Central Park Lutterworth Leicestershire LE17 4PN el 31 ago 2016 | 1 páginas | AD01 | ||||||||||
Cuentas completas preparadas hasta el 31 dic 2015 | 17 páginas | AA | ||||||||||
Cese del nombramiento de Alan Stuart Merrell como secretario el 07 abr 2016 | 1 páginas | TM02 | ||||||||||
Nombramiento de Richard Andrew Cole como secretario el 07 abr 2016 | 2 páginas | AP03 | ||||||||||
Déclaration annuelle établie au 02 dic 2015 avec liste complète des actionnaires | 5 páginas | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
¿Quiénes son los directivos de LOGICAL COMMERCE LIMITED?
| Nombre | Nombrado el | Renunció el | Rol | Dirección | Identificación de la empresa | País de residencia | Nacionalidad | Fecha de nacimiento | Ocupación | Número |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KENNY, Thomas Donald | Director | Central Park LE17 4PN Lutterworth 15 Midland Court Leicestershire England | England | Irish | 165677760002 | |||||
| MURRAY, Thomas Anthony | Director | Finsbury Square EC2P 2YU London 30 | England | British | 198214500001 | |||||
| COLE, Richard Andrew | Secretario | Central Park LE17 4PN Lutterworth 15 Midland Court Leicestershire England | 207374600001 | |||||||
| FRANKLIN, Karen Jane | Secretario | 189 Marldon Road TQ3 3NB Paignton Devon | British | 24926760001 | ||||||
| HILL, Percy James Hannaford | Secretario | 65 Southfield Avenue TQ3 1LQ Paignton Devon | British | 34368290001 | ||||||
| MERRELL, Alan Stuart | Secretario | Midland Court Central Park LE17 4PN Lutterworth 15 Leicestershire England | British | 59110640004 | ||||||
| SARRAGOZI, Jerome | Secretario | Finsbury Square EC2P 2YU London 30 | 236102320001 | |||||||
| SHIPMAN, David Cyril | Secretario | Church Farm Church Lane DE7 6DE Morley Derbyshire | British | 77501360001 | ||||||
| APPLETON, Kevin Andrew | Director | Midland Court Central Park LE17 4PN Lutterworth 15 Leicestershire England | England | British | 67821450016 | |||||
| BAKER, Austin Philip | Director | 4 Meadowcroft Drive Kingsteignton TQ12 3PB Newton Abbot Devon | British | 44426070001 | ||||||
| FISH, Jeremy Peter | Director | Central Park LE17 4PN Lutterworth 15 Midland Court Leicestershire England | England | British | 160373640001 | |||||
| FRANKLIN, Karen Jane | Director | 189 Marldon Road TQ3 3NB Paignton Devon | British | 24926760001 | ||||||
| GANSSER-POTTS, Michael David | Director | Central Park LE17 4PN Lutterworth 15 Midland Court Leicestershire | England | British | 158445070001 | |||||
| GESTETNER, Geoffrey Sigmund | Director | Flat 5 160 Gloucester Terrace W2 6HR London | British | 47136960001 | ||||||
| MCMEEKING, Robert John | Director | Midland Court Central Park LE17 4PN Lutterworth 15 Leicestershire England | United Kingdom | British | 75448720003 | |||||
| MERRELL, Alan Stuart | Director | Midland Court Central Park LE17 4PN Lutterworth 15 Leicestershire England | United Kingdom | British | 59110640004 | |||||
| PRICE, David Lawrence | Director | Brook Farm Luddington In Th Brook PE28 0HB Oundle Northamptonshire | British | 25187800003 | ||||||
| SHIPMAN, David Cyril | Director | Church Farm Church Lane DE7 6DE Morley Derbyshire | British | 77501360001 | ||||||
| TANNER, Cecilia Kathleen Bessie | Director | Three Tors Higher Cadewell Lane Shiphay TQ2 7EX Torquay Devon | British | 24926770001 | ||||||
| TANNER, Charles Derek | Director | Three Tors 66 Higher Cadewell Lane Shiphay TQ2 7EX Torquay Devon | British | 79342340001 | ||||||
| TANNER, Dale Charles | Director | 5 Fair Isle Close Scotts Meadow Barton TQ2 7BT Torquay Devon | British | 43117330002 | ||||||
| WRIGHT, Andrew John | Director | Midland Court Central Park LE17 4PN Lutterworth 15 Leicestershire England | United Kingdom | British | 122845150001 |
¿Quiénes son las personas con control significativo de LOGICAL COMMERCE LIMITED?
| Nombre | Notificado el | Dirección | Cesado | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zooom Holdings (Uk) Limited | 06 abr 2016 | Central Park LE17 4PN Lutterworth 15 Midland Court Leicestershire England | No | ||||||||||
| |||||||||||||
Naturaleza del control
| |||||||||||||
¿Tiene LOGICAL COMMERCE LIMITED alguna carga?
| Clasificación | Fechas | Estado | Detalles | |
|---|---|---|---|---|
| A security agreement | Creado el 08 mar 2012 Entregado el 27 mar 2012 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All monies due or to become due from an obligor or the obligors to the secured parties (or any of them) on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Breve descripción All the security created under the deed is created in favour of the security agent for and on behalf of the secured parties is created over present and future assets of the company is security of the payment and discharge of all the secured obliations see image for full details. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
| Security agreement | Creado el 18 nov 2009 Entregado el 27 nov 2009 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All monies due or to become due from each obligor to any finance party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Breve descripción Fixed and floating charge over all assets present and future, including goodwill, uncalled capital, shares, dividends, plant & machinery see image for full details. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
| Debenture | Creado el 05 sept 2008 Entregado el 20 sept 2008 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All monies due or to become due from the obligors to any one or more of the finance parties on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Breve descripción Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
| Debenture | Creado el 12 mar 1999 Entregado el 20 mar 1999 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Breve descripción Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
| Fixed and floating charge | Creado el 18 jun 1991 Entregado el 19 jun 1991 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Breve descripción Fixed charge on all book debts and other debts owing to the company. Floating charge over the undertaking and all property and assets present and future including book debts except those mentioned above uncalled capital. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
| Legal charge | Creado el 23 nov 1989 Entregado el 29 nov 1989 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Breve descripción Hereditaments and premises being 10 bittern road, sowton industrial estate exeter, devon. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
| Legal charge as evidenced by a statutory declaration dated 17/2/87 | Creado el 23 ene 1987 Entregado el 24 ene 1987 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Breve descripción Warehouse premises on the north west side of salterton road, exmouth, devon. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
| Legal charge | Creado el 19 ago 1981 Entregado el 25 ago 1981 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Breve descripción F/H 27 fore street, exmouth, devon. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
| Legal charge | Creado el 19 ago 1981 Entregado el 25 ago 1981 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Breve descripción L/H 10 bittern road, sowton industrial estate, exeter, devon. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
| Chattels mortgage | Creado el 07 abr 1981 Entregado el 09 abr 1981 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Breve descripción All and singular the chattels, plant machinery and items described or referred to in the schedule (see doc M31 for details). | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
| Mortgage | Creado el 08 jul 1977 Entregado el 28 jul 1977 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada £8,000 and all other monies due or to become due from the company to the chargee. | |
Breve descripción Shop & dwellinghouse, no 145, pinhoe road, exeter devon, title no dn 59731. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
| Floating charge | Creado el 24 ago 1972 Entregado el 30 ago 1972 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All moneys due etc. | |
Breve descripción Floating charge on the undertaking and all property present and future including uncalled capital. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
| Charge | Creado el 01 may 1968 Entregado el 08 may 1968 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All moneys due etc. | |
Breve descripción Plots 110 & 111 leadewell estate extension berkeley avenue, torquay. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
¿Tiene LOGICAL COMMERCE LIMITED algún caso de insolvencia?
| Número de expediente | Fechas | Tipo | Profesionales | Otro | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
| Liquidación voluntaria de socios |
|
Fuente de datos
- Companies House del Reino Unido
El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros. - Licencia: CC0