LOGICAL COMMERCE LIMITED

LOGICAL COMMERCE LIMITED

  • Visión general
  • Resumen
  • Propósito
  • Dirección
  • Nombres anteriores
  • Cuentas
  • Presentaciones
  • Directivos
  • Personas con control significativo
  • Gravámenes
  • Insolvencia
  • Fuente de datos
  • Visión general

    Nombre de la empresaLOGICAL COMMERCE LIMITED
    Estado de la empresaDisuelta
    Forma jurídicaSociedad de responsabilidad limitada
    Número de empresa 00919643
    JurisdicciónInglaterra/Gales
    Fecha de constitución
    Fecha de cese

    Resumen

    Tiene PSCs súper segurosNo
    Tiene gravámenes
    Tiene historial de insolvencia
    La sede social está en disputaNo

    ¿Cuál es el propósito de LOGICAL COMMERCE LIMITED?

    • Compañía no comercial (74990) / Actividades profesionales, científicas y técnicas

    ¿Dónde se encuentra LOGICAL COMMERCE LIMITED?

    Dirección de la sede social
    30 Finsbury Square
    EC2P 2YU London
    Dirección de la sede social no entregableNo

    ¿Cuáles fueron los nombres anteriores de LOGICAL COMMERCE LIMITED?

    Nombres anteriores de la empresa
    Nombre de la empresaDesdeHasta
    DIAMOND PLATFORMS LIMITED08 nov 199508 nov 1995
    EXETER HIRE CENTRE LIMITED25 oct 196725 oct 1967

    ¿Cuáles son las últimas cuentas de LOGICAL COMMERCE LIMITED?

    Últimas cuentas
    Últimas cuentas cerradas hasta31 dic 2017

    ¿Cuáles son las últimas presentaciones para LOGICAL COMMERCE LIMITED?

    Presentaciones
    FechaDescripciónDocumentoTipo

    Gaceta final disuelta tras la liquidación

    1 páginasGAZ2

    Devolución de la reunión final en una liquidación voluntaria de miembros

    8 páginasLIQ13

    Cese del nombramiento de Jerome Sarragozi como secretario el 30 abr 2019

    1 páginasTM02

    Domicilio social registrado cambiado de 15 Midland Court Central Park Lutterworth Leicestershire LE17 4PN England a 30 Finsbury Square London EC2P 2YU el 25 ene 2019

    2 páginasAD01

    Declaración de solvencia

    5 páginasLIQ01

    Nombramiento de un liquidador voluntario

    4 páginas600

    Resoluciones

    Resolutions
    1 páginasRESOLUTIONS
    Acuerdos
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    liquidation

    Acuerdo especial para la liquidación el 07 ene 2019

    LRESSP

    Declaración de confirmación presentada el 05 dic 2018 sin actualizaciones

    3 páginasCS01

    Cuentas completas preparadas hasta el 31 dic 2017

    16 páginasAA

    Declaración de confirmación presentada el 02 dic 2017 sin actualizaciones

    3 páginasCS01

    Nombramiento de Mr Jerome Sarragozi como secretario el 28 jul 2017

    2 páginasAP03

    Cese del nombramiento de Richard Andrew Cole como secretario el 28 jul 2017

    1 páginasTM02

    Cambio de datos del director Mr Donald Thomas Kenny el 24 jul 2017

    2 páginasCH01

    Cuentas completas preparadas hasta el 31 dic 2016

    16 páginasAA

    Nombramiento de Mr Thomas Anthony Murray como director el 01 jul 2017

    2 páginasAP01

    Cese del nombramiento de Alan Stuart Merrell como director el 30 jun 2017

    1 páginasTM01

    Cancelación total de la carga 13

    1 páginasMR04

    Cese del nombramiento de Jeremy Peter Fish como director el 28 feb 2017

    1 páginasTM01

    Declaración de confirmación presentada el 02 dic 2016 con actualizaciones

    5 páginasCS01

    Renuncia del auditor

    1 páginasAUD

    Domicilio social registrado cambiado de 145-157 st. John Street London EC1V 4PY a 15 Midland Court Central Park Lutterworth Leicestershire LE17 4PN el 31 ago 2016

    1 páginasAD01

    Cuentas completas preparadas hasta el 31 dic 2015

    17 páginasAA

    Cese del nombramiento de Alan Stuart Merrell como secretario el 07 abr 2016

    1 páginasTM02

    Nombramiento de Richard Andrew Cole como secretario el 07 abr 2016

    2 páginasAP03

    Déclaration annuelle établie au 02 dic 2015 avec liste complète des actionnaires

    5 páginasAR01
    Presentaciones asociadas
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    capital22 dic 2015

    Estado de capital el 22 dic 2015

    • Capital: GBP 100
    SH01

    ¿Quiénes son los directivos de LOGICAL COMMERCE LIMITED?

    Directivos
    NombreNombrado elRenunció elRolDirecciónIdentificación de la empresaPaís de residenciaNacionalidadFecha de nacimientoOcupaciónNúmero
    KENNY, Thomas Donald
    Central Park
    LE17 4PN Lutterworth
    15 Midland Court
    Leicestershire
    England
    Director
    Central Park
    LE17 4PN Lutterworth
    15 Midland Court
    Leicestershire
    England
    EnglandIrish165677760002
    MURRAY, Thomas Anthony
    Finsbury Square
    EC2P 2YU London
    30
    Director
    Finsbury Square
    EC2P 2YU London
    30
    EnglandBritish198214500001
    COLE, Richard Andrew
    Central Park
    LE17 4PN Lutterworth
    15 Midland Court
    Leicestershire
    England
    Secretario
    Central Park
    LE17 4PN Lutterworth
    15 Midland Court
    Leicestershire
    England
    207374600001
    FRANKLIN, Karen Jane
    189 Marldon Road
    TQ3 3NB Paignton
    Devon
    Secretario
    189 Marldon Road
    TQ3 3NB Paignton
    Devon
    British24926760001
    HILL, Percy James Hannaford
    65 Southfield Avenue
    TQ3 1LQ Paignton
    Devon
    Secretario
    65 Southfield Avenue
    TQ3 1LQ Paignton
    Devon
    British34368290001
    MERRELL, Alan Stuart
    Midland Court
    Central Park
    LE17 4PN Lutterworth
    15
    Leicestershire
    England
    Secretario
    Midland Court
    Central Park
    LE17 4PN Lutterworth
    15
    Leicestershire
    England
    British59110640004
    SARRAGOZI, Jerome
    Finsbury Square
    EC2P 2YU London
    30
    Secretario
    Finsbury Square
    EC2P 2YU London
    30
    236102320001
    SHIPMAN, David Cyril
    Church Farm
    Church Lane
    DE7 6DE Morley
    Derbyshire
    Secretario
    Church Farm
    Church Lane
    DE7 6DE Morley
    Derbyshire
    British77501360001
    APPLETON, Kevin Andrew
    Midland Court
    Central Park
    LE17 4PN Lutterworth
    15
    Leicestershire
    England
    Director
    Midland Court
    Central Park
    LE17 4PN Lutterworth
    15
    Leicestershire
    England
    EnglandBritish67821450016
    BAKER, Austin Philip
    4 Meadowcroft Drive
    Kingsteignton
    TQ12 3PB Newton Abbot
    Devon
    Director
    4 Meadowcroft Drive
    Kingsteignton
    TQ12 3PB Newton Abbot
    Devon
    British44426070001
    FISH, Jeremy Peter
    Central Park
    LE17 4PN Lutterworth
    15 Midland Court
    Leicestershire
    England
    Director
    Central Park
    LE17 4PN Lutterworth
    15 Midland Court
    Leicestershire
    England
    EnglandBritish160373640001
    FRANKLIN, Karen Jane
    189 Marldon Road
    TQ3 3NB Paignton
    Devon
    Director
    189 Marldon Road
    TQ3 3NB Paignton
    Devon
    British24926760001
    GANSSER-POTTS, Michael David
    Central Park
    LE17 4PN Lutterworth
    15 Midland Court
    Leicestershire
    Director
    Central Park
    LE17 4PN Lutterworth
    15 Midland Court
    Leicestershire
    EnglandBritish158445070001
    GESTETNER, Geoffrey Sigmund
    Flat 5 160 Gloucester Terrace
    W2 6HR London
    Director
    Flat 5 160 Gloucester Terrace
    W2 6HR London
    British47136960001
    MCMEEKING, Robert John
    Midland Court
    Central Park
    LE17 4PN Lutterworth
    15
    Leicestershire
    England
    Director
    Midland Court
    Central Park
    LE17 4PN Lutterworth
    15
    Leicestershire
    England
    United KingdomBritish75448720003
    MERRELL, Alan Stuart
    Midland Court
    Central Park
    LE17 4PN Lutterworth
    15
    Leicestershire
    England
    Director
    Midland Court
    Central Park
    LE17 4PN Lutterworth
    15
    Leicestershire
    England
    United KingdomBritish59110640004
    PRICE, David Lawrence
    Brook Farm
    Luddington In Th Brook
    PE28 0HB Oundle
    Northamptonshire
    Director
    Brook Farm
    Luddington In Th Brook
    PE28 0HB Oundle
    Northamptonshire
    British25187800003
    SHIPMAN, David Cyril
    Church Farm
    Church Lane
    DE7 6DE Morley
    Derbyshire
    Director
    Church Farm
    Church Lane
    DE7 6DE Morley
    Derbyshire
    British77501360001
    TANNER, Cecilia Kathleen Bessie
    Three Tors Higher Cadewell Lane
    Shiphay
    TQ2 7EX Torquay
    Devon
    Director
    Three Tors Higher Cadewell Lane
    Shiphay
    TQ2 7EX Torquay
    Devon
    British24926770001
    TANNER, Charles Derek
    Three Tors
    66 Higher Cadewell Lane Shiphay
    TQ2 7EX Torquay
    Devon
    Director
    Three Tors
    66 Higher Cadewell Lane Shiphay
    TQ2 7EX Torquay
    Devon
    British79342340001
    TANNER, Dale Charles
    5 Fair Isle Close
    Scotts Meadow Barton
    TQ2 7BT Torquay
    Devon
    Director
    5 Fair Isle Close
    Scotts Meadow Barton
    TQ2 7BT Torquay
    Devon
    British43117330002
    WRIGHT, Andrew John
    Midland Court
    Central Park
    LE17 4PN Lutterworth
    15
    Leicestershire
    England
    Director
    Midland Court
    Central Park
    LE17 4PN Lutterworth
    15
    Leicestershire
    England
    United KingdomBritish122845150001

    ¿Quiénes son las personas con control significativo de LOGICAL COMMERCE LIMITED?

    Personas con control significativo
    NombreNotificado elDirecciónCesado
    Zooom Holdings (Uk) Limited
    Central Park
    LE17 4PN Lutterworth
    15 Midland Court
    Leicestershire
    England
    06 abr 2016
    Central Park
    LE17 4PN Lutterworth
    15 Midland Court
    Leicestershire
    England
    No
    Forma jurídicaLimited Company
    País de registroUk
    Autoridad legalCompanies Act
    Lugar de registroEngland & Wales
    Número de registro4812536
    Naturaleza del control
    • La persona posee, directa o indirectamente, más del 75% de las acciones de la compañía.

    ¿Tiene LOGICAL COMMERCE LIMITED alguna carga?

    Gravámenes
    ClasificaciónFechasEstadoDetalles
    A security agreement
    Creado el 08 mar 2012
    Entregado el 27 mar 2012
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from an obligor or the obligors to the secured parties (or any of them) on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descripción
    All the security created under the deed is created in favour of the security agent for and on behalf of the secured parties is created over present and future assets of the company is security of the payment and discharge of all the secured obliations see image for full details.
    Personas con derecho
    • Hsbc Corporate Trustee Company (UK) Limited
    Transacciones
    • 27 mar 2012Registro de un cargo (MG01)
    • 22 jun 2017Satisfacción de una carga (MR04)
    Security agreement
    Creado el 18 nov 2009
    Entregado el 27 nov 2009
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from each obligor to any finance party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descripción
    Fixed and floating charge over all assets present and future, including goodwill, uncalled capital, shares, dividends, plant & machinery see image for full details.
    Personas con derecho
    • Bank of Scotland PLC (The Security Trustee) as Agent and/or Trustee for the Finance Parties
    Transacciones
    • 27 nov 2009Registro de un cargo (MG01)
    • 05 abr 2012Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (MG02)
    Debenture
    Creado el 05 sept 2008
    Entregado el 20 sept 2008
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the obligors to any one or more of the finance parties on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descripción
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Personas con derecho
    • Bank of Scotland PLC as Agent and Trustee for the Finance Parties (The “Security Trustee”)
    Transacciones
    • 20 sept 2008Registro de un cargo (395)
    • 05 abr 2012Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (MG02)
    Debenture
    Creado el 12 mar 1999
    Entregado el 20 mar 1999
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transacciones
    • 20 mar 1999Registro de un cargo (395)
    • 20 ago 2008Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Fixed and floating charge
    Creado el 18 jun 1991
    Entregado el 19 jun 1991
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    Fixed charge on all book debts and other debts owing to the company. Floating charge over the undertaking and all property and assets present and future including book debts except those mentioned above uncalled capital.
    Personas con derecho
    • Midland Bank PLC
    Transacciones
    • 19 jun 1991Registro de una carga
    • 03 jul 1997Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Legal charge
    Creado el 23 nov 1989
    Entregado el 29 nov 1989
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    Hereditaments and premises being 10 bittern road, sowton industrial estate exeter, devon.
    Personas con derecho
    • Midland Bank PLC
    Transacciones
    • 29 nov 1989Registro de una carga
    • 28 may 1999Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Legal charge as evidenced by a statutory declaration dated 17/2/87
    Creado el 23 ene 1987
    Entregado el 24 ene 1987
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    Warehouse premises on the north west side of salterton road, exmouth, devon.
    Personas con derecho
    • Midland Bank PLC
    Transacciones
    • 24 ene 1987Registro de una carga
    • 28 may 1999Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Legal charge
    Creado el 19 ago 1981
    Entregado el 25 ago 1981
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    F/H 27 fore street, exmouth, devon.
    Personas con derecho
    • Midland Bank PLC
    Transacciones
    • 25 ago 1981Registro de una carga
    • 28 may 1999Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Legal charge
    Creado el 19 ago 1981
    Entregado el 25 ago 1981
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    L/H 10 bittern road, sowton industrial estate, exeter, devon.
    Personas con derecho
    • Midland Bank PLC
    Transacciones
    • 25 ago 1981Registro de una carga
    • 20 ago 2008Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Chattels mortgage
    Creado el 07 abr 1981
    Entregado el 09 abr 1981
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    All and singular the chattels, plant machinery and items described or referred to in the schedule (see doc M31 for details).
    Personas con derecho
    • Forward Trust LTD
    Transacciones
    • 09 abr 1981Registro de una carga
    Mortgage
    Creado el 08 jul 1977
    Entregado el 28 jul 1977
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    £8,000 and all other monies due or to become due from the company to the chargee.
    Breve descripción
    Shop & dwellinghouse, no 145, pinhoe road, exeter devon, title no dn 59731.
    Personas con derecho
    • E.J.Allen.
    Transacciones
    • 28 jul 1977Registro de una carga
    Floating charge
    Creado el 24 ago 1972
    Entregado el 30 ago 1972
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All moneys due etc.
    Breve descripción
    Floating charge on the undertaking and all property present and future including uncalled capital.
    Personas con derecho
    • Midland Bank PLC
    Transacciones
    • 30 ago 1972Registro de una carga
    • 18 dic 1993Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Charge
    Creado el 01 may 1968
    Entregado el 08 may 1968
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All moneys due etc.
    Breve descripción
    Plots 110 & 111 leadewell estate extension berkeley avenue, torquay.
    Personas con derecho
    • Barclays Bank PLC
    Transacciones
    • 08 may 1968Registro de una carga

    ¿Tiene LOGICAL COMMERCE LIMITED algún caso de insolvencia?

    Número de expedienteFechasTipoProfesionalesOtro
    1
    FechaTipo
    07 ene 2019Inicio de la liquidación
    06 dic 2019Fecha de disolución
    Liquidación voluntaria de socios
    NombreRolDirecciónNombrado elCesado el
    Sean Kenneth Croston
    Grant Thornton Uk Llp
    30 Finsbury Square
    EC2P 2YU London
    Profesional
    Grant Thornton Uk Llp
    30 Finsbury Square
    EC2P 2YU London

    Fuente de datos

    • Companies House del Reino Unido
      El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros.
    • Licencia: CC0