STARPOINT ELECTRICS LIMITED
Visión general
Nombre de la empresa | STARPOINT ELECTRICS LIMITED |
---|---|
Estado de la empresa | Disuelta |
Forma jurídica | Sociedad de responsabilidad limitada |
Número de empresa | 00922239 |
Jurisdicción | Inglaterra/Gales |
Fecha de constitución | |
Fecha de cese |
Resumen
Tiene PSCs súper seguros | No |
---|---|
Tiene gravámenes | Sí |
Tiene historial de insolvencia | No |
La sede social está en disputa | No |
¿Cuál es el propósito de STARPOINT ELECTRICS LIMITED?
- fabricación de otros productos de plástico (22290) / Industrias manufactureras
¿Dónde se encuentra STARPOINT ELECTRICS LIMITED?
Dirección de la sede social | Unit D2 Longmead Business Centre Felstead Road KT19 9QG Epsom Surrey England |
---|---|
Dirección de la sede social no entregable | No |
¿Cuáles son las últimas cuentas de STARPOINT ELECTRICS LIMITED?
Últimas cuentas | |
---|---|
Últimas cuentas cerradas hasta | 31 dic 2019 |
¿Cuáles son las últimas presentaciones para STARPOINT ELECTRICS LIMITED?
Fecha | Descripción | Documento | Tipo | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Boletín oficial final disuelto por cancelación voluntaria | 1 páginas | GAZ2(A) | ||||||||||
Primer aviso en el boletín oficial para la cancelación voluntaria | 1 páginas | GAZ1(A) | ||||||||||
Solicitud de exclusión de la empresa del registro | 1 páginas | DS01 | ||||||||||
Domicilio social registrado cambiado de Unit 1 & 2 King Georges Trading Estate Davis Road Chessington Surrey KT9 1TT a Unit D2 Longmead Business Centre Felstead Road Epsom Surrey KT19 9QG el 15 abr 2021 | 1 páginas | AD01 | ||||||||||
Cuentas de exención total completas preparadas hasta el 31 dic 2019 | 5 páginas | AA | ||||||||||
Declaración de confirmación presentada el 30 may 2020 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||||||||||
Cuentas de exención total completas preparadas hasta el 31 dic 2018 | 6 páginas | AA | ||||||||||
Declaración de confirmación presentada el 30 may 2019 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||||||||||
Cuentas de exención total completas preparadas hasta el 31 dic 2017 | 5 páginas | AA | ||||||||||
Declaración de confirmación presentada el 30 may 2018 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||||||||||
Cessation de Pieter Cornelis Robijn en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 05 jun 2018 | 1 páginas | PSC07 | ||||||||||
Cuentas de exención total completas preparadas hasta el 31 dic 2016 | 7 páginas | AA | ||||||||||
Cambio de datos del director Mr Charles Thomas Frederick Sines el 17 jun 2017 | 2 páginas | CH01 | ||||||||||
Declaración de confirmación presentada el 30 may 2017 con actualizaciones | 6 páginas | CS01 | ||||||||||
Cuentas completas preparadas hasta el 31 dic 2015 | 10 páginas | AA | ||||||||||
Déclaration annuelle établie au 30 may 2016 avec liste complète des actionnaires | 4 páginas | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Cuentas completas preparadas hasta el 31 dic 2014 | 10 páginas | AA | ||||||||||
Déclaration annuelle établie au 30 may 2015 avec liste complète des actionnaires | 4 páginas | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Registro de la carga 009222390007, creada el 13 mar 2015 | 43 páginas | MR01 | ||||||||||
Cuentas completas preparadas hasta el 31 dic 2013 | 12 páginas | AA | ||||||||||
Déclaration annuelle établie au 30 may 2014 avec liste complète des actionnaires | 4 páginas | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Cuentas completas preparadas hasta el 31 dic 2012 | 13 páginas | AA | ||||||||||
Cese del nombramiento de Colin Crossman como director | 1 páginas | TM01 | ||||||||||
Nombramiento de Mr Charles Thomas Frederick Sines como secretario | 2 páginas | AP03 | ||||||||||
Nombramiento de Mr Charles Thomas Frederick Sines como director | 2 páginas | AP01 | ||||||||||
¿Quiénes son los directivos de STARPOINT ELECTRICS LIMITED?
Nombre | Nombrado el | Renunció el | Rol | Dirección | Identificación de la empresa | País de residencia | Nacionalidad | Fecha de nacimiento | Ocupación | Número |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SINES, Charles Thomas Frederick | Secretario | & 2 King Georges Trading Estate Davis Road KT9 1TT Chessington Units 1 Surrey England | 181578090001 | |||||||
BROTMAN, Kenneth Ross | Director | Felstead Road KT19 9QG Epsom Unit D2 Longmead Business Centre Surrey England | United States | American | Banker | 172061850001 | ||||
SINES, Charles Thomas Frederick | Director | & 2 King Georges Trading Estate Davis Road KT9 1TT Chessington Units 1 Surrey England | United Kingdom | British | Company Director | 68160790006 | ||||
ARNAOUTI, Michael | Secretario | 20 Beresford Road KT2 6LR Kingston Upon Thames Surrey | British | 539040002 | ||||||
COX, Edward Brian | Secretario | 1 Charterhouse Road BR6 9EJ Orpington Kent | British | 540730001 | ||||||
CROSSMAN, Colin | Secretario | 93 Heol Y Coed Rhiwbina CF4 6HR Cardiff | British | Director | 53119850001 | |||||
MARCHINI, Barry Allen | Secretario | Beech Lodge Old Brighton Road Pease Pottage RH11 9AJ Crawley West Sussex | British | 70716370003 | ||||||
REGINELLI, David | Secretario | 106 Garlisch Elkgrove Vil Il 60007 Us | Usa | Cfo | 116834130001 | |||||
SAMTER, Daniel John | Secretario | Whitecroft Tandridge Lane RH7 6LL Lingfield Surrey | British | Finance Director | 17049350001 | |||||
TAYLOR, Nigel Francis Glanvill | Secretario | Lower Farm Green Lane RG25 2QL Ellisfield Basingstoke Hampshire | British | Fince Director | 56925320002 | |||||
BISHOP, Trevor James | Director | 12 Beech Road PO8 0LH Clanfield Hants | England | English | Sales Director | 110325260001 | ||||
BOURNE, Walter | Director | 142 Woodland Drive BN3 6DE Hove East Sussex | British | Director | 10510830001 | |||||
COX, Edward Brian | Director | 1 Charterhouse Road BR6 9EJ Orpington Kent | British | Company Secretary | 540730001 | |||||
CROSSMAN, Colin | Director | 93 Heol Y Coed Rhiwbina CF4 6HR Cardiff | Wales | British | Technical Director | 53119850001 | ||||
FRYER, David William | Director | 48 Alders Avenue RH19 2BZ East Grinstead West Sussex | British | Director | 28510780003 | |||||
INNES, Michael Andrew | Director | 67 Temple Road TW9 2EB Richmond Surrey | British | Managing Director | 55128190001 | |||||
MARCHINI, Barry Allen | Director | Beech Lodge Old Brighton Road Pease Pottage RH11 9AJ Crawley West Sussex | British | Managing Director | 70716370003 | |||||
MCEVOY, Michael Joseph | Director | Home Farm Cottage Church Street Dinder BA5 3PE Wells Somerset | England | British | Operations Director | 58803390001 | ||||
NEWMAN, Michael James | Director | 6 Applegrove KT9 1BE Chessington Surrey | British | Works Director | 28510790001 | |||||
PARTRIDGE, David | Director | Newlands 11 Little Court BR4 9AL West Wickham Kent | British | Director | 28510800001 | |||||
PLUMB, Christopher | Director | 9 Cheshunt Close Meopham DA13 0HU Gravesend Kent | British | Director | 66924800001 | |||||
REGINELLI, David | Director | Garlisch Elkgrove Village Il 60007 106 Illinois Usa | Usa | Usa | Finance Director | 116834130001 | ||||
SALMON, Stephen James | Director | Garden Cottage Horsham Road BN4 3AG Steyning West Sussex | United Kingdom | British | Company Director | 1421430001 | ||||
SAMTER, Daniel John | Director | Whitecroft Tandridge Lane RH7 6LL Lingfield Surrey | England | British | Finance Director | 17049350001 | ||||
SMITH, Kenneth George | Director | 16 Birch Grove Kingswood KT20 6QU Tadworth Surrey | United Kingdom | British | Director | 29086370001 | ||||
STARLEVICH, John | Director | 10849 Caribou Lane Orland Park Ilinois 60467 Usa | Usa | Usa | Principal | 116795580001 | ||||
TAYLOR, Nigel Francis Glanvill | Director | Lower Farm Green Lane RG25 2QL Ellisfield Basingstoke Hampshire | British | Fince Director | 56925320002 | |||||
UNDERWOOD, John | Director | 898 S.Bristol Lane, Arlington Heights Illinois Il 60005 Usa | Usa | American | Banking Investments | 103323370001 | ||||
WESTHEAD, John Michael, Dr | Director | 6 Weatherby Mews Bolton Gardens SW5 0JG London | British | Director | 540740002 |
¿Quiénes son las personas con control significativo de STARPOINT ELECTRICS LIMITED?
Nombre | Notificado el | Dirección | Cesado | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mr Pieter Cornelis Robijn | 07 abr 2016 | & 2 King Georges Trading Estate Davis Road KT9 1TT Chessington Unit 1 Surrey | Sí | ||||||||||
Nacionalidad: Dutch País de residencia: Netherlands | |||||||||||||
Naturaleza del control
| |||||||||||||
Global Investments Holding Bv | 06 abr 2016 | Antonie Van Leeuwenhoekstraat 9 3261lt Oud-Beijerland 9 Netherlands | No | ||||||||||
| |||||||||||||
Naturaleza del control
|
¿Tiene STARPOINT ELECTRICS LIMITED alguna carga?
Clasificación | Fechas | Estado | Detalles | |
---|---|---|---|---|
A registered charge | Creado el 13 mar 2015 Entregado el 24 mar 2015 | Pendiente | ||
La garantía flotante cubre todo: Sí Contiene una promesa negativa: Sí Contiene una garantía flotante: Sí Contiene una garantía fija: Sí | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
Debenture | Creado el 17 jul 2012 Entregado el 28 jul 2012 | Pendiente | Cantidad garantizada All monies due or to become due from the security obligors to any of the finance parties on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Breve descripción Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery. See image for full details. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
Deed of charge and assignment | Creado el 31 oct 2006 Entregado el 15 nov 2006 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All monies due or to become due from any borrower to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Breve descripción Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
Supplemental deed to a composite guarantee and debenture | Creado el 03 jun 2003 Entregado el 17 jun 2003 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All monies due or to become due from the company and each other company to the secured parties or any of them under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Breve descripción By way of first fixed charge the charged account being the account held by electrics with the bank denominated "starpoint charged account" with sort code 151000 and account number 21925805 and the charged funds.. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
Composite guarantee and debenture | Creado el 01 oct 1997 Entregado el 20 oct 1997 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All monies due or to become due from the company and each other company (as defined) to the chargee and the secured parties (as defined) or any of them under or pursuant to the secured documents (as defined) | |
Breve descripción Units 1, 2 and 3 king george's estate (otherwise k/a david road estate) davis road chessington surrey t/nos: SGL168117 SGL304984 and SGL305005 .. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
Forth supplemental trust deed. | Creado el 17 sept 1990 Entregado el 27 sept 1990 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada £408,087 8% debenture stock 1988/93 of bowthorpe holdings PLC and any other moneys intended to be secured by this deed and deeds dated 10TH november 1966 9TH july 1970, 10TH april 1979 and 31ST august 1988 to which it is supplemental. | |
Breve descripción All the company's undertaking and assets present and future including uncalled capital. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
Legal charge | Creado el 21 dic 1983 Entregado el 22 dic 1983 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Breve descripción F/H property- land & buildings on N.E. side of garth rd, modern london borough of merton; title no. Sgl 168117. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
|
Fuente de datos
- Companies House del Reino Unido
El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros. - Licencia: CC0