PIPPA DEE PARTIES LIMITED
Visión general
| Nombre de la empresa | PIPPA DEE PARTIES LIMITED |
|---|---|
| Estado de la empresa | Disuelta |
| Forma jurídica | Sociedad de responsabilidad limitada |
| Número de empresa | 00924601 |
| Jurisdicción | Inglaterra/Gales |
| Fecha de constitución | |
| Fecha de cese |
Resumen
| Tiene PSCs súper seguros | No |
|---|---|
| Tiene gravámenes | Sí |
| Tiene historial de insolvencia | No |
| La sede social está en disputa | No |
¿Cuál es el propósito de PIPPA DEE PARTIES LIMITED?
- Compañía no comercial (74990) / Actividades profesionales, científicas y técnicas
¿Dónde se encuentra PIPPA DEE PARTIES LIMITED?
| Dirección de la sede social | Church Bridge House Henry Street BB5 4EE Accrington United Kingdom |
|---|---|
| Dirección de la sede social no entregable | No |
¿Cuáles son las últimas cuentas de PIPPA DEE PARTIES LIMITED?
| Últimas cuentas | |
|---|---|
| Últimas cuentas cerradas hasta | 26 mar 2021 |
¿Cuáles son las últimas presentaciones para PIPPA DEE PARTIES LIMITED?
| Fecha | Descripción | Documento | Tipo | |
|---|---|---|---|---|
Boletín oficial final disuelto por cancelación obligatoria | 1 páginas | GAZ2 | ||
Primer aviso en el boletín oficial para la cancelación obligatoria | 1 páginas | GAZ1 | ||
Nombramiento de Mr Michael Arnaouti como director el 17 dic 2021 | 2 páginas | AP01 | ||
Nombramiento de Mr Michael Arnaouti como secretario el 17 dic 2021 | 2 páginas | AP03 | ||
Cese del nombramiento de Mark Ashcroft como secretario el 16 dic 2021 | 1 páginas | TM02 | ||
Cese del nombramiento de Mark Ashcroft como director el 16 dic 2021 | 1 páginas | TM01 | ||
Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 26 mar 2021 | 1 páginas | AA | ||
Declaración de confirmación presentada el 04 jun 2021 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||
Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 27 mar 2020 | 1 páginas | AA | ||
Cese del nombramiento de Philip Binns Maudsley como director el 26 mar 2021 | 1 páginas | TM01 | ||
Declaración de confirmación presentada el 04 jun 2020 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||
Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 29 mar 2019 | 2 páginas | AA | ||
Declaración de confirmación presentada el 04 jun 2019 con actualizaciones | 4 páginas | CS01 | ||
Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 30 mar 2018 | 2 páginas | AA | ||
Declaración de confirmación presentada el 04 jun 2018 con actualizaciones | 4 páginas | CS01 | ||
Cambio de datos del director Mark Ashcroft el 02 abr 2018 | 2 páginas | CH01 | ||
Cambio de datos del director Mr Philip Binns Maudsley el 02 abr 2018 | 2 páginas | CH01 | ||
Cambio de datos del director Mr Stuart Murdoch Caldwell el 01 abr 2018 | 2 páginas | CH01 | ||
Modification des détails de Rosgill Group Limited en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 02 mar 2018 | 2 páginas | PSC05 | ||
Domicilio social registrado cambiado de 2 Gregory Street Hyde Cheshire SK14 4th a Church Bridge House Henry Street Accrington BB5 4EE el 01 mar 2018 | 1 páginas | AD01 | ||
Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 31 mar 2017 | 2 páginas | AA | ||
Declaración de confirmación presentada el 04 jun 2017 con actualizaciones | 5 páginas | CS01 | ||
Cese del nombramiento de Timothy John Kowalski como director el 05 abr 2017 | 1 páginas | TM01 | ||
Nombramiento de Mark Ashcroft como director el 06 abr 2017 | 2 páginas | AP01 | ||
Nombramiento de Stuart Murdoch Caldwell como director el 06 abr 2017 | 2 páginas | AP01 | ||
¿Quiénes son los directivos de PIPPA DEE PARTIES LIMITED?
| Nombre | Nombrado el | Renunció el | Rol | Dirección | Identificación de la empresa | País de residencia | Nacionalidad | Fecha de nacimiento | Ocupación | Número |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ARNAOUTI, Michael | Secretario | Henry Street BB5 4EE Accrington Church Bridge House United Kingdom | 290653820001 | |||||||
| ARNAOUTI, Michael | Director | Henry Street BB5 4EE Accrington Church Bridge House United Kingdom | England | British | 539040004 | |||||
| CALDWELL, Stuart Murdoch | Director | Henry Street BB5 4EE Accrington Church Bridge House United Kingdom | United Kingdom | British | 229000880001 | |||||
| ASHCROFT, Mark | Secretario | Gregory Street SK14 4TH Hyde 2 Cheshire United Kingdom | 165368920001 | |||||||
| BOLTON, Ivan Joseph, Dr | Secretario | Gregory Street SK14 4TH Hyde 2 Cheshire | British | 14333000007 | ||||||
| CANN, Geoffrey | Secretario | 11 Malmesbury Avenue Midway DE11 7PS Swadlincote Derbyshire | British | 12477370001 | ||||||
| HALE, Donald | Secretario | Trees House Staupes Road High Birstwith HG3 2LF Harrogate North Yorkshire | British | 75316130001 | ||||||
| ASHCROFT, Mark | Director | Henry Street BB5 4EE Accrington Church Bridge House United Kingdom | United Kingdom | British | 113691350001 | |||||
| BOLTON, Ivan Joseph, Dr | Director | Gregory Street SK14 4TH Hyde 2 Cheshire | United Kingdom | British | 14333000007 | |||||
| CHAPMAN, Keith | Director | Flasby BD23 3PX Skipton Flasby Hall North Yorkshire United Kingdom | United Kingdom | British | 143093130001 | |||||
| HALE, Donald | Director | Trees House Staupes Road High Birstwith HG3 2LF Harrogate North Yorkshire | British | 75316130001 | ||||||
| JOHNSON, David Anthony | Director | Cold Knoll Farm Stanbury BD22 0HH Haworth West Yorkshire | United Kingdom | British | 157156750001 | |||||
| JOLLY, Patrick Edmund | Director | Hill Top Farm Hill Top Lane Skipton Road, BB18 6JN Earby Lancashire | England | British | 75327660001 | |||||
| KING, Dennis | Director | 13 Dower House Crescent TN4 0TT Southborough Kent | British | 55754500001 | ||||||
| KITE, Ronald | Director | Keston Hall Lane Doveridge DE6 5NQ Ashbourne Derbyshire | British | 13131070001 | ||||||
| KOWALSKI, Timothy John | Director | Gregory Street SK14 4TH Hyde 2 Cheshire | Uk | British | 153335190003 | |||||
| MAUDSLEY, Philip Binns | Director | Henry Street BB5 4EE Accrington Church Bridge House United Kingdom | United Kingdom | British | 15967010001 | |||||
| MOUNTFORD, Ewart | Director | 11 Ambleside Court CW12 4HZ Congleton Cheshire | British | 13300230001 | ||||||
| SIDDLE, Roger William John | Director | Gregory Street SK14 4TH Hyde 2 Cheshire | England | British | 46903210001 | |||||
| WILLIAMS, Keith John | Director | 12 The Hay Barn Walmley B76 1DE Sutton Coldfield West Midlands | England | British | 12477390001 | |||||
| WOODS, Roger Slater | Director | 229 Burton Road Branston DE14 3DR Burton On Trent Staffordshire | British | 13300240001 |
¿Quiénes son las personas con control significativo de PIPPA DEE PARTIES LIMITED?
| Nombre | Notificado el | Dirección | Cesado | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rosgill Group Limited | 06 abr 2016 | Henry Street BB5 4EE Accrington Church Bridge House United Kingdom | No | ||||||||||
| |||||||||||||
Naturaleza del control
| |||||||||||||
¿Tiene PIPPA DEE PARTIES LIMITED alguna carga?
| Clasificación | Fechas | Estado | Detalles | |
|---|---|---|---|---|
| Fixed and floating charge | Creado el 20 may 1991 Entregado el 05 jun 1991 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Breve descripción Fixed charge on all book debts & other debts owing to the company floating charge over the undertaking and all property and assets present and future including book debts (excluding those mentioned above) uncalled capital. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
| Fixed and floating charge | Creado el 25 nov 1988 Entregado el 13 dic 1988 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Breve descripción Fixed charge on all book debts & other debts owing to the company floating charge over the undertaking and all property and assets present and future including book debts (excluding those mentioned above) uncalled capital. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
| Debenture | Creado el 01 mar 1984 Entregado el 01 mar 1984 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Breve descripción (Including trade fixtures). Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
| Further guarantee and debenture | Creado el 04 jul 1977 Entregado el 08 jul 1977 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All monies due or to become due from the company and/or all or any at the other los named therein | |
Breve descripción All that property, undertaking & assets charged by the principal deed & further deed. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
| Further guarantee & debenture | Creado el 23 jul 1976 Entregado el 16 ago 1976 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other los named therein to the chargee on any account whatsoever. | |
Breve descripción All that property, undertaking & asstes charged by the principal deed & further deed. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
| Guarantee & debenture | Creado el 01 nov 1973 Entregado el 14 nov 1973 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All monies due or to become due from the company and/or all or any of the two other companies named therein | |
Breve descripción Undertaking and goodwill all property and assets present and future including uncalled capital. Fixed & floating charges. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
Fuente de datos
- Companies House del Reino Unido
El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros. - Licencia: CC0