PLASCOAT HOLDINGS LIMITED

PLASCOAT HOLDINGS LIMITED

  • Visión general
  • Resumen
  • Propósito
  • Dirección
  • Nombres anteriores
  • Cuentas
  • Declaración de confirmación
  • Presentaciones
  • Directivos
  • Personas con control significativo
  • Gravámenes
  • Fuente de datos
  • Visión general

    Nombre de la empresaPLASCOAT HOLDINGS LIMITED
    Estado de la empresaActiva
    Forma jurídicaSociedad de responsabilidad limitada
    Número de empresa 00931836
    JurisdicciónInglaterra/Gales
    Fecha de constitución

    Resumen

    Tiene PSCs súper segurosNo
    Tiene gravámenes
    Tiene historial de insolvenciaNo
    La sede social está en disputaNo

    ¿Cuál es el propósito de PLASCOAT HOLDINGS LIMITED?

    • Actividades de oficinas centrales (70100) / Actividades profesionales, científicas y técnicas

    ¿Dónde se encuentra PLASCOAT HOLDINGS LIMITED?

    Dirección de la sede social
    Trading Estate
    Farnham
    GU9 9NY Surrey
    Dirección de la sede social no entregableNo

    ¿Cuáles fueron los nombres anteriores de PLASCOAT HOLDINGS LIMITED?

    Nombres anteriores de la empresa
    Nombre de la empresaDesdeHasta
    MANHATTAN MILLS LIMITED10 may 196810 may 1968

    ¿Cuáles son las últimas cuentas de PLASCOAT HOLDINGS LIMITED?

    VencidoNo
    Próximas cuentas
    Próximo período contable finaliza el31 dic 2024
    Próximas cuentas vencen el30 sept 2025
    Últimas cuentas
    Últimas cuentas cerradas hasta31 dic 2023

    ¿Cuál es el estado de la última declaración de confirmación para PLASCOAT HOLDINGS LIMITED?

    Última declaración de confirmación cerrada hasta23 mar 2025
    Próxima declaración de confirmación vence06 abr 2025
    Última declaración de confirmación
    Próxima declaración de confirmación cerrada hasta23 mar 2024
    VencidoNo

    ¿Cuáles son las últimas presentaciones para PLASCOAT HOLDINGS LIMITED?

    Presentaciones
    FechaDescripciónDocumentoTipo

    Cuentas completas preparadas hasta el 31 dic 2023

    16 páginasAA

    Declaración de confirmación presentada el 23 mar 2024 sin actualizaciones

    3 páginasCS01

    Cuentas completas preparadas hasta el 31 dic 2022

    16 páginasAA

    Cancelación total de la carga 009318360008

    1 páginasMR04

    Cancelación total de la carga 009318360010

    1 páginasMR04

    Cancelación total de la carga 009318360007

    1 páginasMR04

    Declaración de confirmación presentada el 23 mar 2023 sin actualizaciones

    3 páginasCS01

    Cuentas para una empresa pequeña preparadas hasta el 31 dic 2021

    16 páginasAA

    Declaración de confirmación presentada el 23 mar 2022 sin actualizaciones

    3 páginasCS01

    Cuentas para una empresa pequeña preparadas hasta el 31 dic 2020

    16 páginasAA

    Declaración de confirmación presentada el 23 mar 2021 sin actualizaciones

    3 páginasCS01

    Cuentas completas preparadas hasta el 31 dic 2019

    15 páginasAA

    Declaración de confirmación presentada el 23 mar 2020 sin actualizaciones

    3 páginasCS01

    Cese del nombramiento de Michael Keith Davis como director el 24 jun 2019

    1 páginasTM01

    Nombramiento de Mr Farrell Dolan como director el 24 jun 2019

    2 páginasAP01

    Cuentas completas preparadas hasta el 31 dic 2018

    15 páginasAA

    Declaración de confirmación presentada el 23 mar 2019 sin actualizaciones

    3 páginasCS01

    Cuentas de exención total completas preparadas hasta el 31 dic 2017

    16 páginasAA

    Registro de la carga 009318360011, creada el 21 jun 2018

    14 páginasMR01

    Registro de la carga 009318360010, creada el 22 jun 2018

    28 páginasMR01

    Notification de Plascoat Systems Limited en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 14 ago 2017

    2 páginasPSC02

    Cessation de Axalta Coating Systems Uk Holding Ltd en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 14 ago 2017

    1 páginasPSC07

    Declaración de confirmación presentada el 23 mar 2018 con actualizaciones

    4 páginasCS01

    Registro de la carga 009318360008, creada el 20 dic 2017

    10 páginasMR01

    Registro de la carga 009318360009, creada el 20 dic 2017

    14 páginasMR01

    ¿Quiénes son los directivos de PLASCOAT HOLDINGS LIMITED?

    Directivos
    NombreNombrado elRenunció elRolDirecciónIdentificación de la empresaPaís de residenciaNacionalidadFecha de nacimientoOcupaciónNúmero
    BLENKINSOPP, James Ian
    c/o Axalta Coating Systems Uk Holding Limited
    Quadrant Park
    Mundells
    AL7 1FS Welwyn Garden City
    Unit 1
    England
    Director
    c/o Axalta Coating Systems Uk Holding Limited
    Quadrant Park
    Mundells
    AL7 1FS Welwyn Garden City
    Unit 1
    England
    EnglandBritishDirector234692360001
    DOLAN, Farrell
    Quadrant Park
    Mundells
    AL7 1FS Welwyn Garden City
    Unit 1
    Hertfordshire
    United Kingdom
    Director
    Quadrant Park
    Mundells
    AL7 1FS Welwyn Garden City
    Unit 1
    Hertfordshire
    United Kingdom
    EnglandBritishManaging Director249146510001
    ELKIN, George Frank
    Elm Cottage Oakley Lane
    Oakley
    RG23 7JZ Basingstoke
    Hampshire
    Secretario
    Elm Cottage Oakley Lane
    Oakley
    RG23 7JZ Basingstoke
    Hampshire
    British1705100001
    INVENSYS SECRETARIES LIMITED
    Invensys House
    Carlisle Place
    SW1P 1BX London
    Secretario corporativo
    Invensys House
    Carlisle Place
    SW1P 1BX London
    75491680001
    TDC PLASTICS LTD
    Trading Estate
    GU9 9NY Farnham
    C/O Plascoat Systems Limited
    Surrey
    United Kingdom
    Secretario corporativo
    Trading Estate
    GU9 9NY Farnham
    C/O Plascoat Systems Limited
    Surrey
    United Kingdom
    Tipo de identificaciónEEE
    Número de registro00894421
    86898730001
    BROWN, Robert Casson
    38 Newlands Avenue
    Melton Park
    NE3 5PX Newcastle Upon Tyne
    Director
    38 Newlands Avenue
    Melton Park
    NE3 5PX Newcastle Upon Tyne
    BritishSolicitor6343100001
    DAVIS, Michael Keith
    c/o Axalta Coating Systems Uk Holding Limited
    Quadrant Park
    Mundells
    AL7 1FS Welwyn Garden City
    Unit 1
    England
    Director
    c/o Axalta Coating Systems Uk Holding Limited
    Quadrant Park
    Mundells
    AL7 1FS Welwyn Garden City
    Unit 1
    England
    EnglandBritishDirector153157140002
    DUNNETT, Christopher Frederic
    Trading Estate
    Farnham
    GU9 9NY Surrey
    Director
    Trading Estate
    Farnham
    GU9 9NY Surrey
    United KingdomBritishChief Executive34066120002
    DUNNETT, Christopher Frederic
    Roselands
    25 Shortheath Road
    GU9 8SN Farnham
    Surrey
    Director
    Roselands
    25 Shortheath Road
    GU9 8SN Farnham
    Surrey
    United KingdomBritishGroup Managing Director34066120002
    ELKIN, George Frank
    Elm Cottage Oakley Lane
    Oakley
    RG23 7JZ Basingstoke
    Hampshire
    Director
    Elm Cottage Oakley Lane
    Oakley
    RG23 7JZ Basingstoke
    Hampshire
    BritishAccountant1705100001
    STOKE, Jeremy Michael
    Wentworth Road
    B17 9SU Birmingham
    127
    England
    Director
    Wentworth Road
    B17 9SU Birmingham
    127
    England
    EnglandBritishCompany Director80957760001
    THOM, James Demmink
    Tollgate Cottage
    Turners Hill Road
    RH10 4HG Crawley Down
    West Sussex
    Director
    Tollgate Cottage
    Turners Hill Road
    RH10 4HG Crawley Down
    West Sussex
    BritishTreasurer38683120002
    WALTERS, Harold Edward
    Flat 6a Belgravia
    57 South Bay Repulse Bay
    Hong Kong
    Director
    Flat 6a Belgravia
    57 South Bay Repulse Bay
    Hong Kong
    AustralianCompany Secretary15482040003
    WILLIAMS, Stanley Killa
    White Raven
    Park Lane
    KT21 1EU Ashtead
    Surrey
    Director
    White Raven
    Park Lane
    KT21 1EU Ashtead
    Surrey
    EnglandBritishCompany Secretary & Solicitor34401400001
    WILSON, David John
    Flat 3 61 Cadogan Square
    SW1X 0HZ London
    Director
    Flat 3 61 Cadogan Square
    SW1X 0HZ London
    New ZealandDirector3788660001
    WITHERSMEAD HOLDINGS LIMITED
    Trading Estate
    GU9 9NY Farnham
    C/O Plascoat Systems Limited
    Surrey
    United Kingdom
    Director corporativo
    Trading Estate
    GU9 9NY Farnham
    C/O Plascoat Systems Limited
    Surrey
    United Kingdom
    Tipo de identificaciónEEE
    Número de registro01052543
    86903730001

    ¿Quiénes son las personas con control significativo de PLASCOAT HOLDINGS LIMITED?

    Personas con control significativo
    NombreNotificado elDirecciónCesado
    Axalta Coating Systems Uk Holding Ltd
    Mundells
    AL7 1FS Welwyn Garden City
    Unit 1 Quadrant Park
    Hertfordshire
    England
    14 ago 2017
    Mundells
    AL7 1FS Welwyn Garden City
    Unit 1 Quadrant Park
    Hertfordshire
    England
    Forma jurídicaLimited
    País de registroUnited Kingdom
    Autoridad legalCompnies Act 2006
    Lugar de registroEngland
    Número de registro8330148
    Naturaleza del control
    • La persona posee, directa o indirectamente, más del 75% de las acciones de la compañía.
    Plascoat Systems Limited
    Farnham Trading Estate
    GU9 9NY Farnham
    Trading Estate
    England
    14 ago 2017
    Farnham Trading Estate
    GU9 9NY Farnham
    Trading Estate
    England
    No
    Forma jurídicaLimited
    País de registroUk
    Autoridad legalCompanies Act 2006
    Lugar de registroCompanies House Uk
    Número de registro514584
    Naturaleza del control
    • La persona posee, directa o indirectamente, más del 75% de las acciones de la compañía.
    • La persona posee, directa o indirectamente, más del 75% de los derechos de voto en la empresa.
    • La persona tiene el derecho, directa o indirectamente, de nombrar o destituir a la mayoría de la junta directiva de la empresa.
    International Process Technologies Limited
    Farnham Trading Estate
    GU9 9NY Farnham
    Plot 14
    England
    06 abr 2016
    Farnham Trading Estate
    GU9 9NY Farnham
    Plot 14
    England
    Forma jurídicaCompany
    Autoridad legalCompanies Act
    Naturaleza del control
    • La persona posee, directa o indirectamente, más del 75% de las acciones de la compañía.

    ¿Tiene PLASCOAT HOLDINGS LIMITED alguna carga?

    Gravámenes
    ClasificaciónFechasEstadoDetalles
    A registered charge
    Creado el 22 jun 2018
    Entregado el 02 jul 2018
    Satisfecho en su totalidad
    La garantía flotante cubre todo:
    Contiene una promesa negativa:
    Contiene una garantía flotante:
    Personas con derecho
    • Barclays Bank PLC
    Transacciones
    • 02 jul 2018Registro de una carga (MR01)
    • 19 abr 2023Satisfacción de una carga (MR04)
    A registered charge
    Creado el 21 jun 2018
    Entregado el 04 jul 2018
    Pendiente
    La garantía flotante cubre todo:
    Contiene una promesa negativa:
    Contiene una garantía flotante:
    Personas con derecho
    • Barclays Bank PLC
    Transacciones
    • 04 jul 2018Registro de una carga (MR01)
    A registered charge
    Creado el 20 dic 2017
    Entregado el 03 ene 2018
    Pendiente
    Contiene una promesa negativa:
    Contiene una garantía fija:
    Personas con derecho
    • Barclays Bank PLC 1 Churchill Place, London E14 5HP
    Transacciones
    • 03 ene 2018Registro de una carga (MR01)
    A registered charge
    Creado el 20 dic 2017
    Entregado el 03 ene 2018
    Satisfecho en su totalidad
    Contiene una promesa negativa:
    Contiene una garantía flotante:
    Contiene una garantía fija:
    Personas con derecho
    • Barclays Bank PLC
    Transacciones
    • 03 ene 2018Registro de una carga (MR01)
    • 25 abr 2023Satisfacción de una carga (MR04)
    A registered charge
    Creado el 20 dic 2017
    Entregado el 02 ene 2018
    Satisfecho en su totalidad
    La garantía flotante cubre todo:
    Contiene una promesa negativa:
    Contiene una garantía flotante:
    Contiene una garantía fija:
    Personas con derecho
    • Barclays Bank PLC
    Transacciones
    • 02 ene 2018Registro de una carga (MR01)
    • 19 abr 2023Satisfacción de una carga (MR04)
    Agreement and deed of release and pledge of shares and negative pledge agreement
    Creado el 29 mar 1999
    Entregado el 07 abr 1999
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies and obligations (present, future, actual or contingent) due owing or incurred by international process technologies limited, plascoat international limited, plascoat UK limited, the company, plastic coatings europe bv and plascoat europe bv to the chargee from time to time
    Breve descripción
    All the issued shares in the share capital of plastic coatings europe bv consisting of three shares each with a par value of NLG1,000 and all rights to or under dividends bonus shares stock dividends. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transacciones
    • 07 abr 1999Registro de un cargo (395)
    • 18 ago 2017Satisfacción de una carga (MR04)
    Debenture
    Creado el 29 mar 1999
    Entregado el 07 abr 1999
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personas con derecho
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transacciones
    • 07 abr 1999Registro de un cargo (395)
    • 18 ago 2017Satisfacción de una carga (MR04)
    Guarantee and debenture
    Creado el 23 abr 1996
    Entregado el 02 may 1996
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All sums liabilities and obligations due or to become due from the company and/or any other group company to the chargees pursuant to the terms of the facilities agreement and/or any other senior finance document
    Breve descripción
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland as Security Trustee for the Beneficiaries (Asdefined)
    Transacciones
    • 02 may 1996Registro de un cargo (395)
    • 04 sept 1999Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Share pledge agreement
    Creado el 23 abr 1996
    Entregado el 02 may 1996
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All sums liabilities and obligations due or to become due from the company to the chargees pursuant to the terms of a facilities agreement of even date and/or the guarantee and debenture also of even date
    Breve descripción
    62,581 shares (the pledged shares ) having a nominal value of 100FF each which the pledgor fully owns in the share capital of sonabat chantal S.A. together with the proceeds of the pledged shares. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland as Agent and Security Trustee for the Beneficiaries (As Defined)
    Transacciones
    • 02 may 1996Registro de un cargo (395)
    • 04 sept 1999Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Share pledge agreement
    Creado el 23 abr 1996
    Entregado el 02 may 1996
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All sums liabilities and obligations due or to become due from the company to the chargees pursuant to the terms of a facilities agreement of even date and/or the guarantee and debenture of even date
    Breve descripción
    4793 shares (the pledged shares) having a nominal value of 100FF each which the pledgor fully owns in the share capital of plascot europe (france) S.A. together with the proceeds of the pledged shares. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland as Agent and Security Trustee for the Beneficiaries (As Defined)
    Transacciones
    • 02 may 1996Registro de un cargo (395)
    • 04 sept 1999Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Agreement and deed of pledge and negative pledge agreement (as defined)
    Creado el 23 abr 1996
    Entregado el 03 may 1996
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the senior finance documents (as defined)
    Breve descripción
    The shares and rights under under various sections of the agreement. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland,as Security Trustee
    Transacciones
    • 03 may 1996Registro de un cargo (395)
    • 04 sept 1999Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)

    Fuente de datos

    • Companies House del Reino Unido
      El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros.
    • Licencia: CC0