TT1 REALISATIONS LIMITED
Visión general
| Nombre de la empresa | TT1 REALISATIONS LIMITED |
|---|---|
| Estado de la empresa | En administración |
| Forma jurídica | Sociedad de responsabilidad limitada |
| Número de empresa | 00936239 |
| Jurisdicción | Inglaterra/Gales |
| Fecha de constitución |
Resumen
| Tiene PSCs súper seguros | No |
|---|---|
| Tiene gravámenes | No |
| Tiene historial de insolvencia | Sí |
| La sede social está en disputa | No |
¿Cuál es el propósito de TT1 REALISATIONS LIMITED?
- Fabricación de otros muebles n.c.p. (31090) / Industrias manufactureras
¿Dónde se encuentra TT1 REALISATIONS LIMITED?
| Dirección de la sede social | Pricewaterhousecoopers Llp 8th Floor, Central Square 29 Wellington Street LS1 4DL Leeds West Yorkshire |
|---|---|
| Dirección de la sede social no entregable | No |
¿Cuáles fueron los nombres anteriores de TT1 REALISATIONS LIMITED?
| Nombre de la empresa | Desde | Hasta |
|---|---|---|
| TETRAD LIMITED | 08 abr 2009 | 08 abr 2009 |
| TETRAD PLC | 03 may 1995 | 03 may 1995 |
| TETRAD ASSOCIATES PUBLIC LIMITED COMPANY | 30 dic 1987 | 30 dic 1987 |
| GIBSON COOPER LIMITED | 29 jul 1968 | 29 jul 1968 |
¿Cuáles son las últimas cuentas de TT1 REALISATIONS LIMITED?
| Vencido | Sí |
|---|---|
| Próximas cuentas | |
| Próximo período contable finaliza el | 31 dic 2024 |
| Próximas cuentas vencen el | 30 sept 2025 |
| Últimas cuentas | |
| Últimas cuentas cerradas hasta | 31 dic 2023 |
¿Cuál es el estado de la última declaración de confirmación para TT1 REALISATIONS LIMITED?
| Vencido | Sí |
|---|---|
| Última declaración de confirmación cerrada hasta | 31 oct 2025 |
| Próxima declaración de confirmación vence | 14 nov 2025 |
| Última declaración de confirmación | |
| Próxima declaración de confirmación cerrada hasta | 31 oct 2024 |
| Vencido | Sí |
¿Cuáles son las últimas presentaciones para TT1 REALISATIONS LIMITED?
| Fecha | Descripción | Documento | Tipo | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Informe de progreso del administrador | 57 páginas | AM10 | ||||||||||
Declaración de asuntos con el formulario AM02SOA | 8 páginas | AM02 | ||||||||||
Notificación de la aprobación presunta de las propuestas | 3 páginas | AM06 | ||||||||||
Domicilio social registrado cambiado de Hartford Mill Swan Street Preston Lancashire PR1 5PQ a Pricewaterhousecoopers Llp 8th Floor, Central Square 29 Wellington Street Leeds West Yorkshire LS1 4DL el 26 feb 2025 | 3 páginas | AD01 | ||||||||||
Declaración de la propuesta del administrador | 99 páginas | AM03 | ||||||||||
Nombramiento de un administrador | 3 páginas | AM01 | ||||||||||
Certificado de cambio de nombre Company name changed tetrad LIMITED\certificate issued on 20/02/25 | 3 páginas | CERTNM | ||||||||||
| ||||||||||||
| ||||||||||||
Cancelación total de la carga 8 | 4 páginas | MR04 | ||||||||||
Declaración de confirmación presentada el 31 oct 2024 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||||||||||
Cuentas completas preparadas hasta el 31 dic 2023 | 25 páginas | AA | ||||||||||
Registro de la carga 009362390030, creada el 08 ago 2024 | 72 páginas | MR01 | ||||||||||
Resoluciones Resolutions | 2 páginas | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Memorándum y Estatutos | 9 páginas | MA | ||||||||||
Registro de la carga 009362390029, creada el 05 mar 2024 | 21 páginas | MR01 | ||||||||||
Registro de la carga 009362390028, creada el 05 mar 2024 | 71 páginas | MR01 | ||||||||||
Cese del nombramiento de Stuart Christopher Masson como director el 30 ene 2024 | 1 páginas | TM01 | ||||||||||
Registro de la carga 009362390027, creada el 28 dic 2023 | 71 páginas | MR01 | ||||||||||
Cese del nombramiento de Rachael Rebecca Nevins como director el 09 oct 2023 | 1 páginas | TM01 | ||||||||||
Nombramiento de Thomas Graham Prestwich como director el 02 nov 2023 | 2 páginas | AP01 | ||||||||||
Cuentas completas preparadas hasta el 31 dic 2022 | 25 páginas | AA | ||||||||||
Declaración de confirmación presentada el 31 oct 2023 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||||||||||
Nombramiento de Mr Jon Stewart Sharrock como director el 14 sept 2023 | 2 páginas | AP01 | ||||||||||
Cese del nombramiento de John David Meltham como director el 23 dic 2022 | 1 páginas | TM01 | ||||||||||
Declaración de confirmación presentada el 31 oct 2022 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||||||||||
Nombramiento de Ms Rachael Rebecca Nevins como director el 24 oct 2022 | 2 páginas | AP01 | ||||||||||
¿Quiénes son los directivos de TT1 REALISATIONS LIMITED?
| Nombre | Nombrado el | Renunció el | Rol | Dirección | Identificación de la empresa | País de residencia | Nacionalidad | Fecha de nacimiento | Ocupación | Número |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FLETCHER, Christopher John | Director | 8th Floor, Central Square 29 Wellington Street LS1 4DL Leeds Pricewaterhousecoopers Llp West Yorkshire | England | British | 135851640001 | |||||
| PRESTWICH, Thomas Graham | Director | 8th Floor, Central Square 29 Wellington Street LS1 4DL Leeds Pricewaterhousecoopers Llp West Yorkshire | United Kingdom | British | 332261350001 | |||||
| SHARROCK, Jon Stewart | Director | 8th Floor, Central Square 29 Wellington Street LS1 4DL Leeds Pricewaterhousecoopers Llp West Yorkshire | England | British | 188390640001 | |||||
| KING, Catherine Margaret | Secretario | Conifers6 Highgate Avenue Fulwood PR2 8LL Preston | British | 35158250002 | ||||||
| LODGE, Carmel | Secretario | Hartford Mill Swan Street PR1 5PQ Preston Lancashire | British | 134598710001 | ||||||
| LOW, George Robert | Secretario | Westbrook Lodge 15 Main Road, Bolton Le Sands LA5 8DQ Carnforth Lancashire | English | 85000610001 | ||||||
| ALLAN-HARDING, Susan | Director | Swan Street PR1 5PQ Preston Hartford Mill England | United Kingdom | British | 183911590001 | |||||
| BORTHWICK, Iain Alexander | Director | Hartford Mill Swan Street PR1 5PQ Preston Lancashire | England | British | 181980960001 | |||||
| BURKE, Maurice Prentice | Director | Chalet Panorima Postfach 147 FOREIGN Ch-3780 Gstaad Switzerland | Canadian | 31133730001 | ||||||
| COOPER, Janus Robert | Director | Hartford Mill Swan Street PR1 5PQ Preston Lancashire | United Kingdom | British | 124673700001 | |||||
| COOPER, Michael James | Director | Hartford Mill Swan Street PR1 5PQ Preston Lancashire | England | British | 93343230001 | |||||
| COOPER, Robert Gerald | Director | Hartford Mill Swan Street PR1 5PQ Preston Lancashire | United Kingdom | British | 6126720004 | |||||
| EVANS, Grenville Alun | Director | 72 Camberley Drive OL11 4BA Rochdale Lancashire | England | British | 77471580001 | |||||
| GRIFFIN, Martin Edward | Director | Hartford Mill Swan Street PR1 5PQ Preston Lancashire | England | British | 20137790006 | |||||
| HAMPTON, Stephen Raymond | Director | Hartford Mill Swan Street PR1 5PQ Preston Lancashire | England | British | 127114430002 | |||||
| KING, Catherine Margaret | Director | Conifers6 Highgate Avenue Fulwood PR2 8LL Preston | England | British | 35158250002 | |||||
| KING, Laurence | Director | Conifers 6 Highgate Avenue Fulwood PR2 8LL Preston Lancashire | England | British | 51624810001 | |||||
| LANGAN, Fiona Jean | Director | Hartford Mill Swan Street PR1 5PQ Preston Lancashire | England | British | 160333500001 | |||||
| LASHAM, Gary | Director | Hartford Mill Swan Street PR1 5PQ Preston Lancashire | United Kingdom | British | 102512840002 | |||||
| LOW, George Robert | Director | Westbrook Lodge 15 Main Road, Bolton Le Sands LA5 8DQ Carnforth Lancashire | England | English | 85000610001 | |||||
| MASSON, Stuart Christopher | Director | Hartford Mill Swan Street PR1 5PQ Preston Lancashire | England | British | 243645430001 | |||||
| MELTHAM, John David | Director | Hartford Mill Swan Street PR1 5PQ Preston Lancashire | England | British | 257833640001 | |||||
| NEVINS, Rachael Rebecca | Director | Hartford Mill Swan Street PR1 5PQ Preston Lancashire | England | British | 177502610001 | |||||
| OTOOLE, Anthony Jeffrey | Director | 25 Arbour Street PR8 6SB Southport Merseyside | British | 26553960001 | ||||||
| PICKUP, Andrew David | Director | Hartford Mill Swan Street PR1 5PQ Preston Lancashire | England | English | 168397370001 | |||||
| SHERLIKER, Peter Francis | Director | Hartford Mill Swan Street PR1 5PQ Preston Lancashire | United Kingdom | British | 155519810001 | |||||
| STEVENS, Karl Ivor | Director | Hartford Mill Swan Street PR1 5PQ Preston Lancashire | England | British | 133771870001 | |||||
| WILLIAMS, John Albert | Director | 11 The Chase Leyland Preston Lancashire | England | British | 26729820002 |
¿Quiénes son las personas con control significativo de TT1 REALISATIONS LIMITED?
| Nombre | Notificado el | Dirección | Cesado | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Belfield Group Limited | 13 ago 2021 | Hallam Fields Road DE7 4AZ Ilkeston C/O Belfield Furnishings Limited England | No | ||||||||||
| |||||||||||||
Naturaleza del control
| |||||||||||||
| Belfield Furnishings Limited | 17 jul 2017 | Furnace Road DE7 5EP Ilkeston Site 3 England | Sí | ||||||||||
| |||||||||||||
Naturaleza del control
| |||||||||||||
| Mr Janus Robert Cooper | 06 abr 2016 | Hartford Mill Swan Street PR1 5PQ Preston Lancashire | Sí | ||||||||||
Nacionalidad: British País de residencia: United Kingdom | |||||||||||||
Naturaleza del control
| |||||||||||||
¿Tiene TT1 REALISATIONS LIMITED algún caso de insolvencia?
| Número de expediente | Fechas | Tipo | Profesionales | Otro | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
| En administración |
|
Fuente de datos
- Companies House del Reino Unido
El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros. - Licencia: CC0