CITY MOTORS (OXFORD) LIMITED
Visión general
Nombre de la empresa | CITY MOTORS (OXFORD) LIMITED |
---|---|
Estado de la empresa | Disuelta |
Forma jurídica | Sociedad de responsabilidad limitada |
Número de empresa | 00941979 |
Jurisdicción | Inglaterra/Gales |
Fecha de constitución | |
Fecha de cese |
Resumen
Tiene PSCs súper seguros | No |
---|---|
Tiene gravámenes | Sí |
Tiene historial de insolvencia | No |
La sede social está en disputa | No |
¿Cuál es el propósito de CITY MOTORS (OXFORD) LIMITED?
- Compañía no comercial (74990) / Actividades profesionales, científicas y técnicas
¿Dónde se encuentra CITY MOTORS (OXFORD) LIMITED?
Dirección de la sede social | 770 The Crescent Colchester Business Park CO4 9YQ Colchester Essex |
---|---|
Dirección de la sede social no entregable | No |
¿Cuáles son las últimas cuentas de CITY MOTORS (OXFORD) LIMITED?
Últimas cuentas | |
---|---|
Últimas cuentas cerradas hasta | 31 dic 2018 |
¿Cuáles son las últimas presentaciones para CITY MOTORS (OXFORD) LIMITED?
Fecha | Descripción | Documento | Tipo | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Boletín oficial final disuelto por cancelación voluntaria | 1 páginas | GAZ2(A) | ||||||||||||||
Primer aviso en el boletín oficial para la cancelación voluntaria | 1 páginas | GAZ1(A) | ||||||||||||||
Solicitud de exclusión de la empresa del registro | 3 páginas | DS01 | ||||||||||||||
legacy | 1 páginas | SH20 | ||||||||||||||
Estado de capital el 29 jul 2020
| 3 páginas | SH19 | ||||||||||||||
legacy | 1 páginas | CAP-SS | ||||||||||||||
Resoluciones Resolutions | 3 páginas | RESOLUTIONS | ||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Declaración de confirmación presentada el 01 jun 2020 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||||||||||||||
legacy | 49 páginas | PARENT_ACC | ||||||||||||||
legacy | 3 páginas | AGREEMENT1 | ||||||||||||||
legacy | 3 páginas | GUARANTEE1 | ||||||||||||||
Declaración de confirmación presentada el 01 jun 2019 con actualizaciones | 4 páginas | CS01 | ||||||||||||||
Cese del nombramiento de Matthew Bishop como director el 01 ene 2019 | 1 páginas | TM01 | ||||||||||||||
Nombramiento de Mr David John Muir como director el 01 ene 2019 | 2 páginas | AP01 | ||||||||||||||
legacy | 3 páginas | AGREEMENT1 | ||||||||||||||
legacy | 3 páginas | GUARANTEE1 | ||||||||||||||
legacy | 44 páginas | PARENT_ACC | ||||||||||||||
Declaración de confirmación presentada el 01 jun 2018 con actualizaciones | 4 páginas | CS01 | ||||||||||||||
legacy | 3 páginas | AGREEMENT1 | ||||||||||||||
legacy | 49 páginas | PARENT_ACC | ||||||||||||||
legacy | 3 páginas | GUARANTEE1 | ||||||||||||||
Declaración de confirmación presentada el 01 jun 2017 con actualizaciones | 5 páginas | CS01 | ||||||||||||||
legacy | 51 páginas | PARENT_ACC | ||||||||||||||
legacy | 3 páginas | AGREEMENT1 | ||||||||||||||
legacy | 3 páginas | GUARANTEE1 | ||||||||||||||
¿Quiénes son los directivos de CITY MOTORS (OXFORD) LIMITED?
Nombre | Nombrado el | Renunció el | Rol | Dirección | Identificación de la empresa | País de residencia | Nacionalidad | Fecha de nacimiento | Ocupación | Número |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FINCH, Mark | Secretario | The Crescent Colchester Business Park CO4 9YQ Colchester 770 Essex United Kingdom | 175639860001 | |||||||
FINCH, Mark Charles | Director | The Crescent Colchester Business Park CO4 9YQ Colchester 770 Essex United Kingdom | United Kingdom | British | Company Secretary | 175612870001 | ||||
MUIR, David John | Director | The Crescent Colchester Business Park CO4 9YQ Colchester 770 Essex United Kingdom | England | British | Company Director | 254017640001 | ||||
MACNAMARA, Richard James | Secretario | The Crescent Colchester Business Park CO4 9YQ Colchester 770 Essex United Kingdom | 149297140001 | |||||||
WARD, Andrew Ian | Secretario | 6 Coniston Way LS22 6TT Wetherby West Yorkshire | British | 360770001 | ||||||
WATSON, Deirdre Mary Alison | Secretario | 51 Park Avenue Hutton CM13 2QP Brentwood Essex | Uk | 74385360001 | ||||||
MATHESON & CO LIMITED | Secretario corporativo | 3 Lombard Street EC3V 9AQ London | 1947590001 | |||||||
ATKIN, John Richard | Director | Baillie Gate Queens Drive LS29 9QW Ilkley West Yorkshire | British | Financial Director | 20102900001 | |||||
BEATTIE, Craig Alan | Director | The Crescent Colchester Business Park CO4 9YQ Colchester 770 Essex United Kingdom | United Kingdom | British | Company Director | 177627900001 | ||||
BEYNON, Peter | Director | Stonehurst Elm Lane Copdock IP8 3ET Ipswich Suffolk | England | British | Group Finance Director | 38504390006 | ||||
BISHOP, Matthew | Director | The Crescent Colchester Business Park CO4 9YQ Colchester 770 Essex United Kingdom | United Kingdom | British | Company Director | 206755450002 | ||||
CHAMBERS, Paul Jonathan | Director | 24 Constable Road Ben Rhydding LS29 8RW Ilkley West Yorkshire | British | Finance Director | 1188140001 | |||||
HERBERT, Mark Philip | Director | The Crescent Colchester Business Park CO4 9YQ Colchester 770 Essex United Kingdom | England | British | Company Director | 123285980005 | ||||
HOUSTON, Samuel George | Director | Flat 59 Medland House 11 Branch Road E14 7JT London | British | Finance Director | 75730290003 | |||||
JONES, Alun Morton | Director | Fen Walk IP12 4BG Woodbridge Fen House Suffolk United Kingdom | United Kingdom | British | Director | 12785600004 | ||||
MACNAMARA, Richard James | Director | The Crescent Colchester Business Park CO4 9YQ Colchester 770 Essex United Kingdom | United Kingdom | British | Company Secretary | 149294820002 | ||||
POTTS, Derek | Director | 55 East Street Coggeshall CO6 1SJ Colchester Essex | United Kingdom | British | Finance Director | 52485510001 | ||||
RITCHIE, John Muir | Director | High House Snipe Farm Road IP13 6SL Clopton Suffolk | British | Director | 22325820001 | |||||
WATSON, Deirdre Mary Alison | Director | 51 Park Avenue Hutton CM13 2QP Brentwood Essex | England | Uk | Company Secretary | 74385360001 | ||||
WILLIAMS, Steven Wyn | Director | 199 Finchampstead Road RG40 3HE Wokingham Berkshire | United Kingdom | British | Company Director | 54580940001 | ||||
WILLIAMSON, Michael Granville | Director | Church Green Old Church Lane Pateley Bridge HG3 5LZ Harrogate North Yorkshire | British | Chairman & Chief Executive | 57360160001 | |||||
WITT, John Raymond | Director | 28 Westerfield Road IP4 2YJ Ipswich Suffolk | Canadian | Finance Director | 51303670001 |
¿Quiénes son las personas con control significativo de CITY MOTORS (OXFORD) LIMITED?
Nombre | Notificado el | Dirección | Cesado | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Appleyard Group Limited | 06 abr 2016 | The Crescent Colchester Business Park CO4 9YQ Colchester 770 Essex United Kingdom | No | ||||||||||
| |||||||||||||
Naturaleza del control
|
¿Tiene CITY MOTORS (OXFORD) LIMITED alguna carga?
Clasificación | Fechas | Estado | Detalles | |
---|---|---|---|---|
Deed of charge | Creado el 17 may 1985 Entregado el 30 may 1985 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Breve descripción All book & other debts due or owing to the company please see doc M23. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
Charge | Creado el 11 abr 1983 Entregado el 20 abr 1983 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Breve descripción All the debts or sums of money hereafter owing to the company in respect of the sale of new motor vehicles the acquistion of which will be financed by the chargee & which will become the subject of a delayed payment privilege agreement together with all increases additions & rights relating thereto. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
|
Fuente de datos
- Companies House del Reino Unido
El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros. - Licencia: CC0