MCA WEST MIDLANDS LIMITED
Visión general
| Nombre de la empresa | MCA WEST MIDLANDS LIMITED |
|---|---|
| Estado de la empresa | Activa |
| Forma jurídica | Sociedad de responsabilidad limitada |
| Número de empresa | 00942513 |
| Jurisdicción | Inglaterra/Gales |
| Fecha de constitución |
Resumen
| Tiene PSCs súper seguros | No |
|---|---|
| Tiene gravámenes | No |
| Tiene historial de insolvencia | No |
| La sede social está en disputa | No |
¿Cuál es el propósito de MCA WEST MIDLANDS LIMITED?
- Empresa inactiva (99999) / Actividades de organizaciones y organismos extraterritoriales
¿Dónde se encuentra MCA WEST MIDLANDS LIMITED?
| Dirección de la sede social | Gate House Turnpike Road HP12 3NR High Wycombe Buckinghamshire |
|---|---|
| Dirección de la sede social no entregable | No |
¿Cuáles fueron los nombres anteriores de MCA WEST MIDLANDS LIMITED?
| Nombre de la empresa | Desde | Hasta |
|---|---|---|
| ALFRED MCALPINE HOMES WEST MIDLANDS LIMITED | 30 mar 2000 | 30 mar 2000 |
| ALFRED MCALPINE HOMES MIDLANDS LIMITED | 01 mar 1989 | 01 mar 1989 |
| CANBERRA DEVELOPMENTS LIMITED | 18 nov 1968 | 18 nov 1968 |
¿Cuáles son las últimas cuentas de MCA WEST MIDLANDS LIMITED?
| Vencido | No |
|---|---|
| Próximas cuentas | |
| Próximo período contable finaliza el | 31 dic 2025 |
| Próximas cuentas vencen el | 30 sept 2026 |
| Últimas cuentas | |
| Últimas cuentas cerradas hasta | 31 dic 2024 |
¿Cuál es el estado de la última declaración de confirmación para MCA WEST MIDLANDS LIMITED?
| Última declaración de confirmación cerrada hasta | 03 nov 2026 |
|---|---|
| Próxima declaración de confirmación vence | 17 nov 2026 |
| Última declaración de confirmación | |
| Próxima declaración de confirmación cerrada hasta | 03 nov 2025 |
| Vencido | No |
¿Cuáles son las últimas presentaciones para MCA WEST MIDLANDS LIMITED?
| Fecha | Descripción | Documento | Tipo | |
|---|---|---|---|---|
Declaración de confirmación presentada el 03 nov 2025 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||
Cese del nombramiento de Jennifer Canty como director el 30 sept 2025 | 1 páginas | TM01 | ||
Nombramiento de Sara Hollowell como director el 01 oct 2025 | 2 páginas | AP01 | ||
Cese del nombramiento de Jennifer Canty como secretario el 30 sept 2025 | 1 páginas | TM02 | ||
Nombramiento de Sara Hollowell como secretario el 01 oct 2025 | 2 páginas | AP03 | ||
Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 31 dic 2024 | 5 páginas | AA | ||
Cese del nombramiento de Michael Andrew Lonnon como director el 09 dic 2024 | 1 páginas | TM01 | ||
Nombramiento de Miss Katherine Elizabeth Hindmarsh como director el 09 dic 2024 | 2 páginas | AP01 | ||
Declaración de confirmación presentada el 03 nov 2024 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||
Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 31 dic 2023 | 5 páginas | AA | ||
Cese del nombramiento de Omolola Olutomilayo Adedoyin como director el 24 abr 2024 | 1 páginas | TM01 | ||
Nombramiento de Jennifer Canty como secretario el 24 abr 2024 | 2 páginas | AP03 | ||
Nombramiento de Jennifer Canty como director el 24 abr 2024 | 2 páginas | AP01 | ||
Cese del nombramiento de Omolola Olutomilayo Adedoyin como secretario el 24 abr 2024 | 1 páginas | TM02 | ||
Declaración de confirmación presentada el 03 nov 2023 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||
Nombramiento de Mrs Omolola Olutomilayo Adedoyin como director el 09 oct 2023 | 2 páginas | AP01 | ||
Cese del nombramiento de Katherine Elizabeth Hindmarsh como director el 09 oct 2023 | 1 páginas | TM01 | ||
Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 31 dic 2022 | 5 páginas | AA | ||
Cese del nombramiento de Katherine Elizabeth Hindmarsh como secretario el 07 jul 2023 | 1 páginas | TM02 | ||
Nombramiento de Mrs Omolola Olutomilayo Adedoyin como secretario el 07 jul 2023 | 2 páginas | AP03 | ||
Declaración de confirmación presentada el 03 nov 2022 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||
Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 31 dic 2021 | 5 páginas | AA | ||
Declaración de confirmación presentada el 08 nov 2021 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||
Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 31 dic 2020 | 5 páginas | AA | ||
Los registros se han trasladado a la ubicación de inspección registrada Highdown House Yeoman Way Worthing West Sussex BN99 3HH | 1 páginas | AD03 | ||
¿Quiénes son los directivos de MCA WEST MIDLANDS LIMITED?
| Nombre | Nombrado el | Renunció el | Rol | Dirección | Identificación de la empresa | País de residencia | Nacionalidad | Fecha de nacimiento | Ocupación | Número |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HOLLOWELL, Sara | Secretario | Turnpike Road HP12 3NR High Wycombe Gate House Buckinghamshire | 340977420001 | |||||||
| HINDMARSH, Katherine Elizabeth | Director | Turnpike Road HP12 3NR High Wycombe Gate House Buckinghamshire United Kingdom | United Kingdom | British | 330353690001 | |||||
| HOLLOWELL, Sara | Director | Turnpike Road HP12 3NR High Wycombe Gate House Buckinghamshire | United Kingdom | British | 200486170001 | |||||
| ADEDOYIN, Omolola Olutomilayo | Secretario | Turnpike Road HP12 3 NR High Wycombe Gate House Bucks United Kingdom | 311164460001 | |||||||
| ANSELL, Richard David | Secretario | 4 Cassandra Grove Heathcote CV34 6XD Warwick Warwickshire | British | 63526180001 | ||||||
| ATTERBURY, Karen Lorraine | Secretario | Chestnut Drive HP4 2JL Berkhamsted 11 Hertfordshire United Kingdom | British | 175715660001 | ||||||
| CANTY, Jennifer | Secretario | Turnpike Road HP12 3NR High Wycombe Gate House Buckinghamshire | 322325900001 | |||||||
| CARR, Peter Anthony | Secretario | South Luffenham LE15 8NP Rutland Foxfoot House | British | 130306120001 | ||||||
| CLAPHAM, Colin Richard | Secretario | Turnpike Road HP12 3NR High Wycombe Gate House Buckinghamshire United Kingdom | 147316560001 | |||||||
| HASTIE, Nicola Amanda Eleanor | Secretario | 97 Yew Tree Lane Tettenhall WV6 8UN Wolverhampton | British | 76844970003 | ||||||
| HINDMARSH, Katherine Elizabeth | Secretario | Turnpike Road HP12 3NR High Wycombe Gate House Buckinghamshire United Kingdom | 219951550001 | |||||||
| JORDAN, James John | Secretario | Grosvenor House 2 Church Lane NN6 6JP Stanford On Avon Northamptonshire | British | 120602100002 | ||||||
| PHILLIPS, James | Secretario | Stallworth 6 Wood Road Tettenhall WV6 8LS Wolverhampton West Midlands | British | 8364990001 | ||||||
| ADEDOYIN, Omolola Olutomilayo | Director | Turnpike Road HP12 3 NR High Wycombe Gate House Bucks United Kingdom | England | British | 193735640001 | |||||
| ANDREW, Peter Robert | Director | Turnpike Road HP12 3NR High Wycombe Gate House Buckinghamshire United Kingdom | England | British | 113503830003 | |||||
| ANSELL, Richard David | Director | 4 Cassandra Grove Heathcote CV34 6XD Warwick Warwickshire | British | 63526180001 | ||||||
| BASSETT, Brian John | Director | The Pipings Dorsington Lane Pebworth Worcestershire | British | 34075530001 | ||||||
| BEASLEY, Andrew Timothy | Director | Bryancroft 25 Dartmouth Road WS11 1HD Cannock Staffordshire | British | 13970380002 | ||||||
| BERTRAM, Helen Margaret | Director | The Pumphouse Shepley Road, Barnt Green B45 8JW Birmingham West Midlands | British | 60576110006 | ||||||
| BRADY, Clive Paul | Director | Escola Main Road Peopleton WR10 2EA Pershore Worcestershire | British | 57169980003 | ||||||
| BURROWS, Simon Robert | Director | Micheldelving Davey Lane SK9 7NZ Alderley Edge Cheshire | United Kingdom | British | 82259550001 | |||||
| CANTY, Jennifer | Director | Turnpike Road HP12 3NR High Wycombe Gate House Buckinghamshire | United Kingdom | British | 322288120001 | |||||
| CARNEY, Christopher | Director | Turnpike Road HP12 3NR High Wycombe Gate House Buckinghamshire United Kingdom | United Kingdom | British | 125216670001 | |||||
| CARR, Peter Anthony | Director | 551 Avebury Boulevard MK9 3DR Milton Keynes Beech House Buckinghamshire England | England | British | 130306120001 | |||||
| CLAPHAM, Colin Richard | Director | Turnpike Road HP12 3NR High Wycombe Gate House Buckinghamshire United Kingdom | United Kingdom | British | 9684390001 | |||||
| CLARK, John Thomas | Director | 12 Grazing Lane Webeath B97 5PE Redditch Worcestershire | British | 45293300001 | ||||||
| CURRY, Nigel Derek | Director | 6 Wolds End Close GL55 6JW Chipping Camden Gloucestershire | British | 8897820003 | ||||||
| CUSHEN, Keith Morgan | Director | Buddleia Cottage High Street TW12 2SX Hampton Middlesex | British | 37763770002 | ||||||
| DAVIES, Peter John Frank | Director | 50 Rodney Road B92 8RZ Solihull West Midlands | British | 29045800001 | ||||||
| DURLING, David Daisley | Director | 33 Hartwell Close B91 3YP Solihull West Midlands | British | 9775020001 | ||||||
| DZICZKANIECE, Joseph Victor | Director | Stileway Gretton Fields, Gretton GL54 5HJ Cheltenham Gloucestershire | British | 81239190001 | ||||||
| EDMONDSON, Thomas Christopher | Director | Mill Lane Cottage Mill Lane Riseley RG7 1XU Reading Berkshire | British | 44493580001 | ||||||
| FLOWER, Terry Victor | Director | 30 Apsley Grove Dorridge B93 8QP Solihull West Midlands | United Kingdom | British | 75464950001 | |||||
| GROVE, Eric William | Director | The Rye House Catesby Lane Lapworth B94 5QY Solihull West Midlands | England | British | 632880001 | |||||
| GROVE, Lawrence Russell | Director | Park Corner Chadwick Lane Chadwick End B93 0AR Knowle West Midlands | British | 9775040001 |
¿Quiénes son las personas con control significativo de MCA WEST MIDLANDS LIMITED?
| Nombre | Notificado el | Dirección | Cesado | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mca Holdings Limited | 06 abr 2016 | Turnpike Road HP12 3NR High Wycombe Gate House Buckinghamshire United Kingdom | No | ||||||||||
| |||||||||||||
Naturaleza del control
| |||||||||||||
Fuente de datos
- Companies House del Reino Unido
El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros. - Licencia: CC0