ONE LONGRIDGE HOLDINGS
Visión general
Nombre de la empresa | ONE LONGRIDGE HOLDINGS |
---|---|
Estado de la empresa | Disuelta |
Forma jurídica | Sociedad privada sin límite de capital |
Número de empresa | 00953966 |
Jurisdicción | Inglaterra/Gales |
Fecha de constitución | |
Fecha de cese |
Resumen
Tiene PSCs súper seguros | No |
---|---|
Tiene gravámenes | Sí |
Tiene historial de insolvencia | No |
La sede social está en disputa | No |
¿Cuál es el propósito de ONE LONGRIDGE HOLDINGS?
- Compañía no comercial (74990) / Actividades profesionales, científicas y técnicas
¿Dónde se encuentra ONE LONGRIDGE HOLDINGS?
Dirección de la sede social | 5 Aldermanbury Square 13th Floor EC2V 7HR London |
---|---|
Dirección de la sede social no entregable | No |
¿Cuáles fueron los nombres anteriores de ONE LONGRIDGE HOLDINGS?
Nombre de la empresa | Desde | Hasta |
---|---|---|
JAMES BRIGGS HOLDINGS | 11 ene 2005 | 11 ene 2005 |
JAMES BRIGGS | 21 abr 1987 | 21 abr 1987 |
JAMES BRIGGS & SONS LIMITED | 12 may 1969 | 12 may 1969 |
¿Cuáles son las últimas cuentas de ONE LONGRIDGE HOLDINGS?
Últimas cuentas | |
---|---|
Últimas cuentas cerradas hasta | 31 dic 2013 |
¿Cuál es el estado de la última declaración anual para ONE LONGRIDGE HOLDINGS?
Declaración anual |
|
---|
¿Cuáles son las últimas presentaciones para ONE LONGRIDGE HOLDINGS?
Fecha | Descripción | Documento | Tipo | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Boletín oficial final disuelto por cancelación voluntaria | 1 páginas | GAZ2(A) | ||||||||||
Cambio de datos del director Edward Ufland el 21 jun 2010 | 2 páginas | CH01 | ||||||||||
Cambio de datos del director Philip Matthew Deakin el 19 ago 2015 | 2 páginas | CH01 | ||||||||||
Primer aviso en el boletín oficial para la cancelación voluntaria | 1 páginas | GAZ1(A) | ||||||||||
Déclaration annuelle établie au 24 ago 2015 avec liste complète des actionnaires | 4 páginas | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Cambio de datos del secretario S & J Registrars Limited el 01 may 2015 | 1 páginas | CH04 | ||||||||||
Solicitud de exclusión de la empresa del registro | 3 páginas | DS01 | ||||||||||
Domicilio social registrado cambiado de 99 Gresham Street London EC2V 7NG a 5 Aldermanbury Square 13Th Floor London EC2V 7HR el 04 may 2015 | 1 páginas | AD01 | ||||||||||
Déclaration annuelle établie au 24 ago 2014 avec liste complète des actionnaires | 4 páginas | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Cuentas completas preparadas hasta el 31 dic 2013 | 13 páginas | AA | ||||||||||
Déclaration annuelle établie au 24 ago 2013 avec liste complète des actionnaires | 4 páginas | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Certificado de cambio de nombre Company name changed james briggs holdings\certificate issued on 28/06/13 | 3 páginas | CERTNM | ||||||||||
| ||||||||||||
Aviso de cambio de nombre | 2 páginas | CONNOT | ||||||||||
Cese del nombramiento de Ola Barreto-Morley como director | 1 páginas | TM01 | ||||||||||
Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 31 dic 2012 | 3 páginas | AA | ||||||||||
Déclaration annuelle établie au 24 ago 2012 avec liste complète des actionnaires | 5 páginas | AR01 | ||||||||||
Cambio de datos del director Mr Giles Matthew Hudson el 21 may 2012 | 2 páginas | CH01 | ||||||||||
Cuentas completas preparadas hasta el 31 dic 2011 | 12 páginas | AA | ||||||||||
Exercice comptable en cours prolongé du 30 nov 2011 au 31 dic 2011 | 1 páginas | AA01 | ||||||||||
Déclaration annuelle établie au 24 ago 2011 avec liste complète des actionnaires | 5 páginas | AR01 | ||||||||||
Cambio de datos del director Philip Matthew Deakin el 01 oct 2009 | 2 páginas | CH01 | ||||||||||
Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 30 nov 2010 | 3 páginas | AA | ||||||||||
Déclaration annuelle établie au 24 ago 2010 avec liste complète des actionnaires | 5 páginas | AR01 | ||||||||||
Cambio de datos del director Edward Ufland el 01 oct 2009 | 2 páginas | CH01 | ||||||||||
Cambio de datos del director Giles Hudson el 01 oct 2009 | 2 páginas | CH01 | ||||||||||
¿Quiénes son los directivos de ONE LONGRIDGE HOLDINGS?
Nombre | Nombrado el | Renunció el | Rol | Dirección | Identificación de la empresa | País de residencia | Nacionalidad | Fecha de nacimiento | Ocupación | Número | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S & J REGISTRARS LIMITED | Secretario corporativo | Aldermanbury Square 13th Floor EC2V 7HR London 5 England |
| 43122090005 | ||||||||||
DEAKIN, Philip Matthew | Director | Aldermanbury Square 13th Floor EC2V 7HR London 5 England | United Kingdom | British | Chartered Accountant | 146225080003 | ||||||||
HUDSON, Giles Matthew | Director | Aldermanbury Square 13th Floor EC2V 7HR London 5 England | United Kingdom | British | Chartered Accountant | 161583790003 | ||||||||
UFLAND, Edward | Director | Aldermanbury Square 13th Floor EC2V 7HR London 5 England | England | British | Chartered Accountant | 161583570001 | ||||||||
EDWARDS, Norman Taylor | Secretario | 29 Ambleside Road L18 9XT Allerton Liverpool | British | 6790170002 | ||||||||||
GOULD, Gerard | Secretario | 17 Enville Road WA14 2PF Bowdon Cheshire | British | Finance Director | 85192980003 | |||||||||
ANTROBUS, Anita Louise | Director | Orchard House Elcho Road Bowdon WA14 2TL Altrincham Cheshire | English | Company Director | 6790190001 | |||||||||
ANTROBUS, David Lowden | Director | Spring Cottage Wellbank Lane Over Peover WA16 8UN Knutsford Cheshire | England | British | Company Director | 7393710001 | ||||||||
ANTROBUS, Keith Philip | Director | Orchard House Elcho Road Bowdon WA14 2TL Altrincham Cheshire | British | Company Director | 23858680001 | |||||||||
BARRETO-MORLEY, Ola Tricia Aramita | Director | 99 Gresham Street London EC2V 7NG | United Kingdom | British | Tax Manager | 140644240001 | ||||||||
BARRY, Peter | Director | Slack Farm Grains Road OL1 4SS Oldham Lancashire | United Kingdom | British | Managing Director | 125580450003 | ||||||||
EDWARDS, Norman Taylor | Director | 29 Ambleside Road L18 9XT Allerton Liverpool | British | Financial Director | 6790170002 | |||||||||
FAIRMAN, Michael John | Director | 14 Hillcrest Road Offerton SK2 5QL Stockport Cheshire | British | Company Director | 75414410001 | |||||||||
GOULD, Gerard | Director | 17 Enville Road WA14 2PF Bowdon Cheshire | British | Finance Director | 85192980003 | |||||||||
LYTH, Mark Anthony | Director | Mercer Crescent Haslingden BB4 4JJ Rossendale 2 Lancashire United Kingdom | England | British | Director | 140783010001 | ||||||||
MOYLE, Paul Garry | Director | 30 Hauxley Drive DH2 3TE Chester Le Street County Durham | British | Director | 78385370001 | |||||||||
MURIE, Roger James | Director | 24 Cropredy Close Queensbury BD13 1QY Bradford West Yorkshire | England | British | Sales Director | 110452590001 | ||||||||
SEAGER, William | Director | 18 Strain Avenue Brackley M9 6PS Manchester | British | Production Director | 44871880001 | |||||||||
UDALL, Gavin | Director | Summer Lodge Romsey Road, Whiteparish SP5 2SD Salisbury Wiltshire | United Kingdom | British | Accountant | 83889580001 |
¿Tiene ONE LONGRIDGE HOLDINGS alguna carga?
Clasificación | Fechas | Estado | Detalles | |
---|---|---|---|---|
Charge | Creado el 29 jul 2002 Entregado el 30 jul 2002 | Pendiente | Cantidad garantizada All monies due or to become due from the company to the chargee | |
Breve descripción By way of specific charge all uncalled capital and present and future freehold and leasehold property. All present and future book debts together with the benefit of all contracts and engagements. By way of floating security all the undertaking and goodwill and all property assets and rights whatsoever. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
Mortgage | Creado el 23 ene 2002 Entregado el 25 ene 2002 | Pendiente | Cantidad garantizada All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Breve descripción One krupp feeder and duplex slitter s/n 0085 together with all accessories and component parts and all improvements and renewals thereof together also with all books manuals handbooks technical data drawings schedules and other documentation. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
Mortgage | Creado el 18 jul 2001 Entregado el 20 jul 2001 | Pendiente | Cantidad garantizada £250,000 and all other monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Breve descripción One aerosol can line comprising bliss duplex slitter type 5225A, aoudronic welder ABM150/20 s/n M1427, water chiller tae 051..together with all accessories parts handbooks etc (for full details of further properties charged please refer to form 395). see the mortgage charge document for full details. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
Composite guarantee and debenture | Creado el 28 ago 1998 Entregado el 16 sept 1998 | Pendiente | Cantidad garantizada All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever | |
Breve descripción Freehold land and buildings on the west side of higginshaw lane royton oldham t/n GM401711, freehold land on the south side of salmon fields royton oldham t/n GM580375, freehold land on the west side of rudding street royton oldham t/n GM590501 and leasehold land and buildings on the south side of foxdenton lane chadderton oldham t/n GM679747. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
Legal charge | Creado el 28 ago 1998 Entregado el 16 sept 1998 | Pendiente | Cantidad garantizada All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Breve descripción F/H land and buildings on the west side of higginshaw lane royton oldham t/n GM401711 the f/h land on the south side of salmon fields royton oldham t/n GM580375 and f/h land on the west side of rudding street royton oldham t/n GM590501. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
Debenture | Creado el 24 feb 1988 Entregado el 29 feb 1988 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Breve descripción (Including heritable property & assets in scotland).. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
Legal charge | Creado el 30 ene 1986 Entregado el 06 feb 1986 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Breve descripción Land and buildings on the south and west sides of springfield street, royton, oldham, geater manchester. Title no: la 202266. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
|
Fuente de datos
- Companies House del Reino Unido
El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros. - Licencia: CC0