ONE LONGRIDGE HOLDINGS

ONE LONGRIDGE HOLDINGS

  • Visión general
  • Resumen
  • Propósito
  • Dirección
  • Nombres anteriores
  • Cuentas
  • Declaración anual
  • Presentaciones
  • Directivos
  • Gravámenes
  • Fuente de datos
  • Visión general

    Nombre de la empresaONE LONGRIDGE HOLDINGS
    Estado de la empresaDisuelta
    Forma jurídicaSociedad privada sin límite de capital
    Número de empresa 00953966
    JurisdicciónInglaterra/Gales
    Fecha de constitución
    Fecha de cese

    Resumen

    Tiene PSCs súper segurosNo
    Tiene gravámenes
    Tiene historial de insolvenciaNo
    La sede social está en disputaNo

    ¿Cuál es el propósito de ONE LONGRIDGE HOLDINGS?

    • Compañía no comercial (74990) / Actividades profesionales, científicas y técnicas

    ¿Dónde se encuentra ONE LONGRIDGE HOLDINGS?

    Dirección de la sede social
    5 Aldermanbury Square
    13th Floor
    EC2V 7HR London
    Dirección de la sede social no entregableNo

    ¿Cuáles fueron los nombres anteriores de ONE LONGRIDGE HOLDINGS?

    Nombres anteriores de la empresa
    Nombre de la empresaDesdeHasta
    JAMES BRIGGS HOLDINGS11 ene 200511 ene 2005
    JAMES BRIGGS21 abr 198721 abr 1987
    JAMES BRIGGS & SONS LIMITED12 may 196912 may 1969

    ¿Cuáles son las últimas cuentas de ONE LONGRIDGE HOLDINGS?

    Últimas cuentas
    Últimas cuentas cerradas hasta31 dic 2013

    ¿Cuál es el estado de la última declaración anual para ONE LONGRIDGE HOLDINGS?

    Declaración anual
    Última declaración anual

    ¿Cuáles son las últimas presentaciones para ONE LONGRIDGE HOLDINGS?

    Presentaciones
    FechaDescripciónDocumentoTipo

    Boletín oficial final disuelto por cancelación voluntaria

    1 páginasGAZ2(A)

    Cambio de datos del director Edward Ufland el 21 jun 2010

    2 páginasCH01

    Cambio de datos del director Philip Matthew Deakin el 19 ago 2015

    2 páginasCH01

    Primer aviso en el boletín oficial para la cancelación voluntaria

    1 páginasGAZ1(A)

    Déclaration annuelle établie au 24 ago 2015 avec liste complète des actionnaires

    4 páginasAR01
    Presentaciones asociadas
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    capital02 nov 2015

    Estado de capital el 02 nov 2015

    • Capital: GBP .02
    SH01

    Cambio de datos del secretario S & J Registrars Limited el 01 may 2015

    1 páginasCH04

    Solicitud de exclusión de la empresa del registro

    3 páginasDS01

    Domicilio social registrado cambiado de 99 Gresham Street London EC2V 7NG a 5 Aldermanbury Square 13Th Floor London EC2V 7HR el 04 may 2015

    1 páginasAD01

    Déclaration annuelle établie au 24 ago 2014 avec liste complète des actionnaires

    4 páginasAR01
    Presentaciones asociadas
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    capital02 sept 2014

    Estado de capital el 02 sept 2014

    • Capital: GBP .02
    SH01

    Cuentas completas preparadas hasta el 31 dic 2013

    13 páginasAA

    Déclaration annuelle établie au 24 ago 2013 avec liste complète des actionnaires

    4 páginasAR01
    Presentaciones asociadas
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    capital29 ago 2013

    Estado de capital el 29 ago 2013

    • Capital: GBP .02
    SH01

    Certificado de cambio de nombre

    Company name changed james briggs holdings\certificate issued on 28/06/13
    3 páginasCERTNM
    Presentaciones asociadas
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    change-of-name28 jun 2013

    Resolución de cambio de nombre de la empresa el 25 jun 2013

    RES15

    Aviso de cambio de nombre

    2 páginasCONNOT

    Cese del nombramiento de Ola Barreto-Morley como director

    1 páginasTM01

    Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 31 dic 2012

    3 páginasAA

    Déclaration annuelle établie au 24 ago 2012 avec liste complète des actionnaires

    5 páginasAR01

    Cambio de datos del director Mr Giles Matthew Hudson el 21 may 2012

    2 páginasCH01

    Cuentas completas preparadas hasta el 31 dic 2011

    12 páginasAA

    Exercice comptable en cours prolongé du 30 nov 2011 au 31 dic 2011

    1 páginasAA01

    Déclaration annuelle établie au 24 ago 2011 avec liste complète des actionnaires

    5 páginasAR01

    Cambio de datos del director Philip Matthew Deakin el 01 oct 2009

    2 páginasCH01

    Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 30 nov 2010

    3 páginasAA

    Déclaration annuelle établie au 24 ago 2010 avec liste complète des actionnaires

    5 páginasAR01

    Cambio de datos del director Edward Ufland el 01 oct 2009

    2 páginasCH01

    Cambio de datos del director Giles Hudson el 01 oct 2009

    2 páginasCH01

    ¿Quiénes son los directivos de ONE LONGRIDGE HOLDINGS?

    Directivos
    NombreNombrado elRenunció elRolDirecciónIdentificación de la empresaPaís de residenciaNacionalidadFecha de nacimientoOcupaciónNúmero
    S & J REGISTRARS LIMITED
    Aldermanbury Square
    13th Floor
    EC2V 7HR London
    5
    England
    Secretario corporativo
    Aldermanbury Square
    13th Floor
    EC2V 7HR London
    5
    England
    Tipo de identificaciónEEE
    Número de registro1740543
    43122090005
    DEAKIN, Philip Matthew
    Aldermanbury Square
    13th Floor
    EC2V 7HR London
    5
    England
    Director
    Aldermanbury Square
    13th Floor
    EC2V 7HR London
    5
    England
    United KingdomBritishChartered Accountant146225080003
    HUDSON, Giles Matthew
    Aldermanbury Square
    13th Floor
    EC2V 7HR London
    5
    England
    Director
    Aldermanbury Square
    13th Floor
    EC2V 7HR London
    5
    England
    United KingdomBritishChartered Accountant161583790003
    UFLAND, Edward
    Aldermanbury Square
    13th Floor
    EC2V 7HR London
    5
    England
    Director
    Aldermanbury Square
    13th Floor
    EC2V 7HR London
    5
    England
    EnglandBritishChartered Accountant161583570001
    EDWARDS, Norman Taylor
    29 Ambleside Road
    L18 9XT Allerton
    Liverpool
    Secretario
    29 Ambleside Road
    L18 9XT Allerton
    Liverpool
    British6790170002
    GOULD, Gerard
    17 Enville Road
    WA14 2PF Bowdon
    Cheshire
    Secretario
    17 Enville Road
    WA14 2PF Bowdon
    Cheshire
    BritishFinance Director85192980003
    ANTROBUS, Anita Louise
    Orchard House Elcho Road
    Bowdon
    WA14 2TL Altrincham
    Cheshire
    Director
    Orchard House Elcho Road
    Bowdon
    WA14 2TL Altrincham
    Cheshire
    EnglishCompany Director6790190001
    ANTROBUS, David Lowden
    Spring Cottage Wellbank Lane
    Over Peover
    WA16 8UN Knutsford
    Cheshire
    Director
    Spring Cottage Wellbank Lane
    Over Peover
    WA16 8UN Knutsford
    Cheshire
    EnglandBritishCompany Director7393710001
    ANTROBUS, Keith Philip
    Orchard House Elcho Road
    Bowdon
    WA14 2TL Altrincham
    Cheshire
    Director
    Orchard House Elcho Road
    Bowdon
    WA14 2TL Altrincham
    Cheshire
    BritishCompany Director23858680001
    BARRETO-MORLEY, Ola Tricia Aramita
    99 Gresham Street
    London
    EC2V 7NG
    Director
    99 Gresham Street
    London
    EC2V 7NG
    United KingdomBritishTax Manager140644240001
    BARRY, Peter
    Slack Farm
    Grains Road
    OL1 4SS Oldham
    Lancashire
    Director
    Slack Farm
    Grains Road
    OL1 4SS Oldham
    Lancashire
    United KingdomBritishManaging Director125580450003
    EDWARDS, Norman Taylor
    29 Ambleside Road
    L18 9XT Allerton
    Liverpool
    Director
    29 Ambleside Road
    L18 9XT Allerton
    Liverpool
    BritishFinancial Director6790170002
    FAIRMAN, Michael John
    14 Hillcrest Road
    Offerton
    SK2 5QL Stockport
    Cheshire
    Director
    14 Hillcrest Road
    Offerton
    SK2 5QL Stockport
    Cheshire
    BritishCompany Director75414410001
    GOULD, Gerard
    17 Enville Road
    WA14 2PF Bowdon
    Cheshire
    Director
    17 Enville Road
    WA14 2PF Bowdon
    Cheshire
    BritishFinance Director85192980003
    LYTH, Mark Anthony
    Mercer Crescent
    Haslingden
    BB4 4JJ Rossendale
    2
    Lancashire
    United Kingdom
    Director
    Mercer Crescent
    Haslingden
    BB4 4JJ Rossendale
    2
    Lancashire
    United Kingdom
    EnglandBritishDirector140783010001
    MOYLE, Paul Garry
    30 Hauxley Drive
    DH2 3TE Chester Le Street
    County Durham
    Director
    30 Hauxley Drive
    DH2 3TE Chester Le Street
    County Durham
    BritishDirector78385370001
    MURIE, Roger James
    24 Cropredy Close
    Queensbury
    BD13 1QY Bradford
    West Yorkshire
    Director
    24 Cropredy Close
    Queensbury
    BD13 1QY Bradford
    West Yorkshire
    EnglandBritishSales Director110452590001
    SEAGER, William
    18 Strain Avenue
    Brackley
    M9 6PS Manchester
    Director
    18 Strain Avenue
    Brackley
    M9 6PS Manchester
    BritishProduction Director44871880001
    UDALL, Gavin
    Summer Lodge
    Romsey Road, Whiteparish
    SP5 2SD Salisbury
    Wiltshire
    Director
    Summer Lodge
    Romsey Road, Whiteparish
    SP5 2SD Salisbury
    Wiltshire
    United KingdomBritishAccountant83889580001

    ¿Tiene ONE LONGRIDGE HOLDINGS alguna carga?

    Gravámenes
    ClasificaciónFechasEstadoDetalles
    Charge
    Creado el 29 jul 2002
    Entregado el 30 jul 2002
    Pendiente
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee
    Breve descripción
    By way of specific charge all uncalled capital and present and future freehold and leasehold property. All present and future book debts together with the benefit of all contracts and engagements. By way of floating security all the undertaking and goodwill and all property assets and rights whatsoever. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • Barclays Mercantile Business Finance Limited
    Transacciones
    • 30 jul 2002Registro de un cargo (395)
    Mortgage
    Creado el 23 ene 2002
    Entregado el 25 ene 2002
    Pendiente
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    One krupp feeder and duplex slitter s/n 0085 together with all accessories and component parts and all improvements and renewals thereof together also with all books manuals handbooks technical data drawings schedules and other documentation. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • Barclays Bank PLC
    Transacciones
    • 25 ene 2002Registro de un cargo (395)
    Mortgage
    Creado el 18 jul 2001
    Entregado el 20 jul 2001
    Pendiente
    Cantidad garantizada
    £250,000 and all other monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    One aerosol can line comprising bliss duplex slitter type 5225A, aoudronic welder ABM150/20 s/n M1427, water chiller tae 051..together with all accessories parts handbooks etc (for full details of further properties charged please refer to form 395). see the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • Barclays Bank PLC
    Transacciones
    • 20 jul 2001Registro de un cargo (395)
    Composite guarantee and debenture
    Creado el 28 ago 1998
    Entregado el 16 sept 1998
    Pendiente
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    Freehold land and buildings on the west side of higginshaw lane royton oldham t/n GM401711, freehold land on the south side of salmon fields royton oldham t/n GM580375, freehold land on the west side of rudding street royton oldham t/n GM590501 and leasehold land and buildings on the south side of foxdenton lane chadderton oldham t/n GM679747. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personas con derecho
    • Barclays Bank PLC
    Transacciones
    • 16 sept 1998Registro de un cargo (395)
    Legal charge
    Creado el 28 ago 1998
    Entregado el 16 sept 1998
    Pendiente
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    F/H land and buildings on the west side of higginshaw lane royton oldham t/n GM401711 the f/h land on the south side of salmon fields royton oldham t/n GM580375 and f/h land on the west side of rudding street royton oldham t/n GM590501.
    Personas con derecho
    • Barclays Bank PLC
    Transacciones
    • 16 sept 1998Registro de un cargo (395)
    Debenture
    Creado el 24 feb 1988
    Entregado el 29 feb 1988
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    (Including heritable property & assets in scotland).. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personas con derecho
    • Lloyds Bank PLC
    Transacciones
    • 29 feb 1988Registro de una carga
    • 07 abr 1999Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Legal charge
    Creado el 30 ene 1986
    Entregado el 06 feb 1986
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    Land and buildings on the south and west sides of springfield street, royton, oldham, geater manchester. Title no: la 202266.
    Personas con derecho
    • Barclays Bank PLC
    Transacciones
    • 06 feb 1986Registro de una carga
    • 11 mar 1992Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)

    Fuente de datos

    • Companies House del Reino Unido
      El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros.
    • Licencia: CC0