AVOCET CARE & SUPPORT LTD
Visión general
| Nombre de la empresa | AVOCET CARE & SUPPORT LTD |
|---|---|
| Estado de la empresa | Activa |
| Forma jurídica | Sociedad de responsabilidad limitada por garantía sin capital social |
| Número de empresa | 00956345 |
| Jurisdicción | Inglaterra/Gales |
| Fecha de constitución |
Resumen
| Tiene PSCs súper seguros | No |
|---|---|
| Tiene gravámenes | No |
| Tiene historial de insolvencia | No |
| La sede social está en disputa | No |
¿Cuál es el propósito de AVOCET CARE & SUPPORT LTD?
- Hoteles y alojamientos similares (55100) / Actividades de alojamiento y de servicios de comida
¿Dónde se encuentra AVOCET CARE & SUPPORT LTD?
| Dirección de la sede social | West Suite, Cottis House Locks Hill South Street SS4 1BB Rochford Essex England |
|---|---|
| Dirección de la sede social no entregable | No |
¿Cuáles fueron los nombres anteriores de AVOCET CARE & SUPPORT LTD?
| Nombre de la empresa | Desde | Hasta |
|---|---|---|
| THE ABBEYFIELD SOUTHEND SOCIETY LIMITED | 02 mar 2004 | 02 mar 2004 |
| ABBEYFIELD SOUTHEND AND SOUTH EAST ESSEX SOCIETY LIMITED | 25 mar 1998 | 25 mar 1998 |
| ABBEYFIELD SOUTHEND & DISTRICT SOCIETY LIMITED (THE) | 17 jun 1969 | 17 jun 1969 |
¿Cuáles son las últimas cuentas de AVOCET CARE & SUPPORT LTD?
| Vencido | No |
|---|---|
| Próximas cuentas | |
| Próximo período contable finaliza el | 31 mar 2026 |
| Próximas cuentas vencen el | 31 dic 2026 |
| Últimas cuentas | |
| Últimas cuentas cerradas hasta | 31 mar 2025 |
¿Cuál es el estado de la última declaración de confirmación para AVOCET CARE & SUPPORT LTD?
| Última declaración de confirmación cerrada hasta | 07 mar 2026 |
|---|---|
| Próxima declaración de confirmación vence | 21 mar 2026 |
| Última declaración de confirmación | |
| Próxima declaración de confirmación cerrada hasta | 07 mar 2025 |
| Vencido | No |
¿Cuáles son las últimas presentaciones para AVOCET CARE & SUPPORT LTD?
| Fecha | Descripción | Documento | Tipo | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cuentas para una empresa pequeña preparadas hasta el 31 mar 2025 | 26 páginas | AA | ||||||||||
Domicilio social registrado cambiado de Ground Floor 19 Clifftown Road Southend on Sea Essex SS1 1AB a West Suite, Cottis House Locks Hill South Street Rochford Essex SS4 1BB el 30 abr 2025 | 1 páginas | AD01 | ||||||||||
Declaración de confirmación presentada el 07 mar 2025 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||||||||||
Notification d'une déclaration relative à une personne disposant d'un contrôle significatif | 2 páginas | PSC08 | ||||||||||
Cessation de Michelle Carole Rogers en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 04 mar 2025 | 1 páginas | PSC07 | ||||||||||
Cessation de Malachy John O'sullivan en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 04 mar 2025 | 1 páginas | PSC07 | ||||||||||
Cessation de Mark Beresford Stevenson en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 04 mar 2025 | 1 páginas | PSC07 | ||||||||||
Cuentas para una empresa pequeña preparadas hasta el 31 mar 2024 | 27 páginas | AA | ||||||||||
Cessation de Roger Martin Nicholas Calton en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 15 jul 2024 | 1 páginas | PSC07 | ||||||||||
Cessation de Trevor Norman Cass en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 15 jul 2024 | 1 páginas | PSC07 | ||||||||||
Cessation de Ian Phillip Carey en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 15 jul 2024 | 1 páginas | PSC07 | ||||||||||
Certificado de cambio de nombre Company name changed the abbeyfield southend society LIMITED\certificate issued on 26/03/24 | 3 páginas | CERTNM | ||||||||||
| ||||||||||||
| ||||||||||||
Declaración de confirmación presentada el 07 mar 2024 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||||||||||
Notification de Malachy John O'sullivan en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 29 nov 2023 | 2 páginas | PSC01 | ||||||||||
Nombramiento de Mr Malachy John O'sulivan como director el 29 nov 2023 | 2 páginas | AP01 | ||||||||||
Cuentas para una empresa pequeña preparadas hasta el 31 mar 2023 | 27 páginas | AA | ||||||||||
Declaración de confirmación presentada el 07 mar 2023 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||||||||||
Cessation de Ernest Terence Martin en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 30 ago 2022 | 1 páginas | PSC07 | ||||||||||
Cessation de Edward Thomas Speakman en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 30 may 2022 | 1 páginas | PSC07 | ||||||||||
Cuentas para una empresa pequeña preparadas hasta el 31 mar 2022 | 24 páginas | AA | ||||||||||
Nombramiento de Miss Michelle Carole Rogers como secretario el 30 sept 2022 | 2 páginas | AP03 | ||||||||||
Cese del nombramiento de Ernest Terence Martin como director el 31 ago 2022 | 1 páginas | TM01 | ||||||||||
Cese del nombramiento de Edward Thomas Speakman como director el 30 may 2022 | 1 páginas | TM01 | ||||||||||
Notification de Michelle Rogers en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 03 may 2022 | 2 páginas | PSC01 | ||||||||||
Cessation de Susan Patricia Speakman en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 02 may 2022 | 1 páginas | PSC07 | ||||||||||
¿Quiénes son los directivos de AVOCET CARE & SUPPORT LTD?
| Nombre | Nombrado el | Renunció el | Rol | Dirección | Identificación de la empresa | País de residencia | Nacionalidad | Fecha de nacimiento | Ocupación | Número |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ROGERS, Michelle Carole | Secretario | Locks Hill South Street SS4 1BB Rochford West Suite, Cottis House Essex England | 300691510001 | |||||||
| CALTON, Roger Martin Nicholas | Director | Alston Court 15 Crowstone Road SS0 8EH Westcliff-On-Sea 43 Essex United Kingdom | England | British | 146681590002 | |||||
| CAREY, Ian Phillip | Director | Locks Hill South Street SS4 1BB Rochford West Suite, Cottis House Essex England | England | British | 92052200001 | |||||
| CASS, Trevor Norman | Director | Locks Hill South Street SS4 1BB Rochford West Suite, Cottis House Essex England | United Kingdom | British | 285902420001 | |||||
| O'SULIVAN, Malachy John | Director | Locks Hill South Street SS4 1BB Rochford West Suite, Cottis House Essex England | England | British | 319347600001 | |||||
| STEVENSON, Mark Beresford | Director | Locks Hill South Street SS4 1BB Rochford West Suite, Cottis House Essex England | United Kingdom | British | 64713880003 | |||||
| LAWS, Frederick Geoffrey | Secretario | 22 Wheatfields Great Stambridge SS4 2BT Rochford Essex | British | 58499770001 | ||||||
| MEAKIN, John Walter | Secretario | 52 Woodlands Road SS5 4PY Hockley Essex | British | 34185590001 | ||||||
| PHILLIPS, Frank Alexander | Secretario | 43 Manners Way SS2 6QW Southend On Sea Essex | British | 25091400001 | ||||||
| AYRE, Sydney Geoffrey | Director | 23 Tyrone Road Thorpe Bay SS1 3HE Southend On Sea Essex | British | 58499880001 | ||||||
| BANTHORPE, Barbara Violet | Director | 19 Cheldon Barton Thorpe Bay SS1 3TX Southend On Sea Essex | British | 86741830001 | ||||||
| BANTHORPE, David Alfred | Director | 19 Cheldon Barton Thorpe Bay SS1 3TX Southend On Sea Essex | British | 46971050001 | ||||||
| BLEE, Peter James | Director | 26 Marine Approach SS8 0AL Canvey Island Essex | British | 25091410002 | ||||||
| BRIGHT, Gladys Joan | Director | 195 Pall Mall SS9 1RD Leigh On Sea Essex | British | 25091420001 | ||||||
| BROWN, Leonie Marion | Director | 14 Canvey Road SS9 2NN Leigh On Sea Essex | British | 32699670001 | ||||||
| BURROWS, Katherine Tina | Director | No 4 The Pickfords Building 16-22 Priory Avenue Prittlewell SS2 6LB Southend On Sea Essex | England | British | 45424470010 | |||||
| BURROWS, Sheila | Director | 16 Manor Road SS7 4BG Benfleet Essex | British | 63696190001 | ||||||
| BURROWS, Timothy John | Director | Apartment 4 The Pickfords Building 16-22 Priory Avenue SS2 6LB Southend On Sea Essex | British | 84775540008 | ||||||
| BURROWS, Timothy John | Director | 36 John William Close Chafford Hundred RM16 6ED Grays Essex | British | 84775540002 | ||||||
| CALTON, Roger Martin Nicholas | Director | 3 Stephen Court Lime Avenue SS9 3PA Leigh On Sea Essex | England | British | 146681590001 | |||||
| CLAMP, David Walter | Director | 118 Manners Way SS2 6PZ Southend On Sea Essex | British | 78382240001 | ||||||
| CLARKE, Walter George | Director | 102 Oaken Grange Drive SS2 6QA Southend On Sea Essex | British | 25091430001 | ||||||
| COUSINS, Pauline Audrey | Director | 1 Hillway SS0 8QA Westcliff On Sea Essex | British | 42483260001 | ||||||
| DEED, Frank | Director | 19 Westleigh Avenue SS9 2LD Leigh On Sea Essex | British | 25091440001 | ||||||
| DILNOT, Winifred Olive | Director | 68 St Helens Road SS0 7LB Westcliff On Sea Essex | British | 7177560001 | ||||||
| DOWNS, Nancy Helen | Director | 28 Cleveland Drive SS0 0SU Westcliff On Sea Essex | British | 25091450001 | ||||||
| FOGARTY, Patricia Ann Elizabeth | Director | 7 Avenue Terrace SS0 7PL Westcliff On Sea Essex | British | 39435870001 | ||||||
| FYVIE, Gordon William | Director | 11 The Leasway SS0 8PA Westcliff On Sea Essex | British | 25091460001 | ||||||
| FYVIE, Gordon William | Director | 11 The Leasway SS0 8PA Westcliff On Sea Essex | British | 25091460001 | ||||||
| HANSON, Vera Eleanor | Director | 84 Admirals Walk SS3 9HS Shoeburyness Essex | British | 86826080001 | ||||||
| HARRISON, Philip David | Director | 24 Theobalds Road SS9 2NE Leigh On Sea Essex | British | 51350990001 | ||||||
| HARVEY, Olive Christine | Director | 115 Kiln Road Thundersley SS7 1TG Benfleet Essex | British | 54615890001 | ||||||
| HAWKINS, Susan Ruth | Director | Ground Floor 19 Clifftown Road SS1 1AB Southend On Sea Essex | England | British | 157638850001 | |||||
| LAWS, Frederick Geoffrey | Director | 22 Wheatfields Great Stambridge SS4 2BT Rochford Essex | England | British | 58499770001 | |||||
| MACNAUGHTAN, David Malcolm Robert | Director | 151 Kings Road SS0 8PP Westcliff On Sea Essex | British | 7177470001 |
¿Quiénes son las personas con control significativo de AVOCET CARE & SUPPORT LTD?
| Nombre | Notificado el | Dirección | Cesado |
|---|---|---|---|
| Mr Malachy John O'Sullivan | 29 nov 2023 | Ground Floor 19 Clifftown Road SS1 1AB Southend On Sea Essex | Sí |
Nacionalidad: British País de residencia: England | |||
Naturaleza del control
| |||
| Miss Michelle Carole Rogers | 03 may 2022 | Ground Floor 19 Clifftown Road SS1 1AB Southend On Sea Essex | Sí |
Nacionalidad: British País de residencia: England | |||
Naturaleza del control
| |||
| Mr Trevor Norman Cass | 23 jun 2021 | Ground Floor 19 Clifftown Road SS1 1AB Southend On Sea Essex | Sí |
Nacionalidad: British País de residencia: United Kingdom | |||
Naturaleza del control
| |||
| Mr Mark Beresford Stevenson | 28 abr 2021 | Ground Floor 19 Clifftown Road SS1 1AB Southend On Sea Essex | Sí |
Nacionalidad: British País de residencia: United Kingdom | |||
Naturaleza del control
| |||
| Mrs Susan Barbara Turrell | 07 ago 2019 | Ground Floor 19 Clifftown Road SS1 1AB Southend On Sea Essex | Sí |
Nacionalidad: British País de residencia: England | |||
Naturaleza del control
| |||
| Mr Ian Phillip Carey | 23 ago 2017 | Ground Floor 19 Clifftown Road SS1 1AB Southend On Sea Essex | Sí |
Nacionalidad: British País de residencia: England | |||
Naturaleza del control
| |||
| Mrs Janice Mary Price | 03 ago 2016 | Ground Floor 19 Clifftown Road SS1 1AB Southend On Sea Essex | Sí |
Nacionalidad: British País de residencia: England | |||
Naturaleza del control
| |||
| Mr Roger Martin Nicholas Calton | 06 abr 2016 | Ground Floor 19 Clifftown Road SS1 1AB Southend On Sea Essex | Sí |
Nacionalidad: British País de residencia: England | |||
Naturaleza del control
| |||
| Mr Ernest Terence Martin | 06 abr 2016 | Ground Floor 19 Clifftown Road SS1 1AB Southend On Sea Essex | Sí |
Nacionalidad: English País de residencia: England | |||
Naturaleza del control
| |||
| Mr Edward Thomas Speakman | 06 abr 2016 | Ground Floor 19 Clifftown Road SS1 1AB Southend On Sea Essex | Sí |
Nacionalidad: British País de residencia: England | |||
Naturaleza del control
| |||
| Mrs Susan Patricia Speakman | 06 abr 2016 | Ground Floor 19 Clifftown Road SS1 1AB Southend On Sea Essex | Sí |
Nacionalidad: British País de residencia: England | |||
Naturaleza del control
| |||
| Mr Godfrey Salmon | 06 abr 2016 | Ground Floor 19 Clifftown Road SS1 1AB Southend On Sea Essex | Sí |
Nacionalidad: British País de residencia: England | |||
Naturaleza del control
| |||
| Mrs Georgina May Reames | 06 abr 2016 | Ground Floor 19 Clifftown Road SS1 1AB Southend On Sea Essex | Sí |
Nacionalidad: British País de residencia: England | |||
Naturaleza del control
| |||
| Mrs Susan Ruth Hawkins | 06 abr 2016 | Ground Floor 19 Clifftown Road SS1 1AB Southend On Sea Essex | Sí |
Nacionalidad: British País de residencia: England | |||
Naturaleza del control
| |||
¿Cuáles son las últimas declaraciones sobre personas con control significativo para AVOCET CARE & SUPPORT LTD?
| Notificado el | Cesado el | Declaración |
|---|---|---|
| 07 mar 2025 | La empresa sabe o tiene motivos razonables para creer que no existe ninguna persona registrable o entidad jurídica relevante registrable en relación con la empresa. |
Fuente de datos
- Companies House del Reino Unido
El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros. - Licencia: CC0