HSBC VEHICLE FINANCE (UK) LIMITED

HSBC VEHICLE FINANCE (UK) LIMITED

  • Visión general
  • Resumen
  • Propósito
  • Dirección
  • Nombres anteriores
  • Cuentas
  • Declaración anual
  • Presentaciones
  • Directivos
  • Gravámenes
  • Fuente de datos
  • Visión general

    Nombre de la empresaHSBC VEHICLE FINANCE (UK) LIMITED
    Estado de la empresaDisuelta
    Forma jurídicaSociedad de responsabilidad limitada
    Número de empresa 00959366
    JurisdicciónInglaterra/Gales
    Fecha de constitución
    Fecha de cese

    Resumen

    Tiene PSCs súper segurosNo
    Tiene gravámenes
    Tiene historial de insolvenciaNo
    La sede social está en disputaNo

    ¿Cuál es el propósito de HSBC VEHICLE FINANCE (UK) LIMITED?

    • Actividades de sociedades holding de servicios financieros (64205) / Actividades financieras y de seguros

    ¿Dónde se encuentra HSBC VEHICLE FINANCE (UK) LIMITED?

    Dirección de la sede social
    8 Canada Square
    London
    E14 5HQ
    Dirección de la sede social no entregableNo

    ¿Cuáles fueron los nombres anteriores de HSBC VEHICLE FINANCE (UK) LIMITED?

    Nombres anteriores de la empresa
    Nombre de la empresaDesdeHasta
    SWAN NATIONAL LIMITED01 abr 199701 abr 1997
    SWAN NATIONAL LEASING LIMITED31 dic 197831 dic 1978
    INDUSTRIAL RENTALS LIMITED01 ago 196901 ago 1969

    ¿Cuáles son las últimas cuentas de HSBC VEHICLE FINANCE (UK) LIMITED?

    Últimas cuentas
    Últimas cuentas cerradas hasta31 dic 2013

    ¿Cuál es el estado de la última declaración anual para HSBC VEHICLE FINANCE (UK) LIMITED?

    Declaración anual
    Última declaración anual

    ¿Cuáles son las últimas presentaciones para HSBC VEHICLE FINANCE (UK) LIMITED?

    Presentaciones
    FechaDescripciónDocumentoTipo

    Boletín oficial final disuelto por cancelación voluntaria

    1 páginasGAZ2(A)

    Primer aviso en el boletín oficial para la cancelación voluntaria

    1 páginasGAZ1(A)

    Solicitud de exclusión de la empresa del registro

    3 páginasDS01

    legacy

    5 páginasSH20

    legacy

    4 páginasCAP-SS

    Estado de capital el 27 jun 2014

    • Capital: GBP 1
    4 páginasSH19

    Resoluciones

    Resolutions
    2 páginasRESOLUTIONS
    Acuerdos
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    capital

    Resolución de reducción del capital social emitido

    RES06

    Cuentas completas preparadas hasta el 31 dic 2013

    19 páginasAA

    Déclaration annuelle établie au 01 may 2014 avec liste complète des actionnaires

    7 páginasAR01

    Cuentas completas preparadas hasta el 31 dic 2012

    19 páginasAA

    Resoluciones

    Resolutions
    40 páginasRESOLUTIONS
    Acuerdos
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    incorporation

    Resolución de adopción de los Artículos de Asociación

    RES01

    Cese del nombramiento de Hollie Rheanna Wood como secretario el 24 jul 2013

    1 páginasTM02

    Nombramiento de Katherine Dean como secretario el 24 jul 2013

    2 páginasAP03

    Déclaration annuelle établie au 01 may 2013 avec liste complète des actionnaires

    7 páginasAR01

    Nombramiento de Richard Andrew Carter como director el 14 nov 2012

    2 páginasAP01

    Cuentas completas preparadas hasta el 31 dic 2011

    19 páginasAA

    Cese del nombramiento de Adrian Timothy Rigby como director el 22 may 2012

    1 páginasTM01

    Nombramiento de Robert Francis Carver como director el 22 may 2012

    2 páginasAP01

    Déclaration annuelle établie au 01 may 2012 avec liste complète des actionnaires

    6 páginasAR01

    Cambio de datos del director Gavin Paul Hewitt el 20 abr 2012

    2 páginasCH01

    Cuentas completas preparadas hasta el 31 dic 2010

    19 páginasAA

    Nombramiento de Gavin Paul Hewitt como director

    2 páginasAP01

    Nombramiento de Adrian Timothy Rigby como director

    2 páginasAP01

    Cese del nombramiento de Malcolm Brookes como director

    1 páginasTM01

    Déclaration annuelle établie au 01 may 2011 avec liste complète des actionnaires

    5 páginasAR01

    ¿Quiénes son los directivos de HSBC VEHICLE FINANCE (UK) LIMITED?

    Directivos
    NombreNombrado elRenunció elRolDirecciónIdentificación de la empresaPaís de residenciaNacionalidadFecha de nacimientoOcupaciónNúmero
    DEAN, Katherine
    Canada Square
    E14 5HQ London
    8
    United Kingdom
    Secretario
    Canada Square
    E14 5HQ London
    8
    United Kingdom
    180094250001
    CARTER, Richard Andrew
    Canada Square
    E14 5HQ London
    8
    United Kingdom
    Director
    Canada Square
    E14 5HQ London
    8
    United Kingdom
    United KingdomBritish173634300001
    CARVER, Robert Francis
    Canada Square
    E14 5HQ London
    8
    United Kingdom
    Director
    Canada Square
    E14 5HQ London
    8
    United Kingdom
    EnglandBritish167169940001
    HEWITT, Gavin Paul
    Canada Square
    E14 5HQ London
    8
    United Kingdom
    Director
    Canada Square
    E14 5HQ London
    8
    United Kingdom
    United KingdomBritish162283890002
    RUSSELL-BROWN, Michael John
    Canada Square
    E14 5HQ London
    8
    United Kingdom
    Director
    Canada Square
    E14 5HQ London
    8
    United Kingdom
    EnglandBritish109954540001
    BAYER, George William
    Flat 1
    Old Bank House, 110 Bermondsey Street
    SE1 3TX London
    Secretario
    Flat 1
    Old Bank House, 110 Bermondsey Street
    SE1 3TX London
    Other123920600002
    GOTT, Sarah Caroline
    Whitworth Street
    SE10 9EN London
    13
    United Kingdom
    Secretario
    Whitworth Street
    SE10 9EN London
    13
    United Kingdom
    British136485400005
    MAIR, James Stewart
    7 Padgate Close
    Scraptoft
    LE7 9UL Leicester
    Leicestershire
    Secretario
    7 Padgate Close
    Scraptoft
    LE7 9UL Leicester
    Leicestershire
    British8864270001
    MCKENZIE, John Hume
    37 Lime Trees
    Staplehurst
    TN12 0SS Tonbridge
    Kent
    Secretario
    37 Lime Trees
    Staplehurst
    TN12 0SS Tonbridge
    Kent
    British67406010001
    MCQUILLAN, Pauline Louise
    1 Bolney Court
    Portsmouth Road
    KT6 4HX Surbiton
    Surrey
    Secretario
    1 Bolney Court
    Portsmouth Road
    KT6 4HX Surbiton
    Surrey
    British109247130001
    MUSGROVE, Robert Hugh
    6 Barn Meadow
    Staplehurst
    TN12 0SY Tonbridge
    Kent
    Secretario
    6 Barn Meadow
    Staplehurst
    TN12 0SY Tonbridge
    Kent
    Other76913670001
    NIVEN, Frances Julie
    73 Celestial Gardens
    SE13 5RU London
    Secretario
    73 Celestial Gardens
    SE13 5RU London
    British78670270001
    PEARCE, Mark Vivian
    55 Huntly Road
    Talbot Woods
    BH3 7HG Bournemouth
    Dorset
    Secretario
    55 Huntly Road
    Talbot Woods
    BH3 7HG Bournemouth
    Dorset
    British26776940002
    WOOD, Hollie Rheanna
    Canada Square
    E14 5HQ London
    8
    United Kingdom
    Secretario
    Canada Square
    E14 5HQ London
    8
    United Kingdom
    154740750001
    ALDOUS, Frederick Herbert
    16 The Chyne
    South Park
    SL9 8HZ Gerrards Cross
    Buckinghamshire
    Director
    16 The Chyne
    South Park
    SL9 8HZ Gerrards Cross
    Buckinghamshire
    EnglandBritish396990003
    BOTTOMLEY, Stephen Andrew
    Liverton House
    Roundwood Lane
    RH16 1SJ Lindfield
    West Sussex
    Director
    Liverton House
    Roundwood Lane
    RH16 1SJ Lindfield
    West Sussex
    British60768490002
    BOWLES, Roynard Keith
    Bush Cottage Brighton Road
    Lower Kingswood
    KT20 6SX Tadworth
    Surrey
    Director
    Bush Cottage Brighton Road
    Lower Kingswood
    KT20 6SX Tadworth
    Surrey
    British9068280003
    BROOKES, Malcolm James
    Canada Square
    E14 5HQ London
    8
    United Kingdom
    Director
    Canada Square
    E14 5HQ London
    8
    United Kingdom
    United KingdomBritish61727900006
    CARNEY, Brian
    Springwood Lodge
    Owler Park Road
    LS29 0BG Ilkley
    West Yorkshire
    Director
    Springwood Lodge
    Owler Park Road
    LS29 0BG Ilkley
    West Yorkshire
    British100001170001
    CARROLL, Alan
    10 Woodcote
    RH6 9AL Horley
    Surrey
    Director
    10 Woodcote
    RH6 9AL Horley
    Surrey
    British27557560002
    CLAYTON, Leonard Francis
    5 The Crofts
    Banbury Road
    CV37 7NF Stratford Upon Avon
    Warwickshire
    Director
    5 The Crofts
    Banbury Road
    CV37 7NF Stratford Upon Avon
    Warwickshire
    British58398630002
    CORK, Raymond Michael
    Kniveton
    DE6 1JG Ashbourne
    Kniveton Wood Farm
    Director
    Kniveton
    DE6 1JG Ashbourne
    Kniveton Wood Farm
    United KingdomBritish129809740001
    EVANS, Geoffrey William
    The Trumpet House Kington Lane
    Claverdon
    CV35 8PP Warwick
    Director
    The Trumpet House Kington Lane
    Claverdon
    CV35 8PP Warwick
    British42712190001
    GILMAN, David William
    32 Riverside Drive
    Selly Oak
    B29 7ES Birmingham
    Director
    32 Riverside Drive
    Selly Oak
    B29 7ES Birmingham
    British5681410002
    HOLMES, Timothy Victor
    12 Aspins Way
    Bromsgrove
    B61 0UW Birmingham
    Director
    12 Aspins Way
    Bromsgrove
    B61 0UW Birmingham
    British28497420007
    KELL, Christopher Raymond
    6 Gorse Close
    WR9 7SG Droitwich
    Worcestershire
    Director
    6 Gorse Close
    WR9 7SG Droitwich
    Worcestershire
    British87307470001
    LANE, Robert David
    42 Bridgnorth Road
    WV5 0AA Wombourne
    Staffordshire
    Director
    42 Bridgnorth Road
    WV5 0AA Wombourne
    Staffordshire
    EnglandBritish150099050001
    LOOMES, Peter John
    24 Raine Way Grange Park
    Oadby
    LE2 4UB Leicester
    Leicestershire
    Director
    24 Raine Way Grange Park
    Oadby
    LE2 4UB Leicester
    Leicestershire
    British37059930001
    MOSLEY, Ian Christopher
    Middlewood House
    Jordans Way, Jordans
    HP9 2SP Beaconsfield
    Buckinghamshire
    Director
    Middlewood House
    Jordans Way, Jordans
    HP9 2SP Beaconsfield
    Buckinghamshire
    United KingdomBritish81842870001
    PICKEN, Graham Edward
    60 Church Road
    Aspley Heath Woburn Sands
    MK17 8TA Milton Keynes
    Director
    60 Church Road
    Aspley Heath Woburn Sands
    MK17 8TA Milton Keynes
    British144947830001
    QUINN, Noel Paul
    Canada Square
    E14 5HQ London
    8
    United Kingdom
    Director
    Canada Square
    E14 5HQ London
    8
    United Kingdom
    United KingdomBritish123627420002
    QUINN, Noel Paul
    10 Besford Grove
    Shirley
    B90 4YU Solihull
    West Midlands
    Director
    10 Besford Grove
    Shirley
    B90 4YU Solihull
    West Midlands
    British72093050001
    RIGBY, Adrian Timothy
    Canada Square
    E14 5HQ London
    8
    United Kingdom
    Director
    Canada Square
    E14 5HQ London
    8
    United Kingdom
    United KingdomBritish138880420001
    SMITHSON, Keith Victor
    The Stables 3 Old Manor Court
    Welton
    NN11 5HA Daventry
    Northamptonshire
    Director
    The Stables 3 Old Manor Court
    Welton
    NN11 5HA Daventry
    Northamptonshire
    Irish72729280002
    STEIN, Wallace George William
    10 Gibbet Hill Road
    CV4 7AJ Coventry
    West Midlands
    Director
    10 Gibbet Hill Road
    CV4 7AJ Coventry
    West Midlands
    EnglandBritish99602760001

    ¿Tiene HSBC VEHICLE FINANCE (UK) LIMITED alguna carga?

    Gravámenes
    ClasificaciónFechasEstadoDetalles
    Floating charge
    Creado el 27 mar 1979
    Entregado el 17 abr 1979
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    1. benefit of all contracts for the hire of motor vehicles subject to a conditional sale leasing or contract hire agreement with ford credit 2. all right and title to the assets comprised in this security. 3. all proceeds of sale and insurance monies recevable in respect of the assets comprised in this security.
    Personas con derecho
    • Ford Motor Credit Company Limited
    Transacciones
    • 17 abr 1979Registro de una carga
    • 16 sept 1994Declaración de que parte o la totalidad de la propiedad de una carga flotante ha sido liberada (403b)
    • 31 oct 2005Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Debenture
    Creado el 03 feb 1977
    Entregado el 11 feb 1977
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    Fixed and floating charge on the undertaking and all property and assets present and future including goodwill, bookdebts and uncalled capital. With all buildings, fixtures, fixed plant and machinery, (see doc. M. 23).
    Personas con derecho
    • Barclays Bank Limited
    Transacciones
    • 11 feb 1977Registro de una carga
    • 16 sept 1994Declaración de que parte o la totalidad de la propiedad de una carga flotante ha sido liberada (403b)
    • 31 oct 2005Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)

    Fuente de datos

    • Companies House del Reino Unido
      El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros.
    • Licencia: CC0