INTERNATIONAL BUSINESS COMMUNICATIONS LIMITED

INTERNATIONAL BUSINESS COMMUNICATIONS LIMITED

  • Visión general
  • Resumen
  • Propósito
  • Dirección
  • Nombres anteriores
  • Cuentas
  • Presentaciones
  • Directivos
  • Gravámenes
  • Fuente de datos
  • Visión general

    Nombre de la empresaINTERNATIONAL BUSINESS COMMUNICATIONS LIMITED
    Estado de la empresaDisuelta
    Forma jurídicaSociedad de responsabilidad limitada
    Número de empresa 00959641
    JurisdicciónInglaterra/Gales
    Fecha de constitución
    Fecha de cese

    Resumen

    Tiene PSCs súper segurosNo
    Tiene gravámenes
    Tiene historial de insolvenciaNo
    La sede social está en disputaNo

    ¿Cuál es el propósito de INTERNATIONAL BUSINESS COMMUNICATIONS LIMITED?

    • (7499) /

    ¿Dónde se encuentra INTERNATIONAL BUSINESS COMMUNICATIONS LIMITED?

    Dirección de la sede social
    Mortimer House
    37-41 Mortimer Street
    W1T 3JH London
    Dirección de la sede social no entregableNo

    ¿Cuáles fueron los nombres anteriores de INTERNATIONAL BUSINESS COMMUNICATIONS LIMITED?

    Nombres anteriores de la empresa
    Nombre de la empresaDesdeHasta
    IBC CONFERENCES LIMITED05 feb 199205 feb 1992
    INTERNATIONAL BUSINESS COMMUNICATIONS LIMITED03 mar 198603 mar 1986
    OYEZ INTERNATIONAL BUSINESS COMMUNICATIONS LIMITED05 ago 196905 ago 1969

    ¿Cuáles son las últimas cuentas de INTERNATIONAL BUSINESS COMMUNICATIONS LIMITED?

    Últimas cuentas
    Últimas cuentas cerradas hasta31 dic 2009

    ¿Cuáles son las últimas presentaciones para INTERNATIONAL BUSINESS COMMUNICATIONS LIMITED?

    Presentaciones
    FechaDescripciónDocumentoTipo

    Boletín oficial final disuelto por cancelación voluntaria

    1 páginasGAZ2(A)

    Primer aviso en el boletín oficial para la cancelación voluntaria

    1 páginasGAZ1(A)

    Solicitud de exclusión de la empresa del registro

    3 páginasDS01

    legacy

    1 páginasCAP-SS

    Estado de capital el 23 dic 2010

    • Capital: GBP 0.10
    4 páginasSH19

    Resoluciones

    Resolutions
    2 páginasRESOLUTIONS
    Acuerdos
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    capital

    Resoluciones

    Reduce share premium account 23/11/2010
    RES13
    capital

    Resolución de reducción del capital social emitido

    RES06

    Cambio de datos del director Mr Peter Stephen Rigby el 05 oct 2010

    2 páginasCH01

    Cambio de datos del director Mr Adam Christopher Walker el 05 oct 2010

    2 páginasCH01

    Cambio de datos del secretario Miss Julie Louise Wilson el 27 sept 2010

    1 páginasCH03

    Subdivisión de acciones el 02 sept 2010

    5 páginasSH02

    Resoluciones

    Resolutions
    34 páginasRESOLUTIONS
    Acuerdos
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    capital

    Resolución de asignación de valores

    RES10
    incorporation

    Resolución de adopción de los Artículos de Asociación

    RES01
    capital

    Resolución de variación de los derechos o del nombre de las acciones

    RES12

    Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 31 dic 2009

    9 páginasAA

    Cambio de datos del director John William Burton el 11 ago 2010

    2 páginasCH01

    Déclaration annuelle établie au 01 jun 2010 avec liste complète des actionnaires

    7 páginasAR01

    Nombramiento de Rachel Jacobs como director

    2 páginasAP01

    Nombramiento de Gareth Richard Wright como director

    2 páginasAP01

    Cambio de datos del director Mark Henry Kerswell el 02 dic 2009

    2 páginasCH01

    Cambio de datos del secretario Miss Julie Louise Wilson el 02 dic 2009

    1 páginasCH03

    Cambio de datos del director Peter Stephen Rigby el 01 dic 2009

    2 páginasCH01

    Cambio de datos del director Adam Christopher Walker el 27 nov 2009

    2 páginasCH01

    Cuentas preparadas hasta el 31 dic 2008

    5 páginasAA

    legacy

    2 páginas288a

    legacy

    4 páginas363a

    Cuentas preparadas hasta el 31 dic 2007

    5 páginasAA

    legacy

    1 páginas288c

    ¿Quiénes son los directivos de INTERNATIONAL BUSINESS COMMUNICATIONS LIMITED?

    Directivos
    NombreNombrado elRenunció elRolDirecciónIdentificación de la empresaPaís de residenciaNacionalidadFecha de nacimientoOcupaciónNúmero
    WOOLLARD, Julie Louise
    37/41 Mortimer Street
    W1T 3JH London
    Mortimer House
    England
    Secretario
    37/41 Mortimer Street
    W1T 3JH London
    Mortimer House
    England
    British139159370002
    BURTON, John William
    Mortimer House
    37-41 Mortimer Street
    W1T 3JH London
    Director
    Mortimer House
    37-41 Mortimer Street
    W1T 3JH London
    United KingdomBritish113684810001
    JACOBS, Rachel Elizabeth
    37/41 Mortimer Street
    W1T 3JH London
    Mortimer House
    England
    Director
    37/41 Mortimer Street
    W1T 3JH London
    Mortimer House
    England
    United KingdomBritish92334500004
    KERSWELL, Mark Henry
    37/41 Mortimer Street
    W1T 3JH London
    Mortimer House
    England
    Director
    37/41 Mortimer Street
    W1T 3JH London
    Mortimer House
    England
    EnglandBritish82609620003
    RIGBY, Peter Stephen
    37/41 Mortimer Street
    W1T 3JH London
    Mortimer House
    England
    Director
    37/41 Mortimer Street
    W1T 3JH London
    Mortimer House
    England
    SwitzerlandBritish69164290007
    WALKER, Adam Christopher
    37/41 Mortimer Street
    W1T 3JH London
    Mortimer House
    England
    Director
    37/41 Mortimer Street
    W1T 3JH London
    Mortimer House
    England
    SwitzerlandBritish129368430002
    WRIGHT, Gareth Richard
    37/41 Mortimer Street
    W1T 3JH London
    Mortimer House
    England
    Director
    37/41 Mortimer Street
    W1T 3JH London
    Mortimer House
    England
    United KingdomBritish131115190001
    CALLABY, Andrea Mary
    5 Thornton Drive
    CO4 5WB Colchester
    Essex
    Secretario
    5 Thornton Drive
    CO4 5WB Colchester
    Essex
    British70352690002
    HAYWARD, Pearl Catherine
    60 Idmiston Square
    KT4 7SY Worcester Park
    Surrey
    Secretario
    60 Idmiston Square
    KT4 7SY Worcester Park
    Surrey
    British61319730001
    LODGE, David William
    19 Windermere Drive
    CM7 8UB Braintree
    Essex
    Secretario
    19 Windermere Drive
    CM7 8UB Braintree
    Essex
    British10640040001
    PEACH, Inez Mary
    Silverwood Station Road
    Semley
    SP7 9AH Shaftesbury
    Dorset
    Secretario
    Silverwood Station Road
    Semley
    SP7 9AH Shaftesbury
    Dorset
    British9976010001
    RICHMOND, Sonia Anna
    8 Viscount Gardens
    KT14 6HE Byfleet
    Surrey
    Secretario
    8 Viscount Gardens
    KT14 6HE Byfleet
    Surrey
    British118535490002
    WHITE, Teresa Catherine
    2 Cuckoo Dene
    W7 3DP London
    Secretario
    2 Cuckoo Dene
    W7 3DP London
    British65724350001
    WITHERS, John Martin
    High Trees Farm
    2 Lexden Road West Bergholt
    CO6 3BT Colchester
    Essex
    Secretario
    High Trees Farm
    2 Lexden Road West Bergholt
    CO6 3BT Colchester
    Essex
    British41682250002
    CROPPER, Anthony Graham
    Meadow House
    Moules Lane Hadstock
    CB21 4PD Cambridge
    Cambridgeshire
    Director
    Meadow House
    Moules Lane Hadstock
    CB21 4PD Cambridge
    Cambridgeshire
    EnglandBritish8664640001
    FOYE, Anthony Martin
    Lynwood
    White Lane
    RG26 5TN Hannington
    Hampshire
    Director
    Lynwood
    White Lane
    RG26 5TN Hannington
    Hampshire
    United KingdomBritish99515780001
    GILBERTSON, David Stuart
    Casa Maria
    Spaniard's End Hampstead
    NW3 7JG London
    Director
    Casa Maria
    Spaniard's End Hampstead
    NW3 7JG London
    United KingdomBritish10921820004
    HAINES, John James Henry
    Waxway House
    East Hill
    EX11 1QD Ottery St Mary
    Devon
    Director
    Waxway House
    East Hill
    EX11 1QD Ottery St Mary
    Devon
    British28614090002
    WILKINSON, James Henry
    2 The Nursery
    Sutton Courtenay
    OX14 4UA Abingdon
    Oxfordshire
    Director
    2 The Nursery
    Sutton Courtenay
    OX14 4UA Abingdon
    Oxfordshire
    United KingdomBritish56006210002
    WITHERS, John Martin
    High Trees Farm
    2 Lexden Road West Bergholt
    CO6 3BT Colchester
    Essex
    Director
    High Trees Farm
    2 Lexden Road West Bergholt
    CO6 3BT Colchester
    Essex
    British41682250002
    WYLES, Rhona Irene
    43 Blomfield Road
    W9 2PF London
    Director
    43 Blomfield Road
    W9 2PF London
    British51215380001

    ¿Tiene INTERNATIONAL BUSINESS COMMUNICATIONS LIMITED alguna carga?

    Gravámenes
    ClasificaciónFechasEstadoDetalles
    Deed of charge over credit balances
    Creado el 10 may 1995
    Entregado el 16 may 1995
    Pendiente
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    Fixed charge over the "deposit(s)" being all sums of money in any currency deposited with the bank or held by the bank pursuant to the deposit. Barclays bank PLC re international business communications limited currency treasury deposit deal number 63393233.. see the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • Barclays Bank PLC
    Transacciones
    • 16 may 1995Registro de un cargo (395)
    Deed of charge
    Creado el 22 nov 1990
    Entregado el 11 dic 1990
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due form the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee under the terms of the financing documents (as defned in the charge)
    Breve descripción
    (See doc M160 for full details). Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personas con derecho
    • And Hill Samuel Bank Limited
    • Morgan Guaranty Trust Company of New York (As Agent)
    Transacciones
    • 11 dic 1990Registro de una carga
    • 06 dic 1994Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Charge
    Creado el 07 mar 1983
    Entregado el 07 mar 1983
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    Fixed & floating charge over undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital.
    Personas con derecho
    • Solicitors Law Stationery Society PLC
    Transacciones
    • 07 mar 1983Registro de una carga

    Fuente de datos

    • Companies House del Reino Unido
      El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros.
    • Licencia: CC0