TEAM LIFE GLOBAL LIMITED
Visión general
| Nombre de la empresa | TEAM LIFE GLOBAL LIMITED |
|---|---|
| Estado de la empresa | Disuelta |
| Forma jurídica | Sociedad de responsabilidad limitada |
| Número de empresa | 00964286 |
| Jurisdicción | Inglaterra/Gales |
| Fecha de constitución | |
| Fecha de cese |
Resumen
| Tiene PSCs súper seguros | No |
|---|---|
| Tiene gravámenes | Sí |
| Tiene historial de insolvencia | No |
| La sede social está en disputa | No |
¿Cuál es el propósito de TEAM LIFE GLOBAL LIMITED?
- Agencias de publicidad (73110) / Actividades profesionales, científicas y técnicas
¿Dónde se encuentra TEAM LIFE GLOBAL LIMITED?
| Dirección de la sede social | Greater London House Hampstead Road NW1 7QP London England |
|---|---|
| Dirección de la sede social no entregable | No |
¿Cuáles fueron los nombres anteriores de TEAM LIFE GLOBAL LIMITED?
| Nombre de la empresa | Desde | Hasta |
|---|---|---|
| ATLAS ADVERTISING LIMITED | 04 abr 2014 | 04 abr 2014 |
| THE REALITY SHOP LONDON LIMITED | 25 sept 2012 | 25 sept 2012 |
| ATLAS ADVERTISING LIMITED | 08 jul 1998 | 08 jul 1998 |
| ACME MEDIA LIMITED | 17 jun 1994 | 17 jun 1994 |
| SAATCHI & SAATCHI MARKETING LTD | 09 dic 1988 | 09 dic 1988 |
| SAATCHI MARKETING LIMITED | 20 may 1988 | 20 may 1988 |
| THE MARKETING UNIT LTD. | 10 jun 1987 | 10 jun 1987 |
| ELDON GRAPHICS LIMITED | 20 oct 1969 | 20 oct 1969 |
¿Cuáles son las últimas cuentas de TEAM LIFE GLOBAL LIMITED?
| Últimas cuentas | |
|---|---|
| Últimas cuentas cerradas hasta | 31 dic 2020 |
¿Cuáles son las últimas presentaciones para TEAM LIFE GLOBAL LIMITED?
| Fecha | Descripción | Documento | Tipo | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Boletín oficial final disuelto por cancelación voluntaria | 1 páginas | GAZ2(A) | ||||||||||
La acción de exclusión voluntaria ha sido suspendida | 1 páginas | SOAS(A) | ||||||||||
Primer aviso en el boletín oficial para la cancelación voluntaria | 1 páginas | GAZ1(A) | ||||||||||
Solicitud de exclusión de la empresa del registro | 1 páginas | DS01 | ||||||||||
Cese del nombramiento de Julian Gautier como director el 05 dic 2022 | 1 páginas | TM01 | ||||||||||
Declaración de confirmación presentada el 27 mar 2022 con actualizaciones | 4 páginas | CS01 | ||||||||||
Cancelación total de la carga 1 | 1 páginas | MR04 | ||||||||||
Cancelación total de la carga 2 | 1 páginas | MR04 | ||||||||||
Cuentas de exención total completas preparadas hasta el 31 dic 2020 | 12 páginas | AA | ||||||||||
Resoluciones Resolutions | 2 páginas | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
legacy | 1 páginas | SH20 | ||||||||||
legacy | 1 páginas | SH20 | ||||||||||
Estado de capital el 25 oct 2021
| 5 páginas | SH19 | ||||||||||
legacy | 1 páginas | CAP-SS | ||||||||||
Declaración de confirmación presentada el 27 mar 2021 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||||||||||
Cuentas completas preparadas hasta el 31 dic 2019 | 32 páginas | AA | ||||||||||
Cessation de Julian Gautier en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 17 abr 2020 | 1 páginas | PSC07 | ||||||||||
Notification de Garrott Dorland Crawford Holdings Limited en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 17 abr 2020 | 2 páginas | PSC02 | ||||||||||
Declaración de confirmación presentada el 27 mar 2020 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||||||||||
Nombramiento de Mr Tsvetan Kirilov Borisov como director el 12 dic 2019 | 2 páginas | AP01 | ||||||||||
Cessation de Philip James Lancaster en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 26 nov 2019 | 1 páginas | PSC07 | ||||||||||
Notification de Julian Gautier en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 26 nov 2019 | 2 páginas | PSC01 | ||||||||||
Cese del nombramiento de Charles Spencer St John Kingston como director el 26 nov 2019 | 1 páginas | TM01 | ||||||||||
Cese del nombramiento de Ngen Siak Yap como director el 26 nov 2019 | 1 páginas | TM01 | ||||||||||
Nombramiento de Mr Julian Gautier como director el 25 nov 2019 | 2 páginas | AP01 | ||||||||||
¿Quiénes son los directivos de TEAM LIFE GLOBAL LIMITED?
| Nombre | Nombrado el | Renunció el | Rol | Dirección | Identificación de la empresa | País de residencia | Nacionalidad | Fecha de nacimiento | Ocupación | Número | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DIPPLE, Peter Howard | Secretario | Hampstead Road NW1 7QP London Greater London House England | 197837160001 | |||||||||||
| WPP GROUP (NOMINEES) LIMITED | Secretario corporativo | 27 Farm Street W1J 5RJ London |
| 80143770001 | ||||||||||
| BORISOV, Tsvetan Kirilov | Director | Hampstead Road NW1 7QP London Greater London House England | England | Bulgarian | 245243170001 | |||||||||
| CALOW, David Ferguson | Secretario | 27 Farm Street W1J 5RJ London | British | 91285750001 | ||||||||||
| COTTER, Martin Michael | Secretario | Spinney Mill Lane Prestbury GL52 3NE Cheltenham | British | 78291970001 | ||||||||||
| EVANS, Fiona Maria | Secretario | 85 Ravensmede Way Chiswick W4 1TQ London | British | 49259690002 | ||||||||||
| JANS, Annamaria | Secretario | 20 Underhill Road East Dulwich SE22 0AH London | British | 1085040008 | ||||||||||
| WEATHERSEED, David Ian Cameron | Secretario | The Larches 22 Claremont Road KT10 0PL Claygate Surrey | British | 37857730001 | ||||||||||
| WILLIAMS, Denise | Secretario | Marie Cottage Holmbury Lane RH5 6ND Holmbury St Mary Surrey | British | 24311940004 | ||||||||||
| ANTONIOU, Helen Elizabeth | Director | Knightsbridge Green SW1X 7NW London 1 | England | United Kingdom | 197843700001 | |||||||||
| BOLAND, Andrew Kenneth | Director | 25 Chessfield Park Little Chalfont HP6 6RU Amersham Buckinghamshire | British | 71264540005 | ||||||||||
| BUSS, Jeremy David | Director | 34 Goddington Road SL8 5TZ Bourne End Buckinghamshire | United Kingdom | British | 26720550002 | |||||||||
| COTTER, Martin Michael | Director | Spinney Mill Lane Prestbury GL52 3NE Cheltenham | England | British | 78291970001 | |||||||||
| COYLE, Michael Thomas Patrick | Director | 24 Graham Terrace SW1W 8JH London Greater London | United Kingdom | British | 73884120001 | |||||||||
| DELANEY, Paul | Director | 27 Farm Street W1J 5RJ London | United Kingdom | British | 69254240002 | |||||||||
| FORD, Nicholas Andrew | Director | Knightsbridge Green SW1X 7NW London 1 | England | United Kingdom | 104118150001 | |||||||||
| GAUTIER, Julian | Director | Hampstead Road NW1 7QP London Greater London House England | England | British | 261748310001 | |||||||||
| HAM, David Fenton | Director | 25 Chestnut Avenue TN4 0BT Tunbridge Wells Kent | England | British | 103819950001 | |||||||||
| HOWARD, Stuart Michael | Director | 2 Enbrook Park CT20 3SE Folkestone Kent | United Kingdom | British | 160271430001 | |||||||||
| HOWELL, Peter Graham | Director | 76 Kings Road SW19 8QW London | Uk | British | 62634010001 | |||||||||
| JANS, Annamaria | Director | 20 Underhill Road East Dulwich SE22 0AH London | British | 1085040008 | ||||||||||
| KINGSTON, Charles Spencer St John | Director | Hampstead Road NW1 7QP London Greater London House England | England | United Kingdom | 237630730001 | |||||||||
| LANCASTER, Philip James | Director | Knightsbridge Green SW1X 7NW London 1 | England | British | 197922450001 | |||||||||
| PARKER, Michael | Director | 121 Coningham Road W12 8BU London | British | 11837580001 | ||||||||||
| RICHARDSON, Paul Winston George | Director | 125 Park Avenue New York Ny 10017-5529 Usa | British | 45700660003 | ||||||||||
| SCOTT, Andrew Grant Balfour | Director | 27 Farm Street W1J 5RJ London | United Kingdom | British | 67078370001 | |||||||||
| SWEETLAND, Christopher Paul | Director | 27 Farm Street W1J 5RJ London | England | British | 56529540005 | |||||||||
| VAN DER WELLE, Charles Ward | Director | Knightsbridge Green SW1X 7NW London 1 England | England | British | 183827730001 | |||||||||
| WEATHERSEED, David Ian Cameron | Director | The Larches 22 Claremont Road KT10 0PL Claygate Surrey | British | 37857730001 | ||||||||||
| WEATHERSEED, David Ian Cameron | Director | The Larches 22 Claremont Road KT10 0PL Claygate Surrey | British | 37857730001 | ||||||||||
| WILLIAMS, Denise | Director | Marie Cottage Holmbury Lane RH5 6ND Holmbury St Mary Surrey | British | 24311940004 | ||||||||||
| WILSON, Stephen Michael | Director | 9 Boulters Lock Giffard Park MK14 5QR Milton Keynes | British | 81144620001 | ||||||||||
| YAP, Ngen Siak | Director | Hampstead Road NW1 7QP London Greater London House England | England | Malaysian | 123845680001 |
¿Quiénes son las personas con control significativo de TEAM LIFE GLOBAL LIMITED?
| Nombre | Notificado el | Dirección | Cesado | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Garrott Dorland Crawford Holdings Limited | 17 abr 2020 | Upper Ground SE1 9GL London Sea Containers House England | No | ||||||||||
| |||||||||||||
Naturaleza del control
| |||||||||||||
| Mr Julian Gautier | 26 nov 2019 | Hampstead Road NW1 7QP London Greater London House England | Sí | ||||||||||
Nacionalidad: British País de residencia: England | |||||||||||||
Naturaleza del control
| |||||||||||||
| Mr Philip James Lancaster | 06 abr 2016 | Hampstead Road NW1 7QP London Greater London House England | Sí | ||||||||||
Nacionalidad: British País de residencia: England | |||||||||||||
Naturaleza del control
| |||||||||||||
¿Tiene TEAM LIFE GLOBAL LIMITED alguna carga?
| Clasificación | Fechas | Estado | Detalles | |
|---|---|---|---|---|
| Composite guarantee and debenture | Creado el 19 abr 2002 Entregado el 26 abr 2002 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All monies obligations and liabilities due or to become due from the company to the finance parties or any of them under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Breve descripción .. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
| Composite guarantee and debenture | Creado el 04 abr 2002 Entregado el 12 abr 2002 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Breve descripción Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
Fuente de datos
- Companies House del Reino Unido
El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros. - Licencia: CC0