NEC SOFTWARE SOLUTIONS UK LIMITED
Visión general
| Nombre de la empresa | NEC SOFTWARE SOLUTIONS UK LIMITED |
|---|---|
| Estado de la empresa | Activa |
| Forma jurídica | Sociedad de responsabilidad limitada |
| Número de empresa | 00968498 |
| Jurisdicción | Inglaterra/Gales |
| Fecha de constitución |
Resumen
| Tiene PSCs súper seguros | No |
|---|---|
| Tiene gravámenes | No |
| Tiene historial de insolvencia | No |
| La sede social está en disputa | No |
¿Cuál es el propósito de NEC SOFTWARE SOLUTIONS UK LIMITED?
- Desarrollo de software para negocios y hogares (62012) / Información y comunicación
¿Dónde se encuentra NEC SOFTWARE SOLUTIONS UK LIMITED?
| Dirección de la sede social | 1st Floor, Imex Centre 575-599 Maxted Road HP2 7DX Hemel Hempstead Hertfordshire United Kingdom |
|---|---|
| Dirección de la sede social no entregable | No |
¿Cuáles fueron los nombres anteriores de NEC SOFTWARE SOLUTIONS UK LIMITED?
| Nombre de la empresa | Desde | Hasta |
|---|---|---|
| NORTHGATE PUBLIC SERVICES (UK) LIMITED | 16 jun 2015 | 16 jun 2015 |
| NORTHGATE INFORMATION SOLUTIONS UK LIMITED | 28 abr 2000 | 28 abr 2000 |
| MCDONNELL INFORMATION SYSTEMS LIMITED | 05 ene 1994 | 05 ene 1994 |
| MCDONNELL DOUGLAS INFORMATION SYSTEMS LIMITED | 29 oct 1985 | 29 oct 1985 |
| MICRODATA INFORMATION SYSTEMS LIMITED | 15 mar 1983 | 15 mar 1983 |
| CMC LEASINGS LIMITED | 17 dic 1969 | 17 dic 1969 |
¿Cuáles son las últimas cuentas de NEC SOFTWARE SOLUTIONS UK LIMITED?
| Vencido | Sí |
|---|---|
| Próximas cuentas | |
| Próximo período contable finaliza el | 31 mar 2025 |
| Próximas cuentas vencen el | 31 dic 2025 |
| Últimas cuentas | |
| Últimas cuentas cerradas hasta | 31 mar 2024 |
¿Cuál es el estado de la última declaración de confirmación para NEC SOFTWARE SOLUTIONS UK LIMITED?
| Última declaración de confirmación cerrada hasta | 09 feb 2026 |
|---|---|
| Próxima declaración de confirmación vence | 23 feb 2026 |
| Última declaración de confirmación | |
| Próxima declaración de confirmación cerrada hasta | 09 feb 2025 |
| Vencido | No |
¿Cuáles son las últimas presentaciones para NEC SOFTWARE SOLUTIONS UK LIMITED?
| Fecha | Descripción | Documento | Tipo | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cuentas completas preparadas hasta el 31 mar 2024 | 63 páginas | AA | ||||||||||
Declaración de confirmación presentada el 09 feb 2025 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||||||||||
Cuentas completas preparadas hasta el 31 mar 2023 | 63 páginas | AA | ||||||||||
Declaración de confirmación presentada el 09 feb 2024 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||||||||||
Cuentas completas preparadas hasta el 31 mar 2022 | 60 páginas | AA | ||||||||||
Declaración de confirmación presentada el 09 feb 2023 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||||||||||
Cuentas completas preparadas hasta el 31 mar 2021 | 55 páginas | AA | ||||||||||
Cambio de datos del director Mr Stefan John Maynard el 26 nov 2021 | 2 páginas | CH01 | ||||||||||
Declaración de confirmación presentada el 09 feb 2022 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||||||||||
Modification des détails de Nps (Holdings) Limited en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 01 jul 2021 | 2 páginas | PSC05 | ||||||||||
Cese del nombramiento de Stephen James Callaghan como director el 30 jun 2021 | 1 páginas | TM01 | ||||||||||
Resoluciones Resolutions | 3 páginas | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
| ||||||||||||
Cuentas completas preparadas hasta el 31 mar 2020 | 56 páginas | AA | ||||||||||
Declaración de confirmación presentada el 09 feb 2021 con actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||||||||||
Domicilio social registrado cambiado de Peoplebuilding 2 Peoplebuilding Estate Maylands Avenue Hemel Hempstead Hertfordshire HP2 4NW a 1st Floor, Imex Centre 575-599 Maxted Road Hemel Hempstead Hertfordshire HP2 7DX el 22 ene 2021 | 1 páginas | AD01 | ||||||||||
Declaración de confirmación presentada el 17 nov 2020 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||||||||||
Cese del nombramiento de Alan George O'reilly como director el 30 sept 2020 | 1 páginas | TM01 | ||||||||||
Nombramiento de Stefan John Maynard como director el 13 jul 2020 | 2 páginas | AP01 | ||||||||||
Cuentas completas preparadas hasta el 31 mar 2019 | 58 páginas | AA | ||||||||||
Los registros se han trasladado a la ubicación de inspección registrada Queens Court Wilmslow Road Alderley Edge Cheshire SK9 7RR | 1 páginas | AD03 | ||||||||||
La dirección de inspección del registro se ha cambiado a Queens Court Wilmslow Road Alderley Edge Cheshire SK9 7RR | 1 páginas | AD02 | ||||||||||
Cese del nombramiento de Pinsent Masons Secretarial Limited como secretario el 31 mar 2020 | 1 páginas | TM02 | ||||||||||
Nombramiento de Ms Tina Jane Whitley como director el 22 nov 2019 | 2 páginas | AP01 | ||||||||||
Cese del nombramiento de Tomonori Hira como director el 22 nov 2019 | 1 páginas | TM01 | ||||||||||
Declaración de confirmación presentada el 17 nov 2019 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||||||||||
¿Quiénes son los directivos de NEC SOFTWARE SOLUTIONS UK LIMITED?
| Nombre | Nombrado el | Renunció el | Rol | Dirección | Identificación de la empresa | País de residencia | Nacionalidad | Fecha de nacimiento | Ocupación | Número | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MAYNARD, Stefan John | Director | 575-599 Maxted Road HP2 7DX Hemel Hempstead 1st Floor, Imex Centre Hertfordshire United Kingdom | England | British | 274905000002 | |||||||||
| WHITLEY, Tina Jane | Director | 575-599 Maxted Road HP2 7DX Hemel Hempstead 1st Floor, Imex Centre Hertfordshire United Kingdom | England | British | 279818300001 | |||||||||
| BARFIELD, Richard Timothy | Secretario | 4 Church Lane Shepreth SG8 6RG Royston Hertfordshire | British | 69945330001 | ||||||||||
| DARRAUGH, Peter Anthony | Secretario | 50 Chiltern Way HP23 5LD Tring Hertfordshire | British | 70239600001 | ||||||||||
| FARRIMOND, Nicholas Brian | Secretario | 51 The Avenue WD17 4NU Watford Hertfordshire | British | 75357260001 | ||||||||||
| GRANT, Robert Murray | Secretario | 30 South Parade Harbury CV33 9JE Leamington Spa Warwickshire | British | 10658540001 | ||||||||||
| HOPKINSON, Ian Michael | Secretario | 10 Harvest Bank Hyde Heath HP6 5RD Amersham Buckinghamshire | British | 53858740001 | ||||||||||
| JAY, Christopher Howard Orcombe | Secretario | 102 Rusthall Avenue W4 1BS London | British | 37881210001 | ||||||||||
| NUNN, Carol Jayne | Secretario | Boundary Way HP2 7HU Hemel Hempstead Hertfordshire | British | 101872040001 | ||||||||||
| RICHARDSON, John David | Secretario | High Street Burnham SL1 7JD Slough 27 Berks | British | 128558470001 | ||||||||||
| SCHENCK, Daniel William | Secretario | Peoplebuilding 2, Peoplebuilding Estate Marylands Avenue HP2 4NW Hemel Hempstead 3rd Floor Hertfordshire United Kingdom | Usa | 181204960001 | ||||||||||
| SMITH, Stephen Raymond | Secretario | 21 Ash Grove Wheathampstead AL4 8DF St Albans Hertfordshire | British | 35870250001 | ||||||||||
| STIER, John Robert | Secretario | 23 Coppins Close HP4 3NZ Berkhamsted Hertfordshire | British | 78901530002 | ||||||||||
| PINSENT MASONS SECRETARIAL LIMITED | Secretario corporativo | Park Row LS1 5AB Leeds 1 United Kingdom |
| 76579530001 | ||||||||||
| AL-SALEH, Adel Bedry | Director | Peoplebuilding 2, Peoplebuilding Estate Marylands Avenue HP2 4NW Hemel Hempstead 3rd Floor Hertfordshire United Kingdom | United States | American | 165900220001 | |||||||||
| BARFIELD, Richard Timothy | Director | 4 Church Lane Shepreth SG8 6RG Royston Hertfordshire | British | 69945330001 | ||||||||||
| BICKNELL, Geoffrey James | Director | 15 Quay West Ferry Road TW11 9NH Teddington Middlesex | United Kingdom | British | 70240070001 | |||||||||
| CALLAGHAN, Stephen James | Director | Peoplebuilding Estate Maylands Avenue HP2 4NW Hemel Hempstead Peoplebuilding 2 Hertfordshire United Kingdom | United Kingdom | British | 201347710052 | |||||||||
| CAUSLEY, Jeremy John | Director | 11 Bristol Mews Little Venice W9 London | British | 33042410003 | ||||||||||
| COLL, Andrew | Director | Maylands Avenue HP2 4NW Hemel Hempstead Peoplebuilding 2 Hertfordshire United Kingdom | England | British | 237260100001 | |||||||||
| COLL, Andrew | Director | Peoplebuilding 2 Peoplebuilding Estate Maylands HP2 4NW Avenue Hemel Hempstead Hertfordshire | United Kingdom | British | 164593980001 | |||||||||
| D'ABREU, Philip | Director | Peoplebuilding 2 Peoplebuilding Estate Maylands HP2 4NW Avenue Hemel Hempstead Hertfordshire | United Kingdom | Canadian | 154840870001 | |||||||||
| GODDARD, Liam Stuart | Director | 11 Napier Court Outram Road CR0 6XE Croydon | England | British | 108987960002 | |||||||||
| HEMMINGS, Giles Edward | Director | Balnald Lodge Kirkmichael PH10 7NA Blairgowrie Perthshire | United Kingdom | United Kingdom | 44393940001 | |||||||||
| HEPPELL, Carl Brian | Director | 42 Kindersley Way WD5 0DQ Abbots Langley Hertfordshire | British | 20176070001 | ||||||||||
| HIRA, Tomonori | Director | Peoplebuilding 2 Peoplebuilding Estate Maylands HP2 4NW Avenue Hemel Hempstead Hertfordshire | England | Japanese | 243018330002 | |||||||||
| JONES, Martin Lee | Director | Hall Farm House Gold Street, Podington NN29 7HX Wellingborough Northamptonshire | British | 89033240001 | ||||||||||
| KLEIN, John Elliot | Director | 52c Maresfield Gardens NW3 5RX London | American | 52109700002 | ||||||||||
| KNOX, Ian Wallace | Director | 98 Thorpe Park Road PE3 6LJ Peterborough Cambridgeshire | Great Britain | British | 8456660001 | |||||||||
| MARRISON, Michael Anthony | Director | 10 Armistead Way Cranage CW4 8FE Crewe Cheshire | England | British | 67938980003 | |||||||||
| MEADEN, David John | Director | Maylands Avenue HP2 4NW Hemel Hempstead Peoplebuilding 2 Hertfordshire United Kingdom | United Kingdom | British | 193740420001 | |||||||||
| MEADEN, David John | Director | Peoplebuilding 2, Peoplebuilding Estate, Maylands Avenue HP2 4NW Hemel Hempstead Hertfordshire | United Kingdom | British | 193740420001 | |||||||||
| NOBLE, Ian Michael | Director | Peoplebuilding 2 Peoplebuilding Estate Maylands HP2 4NW Avenue Hemel Hempstead Hertfordshire | United Kingdom | British | 126281750001 | |||||||||
| O'REILLY, Alan George | Director | Peoplebuilding Estate Maylands Avenue HP2 4NW Hemel Hempstead Peoplebuilding 2 Hertfordshire United Kingdom | United Kingdom | Irish | 220991280002 | |||||||||
| OSBORNE, Russell Thomas | Director | Coventry Road Dunchurch CV22 6RE Rugby 1 Warwickshire United Kingdom | England | British | 128999670001 |
¿Quiénes son las personas con control significativo de NEC SOFTWARE SOLUTIONS UK LIMITED?
| Nombre | Notificado el | Dirección | Cesado | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nps (Holdings) Limited | 06 abr 2016 | 575-599 Maxted Road HP2 7DX Hemel Hempstead 1st Floor, Imex Centre United Kingdom | No | ||||||||||
| |||||||||||||
Naturaleza del control
| |||||||||||||
Fuente de datos
- Companies House del Reino Unido
El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros. - Licencia: CC0