GEORGE WIMPEY SOUTH WEST LIMITED

GEORGE WIMPEY SOUTH WEST LIMITED

  • Visión general
  • Resumen
  • Propósito
  • Dirección
  • Nombres anteriores
  • Cuentas
  • Declaración de confirmación
  • Presentaciones
  • Directivos
  • Personas con control significativo
  • Fuente de datos
  • Visión general

    Nombre de la empresaGEORGE WIMPEY SOUTH WEST LIMITED
    Estado de la empresaActiva
    Forma jurídicaSociedad de responsabilidad limitada
    Número de empresa 00977340
    JurisdicciónInglaterra/Gales
    Fecha de constitución

    Resumen

    Tiene PSCs súper segurosNo
    Tiene gravámenesNo
    Tiene historial de insolvenciaNo
    La sede social está en disputaNo

    ¿Cuál es el propósito de GEORGE WIMPEY SOUTH WEST LIMITED?

    • Desarrollo de proyectos de construcción (41100) / Construcción

    ¿Dónde se encuentra GEORGE WIMPEY SOUTH WEST LIMITED?

    Dirección de la sede social
    Gate House
    Turnpike Road
    HP12 3NR High Wycombe
    Buckinghamshire
    Dirección de la sede social no entregableNo

    ¿Cuáles fueron los nombres anteriores de GEORGE WIMPEY SOUTH WEST LIMITED?

    Nombres anteriores de la empresa
    Nombre de la empresaDesdeHasta
    MCLEAN HOMES SOUTH WEST LIMITED 29 ene 199329 ene 1993
    MCLEAN HOMES SOUTHERN LIMITED16 abr 197016 abr 1970

    ¿Cuáles son las últimas cuentas de GEORGE WIMPEY SOUTH WEST LIMITED?

    VencidoNo
    Próximas cuentas
    Próximo período contable finaliza el31 dic 2025
    Próximas cuentas vencen el30 sept 2026
    Últimas cuentas
    Últimas cuentas cerradas hasta31 dic 2024

    ¿Cuál es el estado de la última declaración de confirmación para GEORGE WIMPEY SOUTH WEST LIMITED?

    Última declaración de confirmación cerrada hasta08 nov 2026
    Próxima declaración de confirmación vence22 nov 2026
    Última declaración de confirmación
    Próxima declaración de confirmación cerrada hasta08 nov 2025
    VencidoNo

    ¿Cuáles son las últimas presentaciones para GEORGE WIMPEY SOUTH WEST LIMITED?

    Presentaciones
    FechaDescripciónDocumentoTipo

    Declaración de confirmación presentada el 08 nov 2025 sin actualizaciones

    3 páginasCS01

    Cese del nombramiento de Jennifer Canty como director el 30 sept 2025

    1 páginasTM01

    Nombramiento de Sara Hollowell como director el 01 oct 2025

    2 páginasAP01

    Nombramiento de Sara Hollowell como secretario el 01 oct 2025

    2 páginasAP03

    Cese del nombramiento de Jennifer Canty como secretario el 30 sept 2025

    1 páginasTM02

    Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 31 dic 2024

    5 páginasAA

    Cese del nombramiento de Michael Andrew Lonnon como director el 09 dic 2024

    1 páginasTM01

    Nombramiento de Miss Katherine Elizabeth Hindmarsh como director el 09 dic 2024

    2 páginasAP01

    Declaración de confirmación presentada el 08 nov 2024 sin actualizaciones

    3 páginasCS01

    Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 31 dic 2023

    5 páginasAA

    Cese del nombramiento de Omolola Olutomilayo Adedoyin como secretario el 24 abr 2024

    1 páginasTM02

    Cese del nombramiento de Omolola Olutomilayo Adedoyin como director el 24 abr 2024

    1 páginasTM01

    Nombramiento de Jennifer Canty como secretario el 24 abr 2024

    2 páginasAP03

    Nombramiento de Jennifer Canty como director el 24 abr 2024

    2 páginasAP01

    Declaración de confirmación presentada el 08 nov 2023 sin actualizaciones

    3 páginasCS01

    Nombramiento de Mrs Omolola Olutomilayo Adedoyin como director el 25 sept 2023

    2 páginasAP01

    Cese del nombramiento de Katherine Elizabeth Hindmarsh como director el 25 sept 2023

    1 páginasTM01

    Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 31 dic 2022

    5 páginasAA

    Cese del nombramiento de Katherine Elizabeth Hindmarsh como secretario el 15 jun 2023

    1 páginasTM02

    Nombramiento de Mrs Omolola Olutomilayo Adedoyin como secretario el 15 jun 2023

    2 páginasAP03

    Declaración de confirmación presentada el 08 nov 2022 sin actualizaciones

    3 páginasCS01

    Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 31 dic 2021

    5 páginasAA

    Declaración de confirmación presentada el 08 nov 2021 sin actualizaciones

    3 páginasCS01

    Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 31 dic 2020

    5 páginasAA

    Los registros se han trasladado a la ubicación de inspección registrada Highdown House Yeoman Way Worthing West Sussex BN99 3HH

    1 páginasAD03

    ¿Quiénes son los directivos de GEORGE WIMPEY SOUTH WEST LIMITED?

    Directivos
    NombreNombrado elRenunció elRolDirecciónIdentificación de la empresaPaís de residenciaNacionalidadFecha de nacimientoOcupaciónNúmero
    HOLLOWELL, Sara
    Turnpike Road
    HP12 3NR High Wycombe
    Gate House
    Buckinghamshire
    Secretario
    Turnpike Road
    HP12 3NR High Wycombe
    Gate House
    Buckinghamshire
    340898840001
    HINDMARSH, Katherine Elizabeth
    Turnpike Road
    HP12 3NR High Wycombe
    Gate House
    Buckinghamshire
    United Kingdom
    Director
    Turnpike Road
    HP12 3NR High Wycombe
    Gate House
    Buckinghamshire
    United Kingdom
    United KingdomBritish330353690001
    HOLLOWELL, Sara
    Turnpike Road
    HP12 3NR High Wycombe
    Gate House
    Buckinghamshire
    Director
    Turnpike Road
    HP12 3NR High Wycombe
    Gate House
    Buckinghamshire
    United KingdomBritish200486170001
    ADEDOYIN, Omolola Olutomilayo
    Turnpike Road
    HP12 3 NR High Wycombe
    Gate House
    Bucks
    United Kingdom
    Secretario
    Turnpike Road
    HP12 3 NR High Wycombe
    Gate House
    Bucks
    United Kingdom
    310338790001
    ATTERBURY, Karen Lorraine
    Turnpike Road
    HP12 3NR High Wycombe
    Gate House
    Buckinghamshire
    United Kingdom
    Secretario
    Turnpike Road
    HP12 3NR High Wycombe
    Gate House
    Buckinghamshire
    United Kingdom
    147317630001
    BORT, Stefan Edward
    126 Grove Park
    SE5 8LD London
    Secretario
    126 Grove Park
    SE5 8LD London
    British32824200005
    CANTY, Jennifer
    Turnpike Road
    HP12 3NR High Wycombe
    Gate House
    Buckinghamshire
    Secretario
    Turnpike Road
    HP12 3NR High Wycombe
    Gate House
    Buckinghamshire
    322306550001
    CARR, Peter Anthony
    South Luffenham
    LE15 8NP Rutland
    Foxfoot House
    Secretario
    South Luffenham
    LE15 8NP Rutland
    Foxfoot House
    British130306120001
    CLAPHAM, Colin Richard
    Scotland Street
    Stoke By Nayland
    CO6 4QF Colchester
    Homestead
    Essex
    Secretario
    Scotland Street
    Stoke By Nayland
    CO6 4QF Colchester
    Homestead
    Essex
    Other135438270002
    HASTIE, Nicola Amanda Eleanor
    97 Yew Tree Lane
    Tettenhall
    WV6 8UN Wolverhampton
    Secretario
    97 Yew Tree Lane
    Tettenhall
    WV6 8UN Wolverhampton
    British76844970003
    HINDMARSH, Katherine Elizabeth
    Turnpike Road
    HP12 3NR High Wycombe
    Gate House
    Buckinghamshire
    United Kingdom
    Secretario
    Turnpike Road
    HP12 3NR High Wycombe
    Gate House
    Buckinghamshire
    United Kingdom
    219926390001
    JORDAN, James John
    Grosvenor House
    2 Church Lane
    NN6 6JP Stanford On Avon
    Northamptonshire
    Secretario
    Grosvenor House
    2 Church Lane
    NN6 6JP Stanford On Avon
    Northamptonshire
    British120602100002
    LONNON, Michael Andrew, Mr.
    Turnpike Road
    HP12 3NR High Wycombe
    Gate House
    Buckinghamshire
    United Kingdom
    Secretario
    Turnpike Road
    HP12 3NR High Wycombe
    Gate House
    Buckinghamshire
    United Kingdom
    166109680001
    PHILLIPS, James
    Stallworth
    6 Wood Road Tettenhall
    WV6 8LS Wolverhampton
    West Midlands
    Secretario
    Stallworth
    6 Wood Road Tettenhall
    WV6 8LS Wolverhampton
    West Midlands
    British8364990001
    PHILLIPS, James
    Stallworth
    6 Wood Road Tettenhall
    WV6 8LS Wolverhampton
    West Midlands
    Secretario
    Stallworth
    6 Wood Road Tettenhall
    WV6 8LS Wolverhampton
    West Midlands
    British8364990001
    ADEDOYIN, Omolola Olutomilayo
    Turnpike Road
    HP12 3 NR High Wycombe
    Gate House
    Bucks
    United Kingdom
    Director
    Turnpike Road
    HP12 3 NR High Wycombe
    Gate House
    Bucks
    United Kingdom
    United KingdomBritish193735640001
    ANDREW, Peter Robert
    Turnpike Road
    HP12 3NR High Wycombe
    Gate House
    Buckinghamshire
    United Kingdom
    Director
    Turnpike Road
    HP12 3NR High Wycombe
    Gate House
    Buckinghamshire
    United Kingdom
    EnglandBritish113503830003
    BYRNE, Christopher Paul
    135 Marlborough Road
    Old Town
    SN3 1NJ Swindon
    Wiltshire
    Director
    135 Marlborough Road
    Old Town
    SN3 1NJ Swindon
    Wiltshire
    British99756530001
    CANTY, Jennifer
    Turnpike Road
    HP12 3NR High Wycombe
    Gate House
    Buckinghamshire
    Director
    Turnpike Road
    HP12 3NR High Wycombe
    Gate House
    Buckinghamshire
    United KingdomBritish322288120001
    CARNEY, Christopher
    Turnpike Road
    HP12 3NR High Wycombe
    Gate House
    Buckinghamshire
    United Kingdom
    Director
    Turnpike Road
    HP12 3NR High Wycombe
    Gate House
    Buckinghamshire
    United Kingdom
    United KingdomBritish125216670001
    CARR, Peter Anthony
    551 Avebury Boulevard
    MK9 3DR Milton Keynes
    Beech House
    Buckinghamshire
    England
    Director
    551 Avebury Boulevard
    MK9 3DR Milton Keynes
    Beech House
    Buckinghamshire
    England
    EnglandBritish130306120001
    CLAPHAM, Colin Richard
    Turnpike Road
    HP12 3NR High Wycombe
    Gate House
    Buckinghamshire
    United Kingdom
    Director
    Turnpike Road
    HP12 3NR High Wycombe
    Gate House
    Buckinghamshire
    United Kingdom
    United KingdomBritish9684390001
    COLE, David
    4 Durrant Way
    Sway
    SO41 6DQ Lymington
    Hampshire
    Director
    4 Durrant Way
    Sway
    SO41 6DQ Lymington
    Hampshire
    EnglandBritish8895090001
    CUSHEN, Keith Morgan
    Buddleia Cottage
    High Street
    TW12 2SX Hampton
    Middlesex
    Director
    Buddleia Cottage
    High Street
    TW12 2SX Hampton
    Middlesex
    British37763770002
    FITZJOHN, Pamela Anne
    2 Tudor Mews
    Miskin
    CF72 8SL Pontyclun
    Mid Glamorgan
    Director
    2 Tudor Mews
    Miskin
    CF72 8SL Pontyclun
    Mid Glamorgan
    British107644960002
    FLETCHER, Jonathan Michael
    2 Gold View
    Rushey Platt
    SN5 8ZG Swindon
    Wiltshire
    Director
    2 Gold View
    Rushey Platt
    SN5 8ZG Swindon
    Wiltshire
    British79091140001
    GRIFFITHS, Melvyn Robert
    36 Lower Harlestone
    NN7 4EP Northampton
    Director
    36 Lower Harlestone
    NN7 4EP Northampton
    British62880360001
    HANSON, Michael David
    18 Biddel Springs
    Highworth
    SN6 7BH Swindon
    Wiltshire
    Director
    18 Biddel Springs
    Highworth
    SN6 7BH Swindon
    Wiltshire
    British57032360001
    HARDMAN, Raymond Victor
    10 Church Walk
    Ashton Keynes
    SN6 6PB Swindon
    Wiltshire
    Director
    10 Church Walk
    Ashton Keynes
    SN6 6PB Swindon
    Wiltshire
    British8472930001
    HARRISON, Roy James
    The Old Vicarage
    Monkhopton
    WV16 6SB Bridgnorth
    Shropshire
    Director
    The Old Vicarage
    Monkhopton
    WV16 6SB Bridgnorth
    Shropshire
    EnglandBritish27237570013
    HINDMARSH, Katherine Elizabeth
    Turnpike Road
    HP12 3NR High Wycombe
    Gate House
    Buckinghamshire
    United Kingdom
    Director
    Turnpike Road
    HP12 3NR High Wycombe
    Gate House
    Buckinghamshire
    United Kingdom
    United KingdomBritish257671040002
    JENKINS, Stephen Adrian
    Kingsview
    Manor Road
    HP10 8JA Penn
    Buckinghamshire
    Director
    Kingsview
    Manor Road
    HP10 8JA Penn
    Buckinghamshire
    United KingdomBritish49738660003
    JONES, David Nicholas
    Melody Farm
    The Causeway, Mark
    TA9 4PZ Highbridge
    Somerset
    Director
    Melody Farm
    The Causeway, Mark
    TA9 4PZ Highbridge
    Somerset
    British108042840001
    LONNON, Michael Andrew, Mr.
    Turnpike Road
    HP12 3NR High Wycombe
    Gate House
    Buckinghamshire
    United Kingdom
    Director
    Turnpike Road
    HP12 3NR High Wycombe
    Gate House
    Buckinghamshire
    United Kingdom
    United KingdomBritish34521340004
    MENHAM, Ian Duncan
    11 Swinley Drive
    Peatmoor
    SN5 5AP Swindon
    Wiltshire
    Director
    11 Swinley Drive
    Peatmoor
    SN5 5AP Swindon
    Wiltshire
    United KingdomBritish79153840001

    ¿Quiénes son las personas con control significativo de GEORGE WIMPEY SOUTH WEST LIMITED?

    Personas con control significativo
    NombreNotificado elDirecciónCesado
    Turnpike Road
    HP12 3NR High Wycombe
    Gate House
    Buckinghamshire
    United Kingdom
    06 abr 2016
    Turnpike Road
    HP12 3NR High Wycombe
    Gate House
    Buckinghamshire
    United Kingdom
    No
    Forma jurídicaLimited By Shares
    País de registroEngland
    Autoridad legalCompanies Act 2006
    Lugar de registroCompanies House
    Número de registro1392762
    Naturaleza del control
    • La persona posee, directa o indirectamente, más del 75% de las acciones de la compañía.
    • La persona posee, directa o indirectamente, más del 75% de los derechos de voto en la empresa.
    • La persona tiene el derecho, directa o indirectamente, de nombrar o destituir a la mayoría de la junta directiva de la empresa.

    Fuente de datos

    • Companies House del Reino Unido
      El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros.
    • Licencia: CC0