KELNIGAL GROUP LIMITED

KELNIGAL GROUP LIMITED

  • Visión general
  • Resumen
  • Propósito
  • Dirección
  • Nombres anteriores
  • Cuentas
  • Presentaciones
  • Directivos
  • Personas con control significativo
  • Gravámenes
  • Fuente de datos
  • Visión general

    Nombre de la empresaKELNIGAL GROUP LIMITED
    Estado de la empresaDisuelta
    Forma jurídicaSociedad de responsabilidad limitada
    Número de empresa 00979170
    JurisdicciónInglaterra/Gales
    Fecha de constitución
    Fecha de cese

    Resumen

    Tiene PSCs súper segurosNo
    Tiene gravámenes
    Tiene historial de insolvenciaNo
    La sede social está en disputaNo

    ¿Cuál es el propósito de KELNIGAL GROUP LIMITED?

    • Compañía no comercial (74990) / Actividades profesionales, científicas y técnicas

    ¿Dónde se encuentra KELNIGAL GROUP LIMITED?

    Dirección de la sede social
    200 Great Dover Street
    SE1 4YB London
    England
    Dirección de la sede social no entregableNo

    ¿Cuáles fueron los nombres anteriores de KELNIGAL GROUP LIMITED?

    Nombres anteriores de la empresa
    Nombre de la empresaDesdeHasta
    HIGH-POINT RENDEL GROUP LIMITED26 feb 200726 feb 2007
    HIGH-POINT RENDEL GROUP PLC14 ene 199814 ene 1998
    HIGH-POINT PLC06 oct 198806 oct 1988
    HIGH-POINT SERVICES GROUP PLC31 dic 197731 dic 1977
    HIGH-POINT CONTRACT SERVICES LIMITED08 may 197008 may 1970

    ¿Cuáles son las últimas cuentas de KELNIGAL GROUP LIMITED?

    Últimas cuentas
    Últimas cuentas cerradas hasta31 mar 2015

    ¿Cuáles son las últimas presentaciones para KELNIGAL GROUP LIMITED?

    Presentaciones
    FechaDescripciónDocumentoTipo

    Boletín oficial final disuelto por cancelación obligatoria

    1 páginasGAZ2

    Primer aviso en el boletín oficial para la cancelación obligatoria

    1 páginasGAZ1

    Declaración de confirmación presentada el 09 ene 2017 con actualizaciones

    7 páginasCS01

    Exercice comptable précédent prolongé du 31 mar 2016 au 30 sept 2016

    1 páginasAA01

    Domicilio social registrado cambiado de 61 Southwark Street London SE1 1SA a 200 Great Dover Street London SE1 4YB el 06 jul 2016

    1 páginasAD01

    Déclaration annuelle établie au 09 ene 2016 avec liste complète des actionnaires

    4 páginasAR01

    legacy

    1 páginasSH20

    Estado de capital el 12 ene 2016

    • Capital: GBP 0.01
    4 páginasSH19

    legacy

    1 páginasCAP-SS

    Resoluciones

    Resolutions
    2 páginasRESOLUTIONS
    Acuerdos
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    capital

    Resolución de reducción del capital social emitido

    RES06
    capital

    Resoluciones

    Share premium account reduced. Approval & authorisation of reduction 07/12/2015
    RES13

    Cuentas completas preparadas hasta el 31 mar 2015

    16 páginasAA

    Certificado de cambio de nombre

    Company name changed high-point rendel group LIMITED\certificate issued on 04/08/15
    2 páginasCERTNM
    Acuerdos
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    change-of-name

    Resolución de cambio de nombre de la empresa el 02 jul 2015

    RES15

    Aviso de cambio de nombre

    2 páginasCONNOT

    Cancelación total de la carga 009791700014

    6 páginasMR04

    Déclaration annuelle établie au 09 ene 2015 avec liste complète des actionnaires

    4 páginasAR01
    Presentaciones asociadas
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    capital12 ene 2015

    Estado de capital el 12 ene 2015

    • Capital: GBP 274,249.12
    SH01

    Cuentas completas preparadas hasta el 31 mar 2014

    17 páginasAA

    Renuncia del auditor

    1 páginasAUD

    Exercice comptable précédent raccourci du 19 abr 2014 au 31 mar 2014

    1 páginasAA01

    Cuentas completas preparadas hasta el 19 abr 2013

    16 páginasAA

    Déclaration annuelle établie au 05 dic 2013 avec liste complète des actionnaires

    4 páginasAR01
    Presentaciones asociadas
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    capital06 dic 2013

    Estado de capital el 06 dic 2013

    • Capital: GBP 274,249.12
    SH01

    Exercice comptable précédent raccourci du 31 jul 2013 au 19 abr 2013

    1 páginasAA01

    Cancelación total de la carga 13

    4 páginasMR04

    Registro de la carga 009791700014

    191 páginasMR01

    Cuentas completas preparadas hasta el 31 jul 2012

    16 páginasAA

    Déclaration annuelle établie au 05 dic 2012 avec liste complète des actionnaires

    4 páginasAR01

    ¿Quiénes son los directivos de KELNIGAL GROUP LIMITED?

    Directivos
    NombreNombrado elRenunció elRolDirecciónIdentificación de la empresaPaís de residenciaNacionalidadFecha de nacimientoOcupaciónNúmero
    PARSONS, Charlotte Louise
    Great Dover Street
    SE1 4YB London
    200
    England
    Secretario
    Great Dover Street
    SE1 4YB London
    200
    England
    Other135626530001
    BELL, Nigel Stuart
    Great Dover Street
    SE1 4YB London
    200
    England
    Director
    Great Dover Street
    SE1 4YB London
    200
    England
    United KingdomBritish91913690001
    HINGLEY, Kelvin William Thomas
    Great Dover Street
    SE1 4YB London
    200
    England
    Director
    Great Dover Street
    SE1 4YB London
    200
    England
    United KingdomBritish50467220002
    PARSONS, Charlotte Louise
    Great Dover Street
    SE1 4YB London
    200
    England
    Director
    Great Dover Street
    SE1 4YB London
    200
    England
    United KingdomBritish140414820004
    BEST, John David
    Milbanke 43 Lady Byron Lane
    Knowle
    B93 9AX Solihull
    West Midlands
    Secretario
    Milbanke 43 Lady Byron Lane
    Knowle
    B93 9AX Solihull
    West Midlands
    British2810080001
    DAVISON, Suzanne
    106a Coppermill Lane
    Walthamstow
    E17 7HE London
    Secretario
    106a Coppermill Lane
    Walthamstow
    E17 7HE London
    British80856470001
    DESMOND, Pat
    7 Regents Drive
    BR2 6BU Keston
    Kent
    Secretario
    7 Regents Drive
    BR2 6BU Keston
    Kent
    British52839700001
    DIXON, Leslie Albert
    167 St Bernards Road
    B92 7DH Solihull
    West Midlands
    Secretario
    167 St Bernards Road
    B92 7DH Solihull
    West Midlands
    British3640870001
    FINDLAY, Ian Scott
    4 The Cobbles
    Off Priory Walk
    B72 1XE Sutton Coldfield
    West Midlands
    Secretario
    4 The Cobbles
    Off Priory Walk
    B72 1XE Sutton Coldfield
    West Midlands
    British54138670001
    FINDLAY, Ian Scott
    4 The Cobbles
    Off Priory Walk
    B72 1XE Sutton Coldfield
    West Midlands
    Secretario
    4 The Cobbles
    Off Priory Walk
    B72 1XE Sutton Coldfield
    West Midlands
    British54138670001
    GREENWOOD, Stephen Harold
    45 New Concordia Wharf
    Mill Street
    SE1 2BB London
    Secretario
    45 New Concordia Wharf
    Mill Street
    SE1 2BB London
    British71052650001
    GREENWOOD, Stephen Harold
    45 New Concordia Wharf
    Mill Street
    SE1 2BB London
    Secretario
    45 New Concordia Wharf
    Mill Street
    SE1 2BB London
    British71052650001
    TRENDELL, William Anthony
    Victorian Rendezvous
    18 Rectory Close Merrow
    GU4 7AR Guildford
    Surrey
    Secretario
    Victorian Rendezvous
    18 Rectory Close Merrow
    GU4 7AR Guildford
    Surrey
    British12317760001
    BENNETT, Melvin Eugene
    2016 Bulrush Lane
    Cardiff By The Sea
    FOREIGN San Diego Ca 92007 Usa
    Director
    2016 Bulrush Lane
    Cardiff By The Sea
    FOREIGN San Diego Ca 92007 Usa
    American43502520002
    DESMOND, Pat
    7 Regents Drive
    BR2 6BU Keston
    Kent
    Director
    7 Regents Drive
    BR2 6BU Keston
    Kent
    British52839700001
    DIXON, Leslie Albert
    167 St Bernards Road
    B92 7DH Solihull
    West Midlands
    Director
    167 St Bernards Road
    B92 7DH Solihull
    West Midlands
    British3640870001
    FINDLAY, Ian Scott
    4 The Cobbles
    Off Priory Walk
    B72 1XE Sutton Coldfield
    West Midlands
    Director
    4 The Cobbles
    Off Priory Walk
    B72 1XE Sutton Coldfield
    West Midlands
    British54138670001
    GREENWOOD, Stephen Harold
    45 New Concordia Wharf
    Mill Street
    SE1 2BB London
    Director
    45 New Concordia Wharf
    Mill Street
    SE1 2BB London
    British71052650001
    HOOKWAY, David Wilfred
    68 Hartley Old Road
    CR8 4HJ Purley
    Surrey
    Director
    68 Hartley Old Road
    CR8 4HJ Purley
    Surrey
    British374710001
    JOHNSON, Peter
    54 Mymms Drive
    Brookmans Park
    AL9 7AF Hatfield
    Hertfordshire
    Director
    54 Mymms Drive
    Brookmans Park
    AL9 7AF Hatfield
    Hertfordshire
    British11342310001
    PALMER, Horace Anthony
    Fairfield London Road
    Sunninghill
    SL5 0PH Ascot
    Berkshire
    Director
    Fairfield London Road
    Sunninghill
    SL5 0PH Ascot
    Berkshire
    United KingdomBritish45646020002
    PERREY, Derek Randall
    Oaklands Rockbear Hill
    Marsh Green
    EX5 2EZ Exeter
    Director
    Oaklands Rockbear Hill
    Marsh Green
    EX5 2EZ Exeter
    British12614160001
    REEVES, Ian William
    Hewletts Mill
    Galhampton
    BA22 7BG Yeovil
    Somerset
    Director
    Hewletts Mill
    Galhampton
    BA22 7BG Yeovil
    Somerset
    British71881990001
    REEVES, Ian William
    Hewletts Mill
    Galhampton
    BA22 7BG Yeovil
    Somerset
    Director
    Hewletts Mill
    Galhampton
    BA22 7BG Yeovil
    Somerset
    British71881990001
    SHEPPARD, Allen John George, The Right Honourable Lord
    Didgmere Hall Low Hill Road
    Roydon
    CM19 5JN Harlow
    Essex
    Director
    Didgmere Hall Low Hill Road
    Roydon
    CM19 5JN Harlow
    Essex
    Great BritainBritish66789210001
    SMITH, Martin Christopher Geoffrey
    9 Finlarigg Drive
    Edgbaston
    B15 3RH Birmingham
    West Midlands
    Director
    9 Finlarigg Drive
    Edgbaston
    B15 3RH Birmingham
    West Midlands
    EnglandBritish71281420001
    STUBBS, Robert John
    40 Tolmers Road
    Cuffley
    EN6 4JF Potters Bar
    Hertfordshire
    Director
    40 Tolmers Road
    Cuffley
    EN6 4JF Potters Bar
    Hertfordshire
    United KingdomBritish40694340001
    TREE, David George
    East Wickham 59 College Lane
    Hurstpierpoint
    BN6 9AD Hassocks
    West Sussex
    Director
    East Wickham 59 College Lane
    Hurstpierpoint
    BN6 9AD Hassocks
    West Sussex
    British64855130001
    TRENDELL, William Anthony
    Victorian Rendezvous
    18 Rectory Close Merrow
    GU4 7AR Guildford
    Surrey
    Director
    Victorian Rendezvous
    18 Rectory Close Merrow
    GU4 7AR Guildford
    Surrey
    EnglandBritish12317760001
    WHARTON, Robert Victor
    Seven Clare Drive
    Edgbaston
    B15 3LP Birmingham
    West Midlands
    Director
    Seven Clare Drive
    Edgbaston
    B15 3LP Birmingham
    West Midlands
    United KingdomBritish3640880001

    ¿Quiénes son las personas con control significativo de KELNIGAL GROUP LIMITED?

    Personas con control significativo
    NombreNotificado elDirecciónCesado
    Mr Kelvin William Thomas Hingley
    Great Dover Street
    SE1 4YB London
    200
    England
    06 abr 2016
    Great Dover Street
    SE1 4YB London
    200
    England
    No
    Nacionalidad: British
    País de residencia: United Kingdom
    Naturaleza del control
    • La persona posee, directa o indirectamente, más del 25% pero no más del 50% de las acciones de la compañía.
    Mr Nigel Stuart Bell
    Great Dover Street
    SE1 4YB London
    200
    England
    06 abr 2016
    Great Dover Street
    SE1 4YB London
    200
    England
    No
    Nacionalidad: British
    País de residencia: United Kingdom
    Naturaleza del control
    • La persona posee, directa o indirectamente, más del 25% pero no más del 50% de las acciones de la compañía.

    ¿Tiene KELNIGAL GROUP LIMITED alguna carga?

    Gravámenes
    ClasificaciónFechasEstadoDetalles
    A registered charge
    Creado el 22 abr 2013
    Entregado el 10 may 2013
    Satisfecho en su totalidad
    Breve descripción
    Trade mark: hp-high point. Class: 16. registration number: 1074975. notification of addition to or amendment of charge.
    La garantía flotante cubre todo:
    Contiene una garantía flotante:
    Contiene una garantía fija:
    Personas con derecho
    • 20-20 Trustees Limited
    • Bridge Trustees Limited
    Transacciones
    • 10 may 2013Registro de una carga (MR01)
    • 24 jul 2015Satisfacción de una carga (MR04)
    Debenture
    Creado el 27 may 2010
    Entregado el 04 jun 2010
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill uncalled capital buildings fixtures plant and machinery.
    Personas con derecho
    • National Westminster Bank PLC
    Transacciones
    • 04 jun 2010Registro de un cargo (MG01)
    • 27 jun 2013Satisfacción de una carga (MR04)
    Debenture
    Creado el 19 jul 2005
    Entregado el 27 jul 2005
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • Arab National Bank
    Transacciones
    • 27 jul 2005Registro de un cargo (395)
    • 28 may 2010Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (MG02)
    Guarantee and debenture by the company and high-point rendel limited, high-point europe limited, vantagepoint management consultants (public sector) limited
    Creado el 04 jul 2001
    Entregado el 24 jul 2001
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personas con derecho
    • Barclays Bank PLC
    Transacciones
    • 24 jul 2001Registro de un cargo (395)
    • 08 mar 2007Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Charge
    Creado el 16 feb 1999
    Entregado el 17 feb 1999
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    Book debts and all the goodwill of the business. Undertaking and all property and assets present and future including uncalled capital.
    Personas con derecho
    • Barclays Mercantile Business Finance Limited
    Transacciones
    • 17 feb 1999Registro de un cargo (395)
    • 08 mar 2007Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Deed of assignment
    Creado el 10 jun 1997
    Entregado el 19 jun 1997
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever and under the terms of the facility agreement being the master facilities agreement dated 9 june 1997 (as therein defined)
    Breve descripción
    The agreement being the placing and offer agreement dated 10/6/97 relating to a placing and open offer of ordinary shares of 1P each in high-point PLC and the benefit of the same and assigns all right title and interest in and to all moneys owing under the agreement. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • Barclays Bank PLC
    Transacciones
    • 19 jun 1997Registro de un cargo (395)
    • 08 mar 2007Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Guarantee and debenture
    Creado el 09 oct 1995
    Entregado el 12 oct 1995
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • Barclays Bank PLC
    Transacciones
    • 12 oct 1995Registro de un cargo (395)
    • 08 mar 2007Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Debenture
    Creado el 14 jun 1989
    Entregado el 20 jun 1989
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personas con derecho
    • Barclays Bank PLC
    Transacciones
    • 20 jun 1989Registro de una carga
    • 08 mar 2007Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Legal charge
    Creado el 16 dic 1986
    Entregado el 05 ene 1987
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    No 11 amen lodge ave. Maria lane l/b or the city of london t/no - lgl 427936.
    Personas con derecho
    • Barclays Bank PLC
    Transacciones
    • 05 ene 1987Registro de una carga
    • 08 mar 2007Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Legal charge
    Creado el 16 dic 1986
    Entregado el 05 ene 1987
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    The penthouse, amen lodge ave, maria lane l/borne city of london t/no-ngl 137194.
    Personas con derecho
    • Barclays Bank PLC
    Transacciones
    • 05 ene 1987Registro de una carga
    • 08 mar 2007Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Legal charge
    Creado el 30 ene 1985
    Entregado el 06 feb 1985
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    Property situate and known as the penthouse amen lodge, warwick lane london EC4 title no ngl 137194 and flat 11 amen lodge warwick lane london EC4 title no ngl 427936 together with all buildings, trade and other fixtures, fixed plant and machinery. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Personas con derecho
    • City Bank N.A.
    Transacciones
    • 06 feb 1985Registro de una carga
    • 20 ene 1994Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Mortgage debenture
    Creado el 01 jul 1982
    Entregado el 15 jul 1982
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    A specific equitable charge over all freehold and leasehold properties and/or the proceeds of sale thereof fixed and floating charges over undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts and the benefits of any licences.
    Personas con derecho
    • National Westminster Bank PLC
    Transacciones
    • 15 jul 1982Registro de una carga
    Legal charge
    Creado el 01 oct 1980
    Entregado el 06 oct 1980
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    L/Hold 6TH & part 7TH floor of king edward house, new st. Birmingham B2 4QW. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Personas con derecho
    • National Westminster Bank PLC
    Transacciones
    • 06 oct 1980Registro de una carga
    • 09 jul 2005Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Legal mortgage
    Creado el 11 ago 1980
    Entregado el 21 ago 1980
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    2A highfield road, dartford kent, title no k 464228. floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Personas con derecho
    • National Westminster Bank PLC
    Transacciones
    • 21 ago 1980Registro de una carga
    • 09 jul 2005Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)

    Fuente de datos

    • Companies House del Reino Unido
      El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros.
    • Licencia: CC0