CENTRAL TRAILER RENTCO LIMITED

CENTRAL TRAILER RENTCO LIMITED

  • Visión general
  • Resumen
  • Propósito
  • Dirección
  • Nombres anteriores
  • Cuentas
  • Presentaciones
  • Directivos
  • Personas con control significativo
  • Declaraciones de personas con control significativo
  • Gravámenes
  • Insolvencia
  • Fuente de datos
  • Visión general

    Nombre de la empresaCENTRAL TRAILER RENTCO LIMITED
    Estado de la empresaDisuelta
    Forma jurídicaSociedad de responsabilidad limitada
    Número de empresa 00981659
    JurisdicciónInglaterra/Gales
    Fecha de constitución
    Fecha de cese

    Resumen

    Tiene PSCs súper segurosNo
    Tiene gravámenes
    Tiene historial de insolvencia
    La sede social está en disputaNo

    ¿Cuál es el propósito de CENTRAL TRAILER RENTCO LIMITED?

    • Otras actividades de apoyo a los negocios n.c.p. (82990) / Actividades administrativas y de apoyo

    ¿Dónde se encuentra CENTRAL TRAILER RENTCO LIMITED?

    Dirección de la sede social
    1 More London Place
    SE1 2AF London
    Dirección de la sede social no entregableNo

    ¿Cuáles fueron los nombres anteriores de CENTRAL TRAILER RENTCO LIMITED?

    Nombres anteriores de la empresa
    Nombre de la empresaDesdeHasta
    RENTCO NATIONWIDE LIMITED09 jun 197009 jun 1970

    ¿Cuáles son las últimas cuentas de CENTRAL TRAILER RENTCO LIMITED?

    Últimas cuentas
    Últimas cuentas cerradas hasta30 jun 2016

    ¿Cuáles son las últimas presentaciones para CENTRAL TRAILER RENTCO LIMITED?

    Presentaciones
    FechaDescripciónDocumentoTipo

    Gaceta final disuelta tras la liquidación

    1 páginasGAZ2

    Devolución de la reunión final en una liquidación voluntaria de miembros

    10 páginasLIQ13

    Misceláneos

    Form AD03/historic register/members
    2 páginasMISC

    Declaración de solvencia

    5 páginasLIQ01

    Los registros se han trasladado a la ubicación de inspección registrada Oakwood Corporate Services Limited 3rd Floor Ashley Road Altrincham Cheshire WA14 2DT

    2 páginasAD03

    La dirección de inspección del registro se ha cambiado a Oakwood Corporate Services Limited 3rd Floor Ashley Road Altrincham Cheshire WA14 2DT

    2 páginasAD02

    Domicilio social registrado cambiado de , 3rd Floor, 1 Ashley Road, Altrincham, Cheshire, WA14 2DT a 1 More London Place London SE1 2AF el 12 ene 2018

    2 páginasAD01

    Nombramiento de un liquidador voluntario

    4 páginas600

    Resoluciones

    Resolutions
    1 páginasRESOLUTIONS
    Acuerdos
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    liquidation

    Acuerdo especial para la liquidación el 21 dic 2017

    LRESSP

    Notification de Ge Ese Uk Limited en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 06 abr 2016

    2 páginasPSC02

    Retrait d'une déclaration relative à une personne disposant d'un contrôle significatif le 28 dic 2017

    2 páginasPSC09

    Declaración de confirmación presentada el 31 oct 2017 sin actualizaciones

    3 páginasCS01

    Cese del nombramiento de Joseph Preston Swithenbank como director el 11 sept 2017

    1 páginasTM01

    Cese del nombramiento de Neil Campbell Smith como director el 14 jun 2017

    1 páginasTM01

    Nombramiento de Jonathan Lawrence John Gatt como director el 30 mar 2017

    2 páginasAP01

    Cuentas completas preparadas hasta el 30 jun 2016

    17 páginasAA

    Declaración de confirmación presentada el 31 oct 2016 con actualizaciones

    5 páginasCS01

    Segunda presentación para el nombramiento de Neil Smith como director

    6 páginasRP04AP01

    Cambio de datos del director Joseph Preston Swithenbank el 31 ago 2016

    2 páginasCH01

    Cambio de datos del director Joseph Preston Swithenbank el 31 ago 2016

    2 páginasCH01

    legacy

    1 páginasSH20

    Estado de capital el 04 mar 2016

    • Capital: GBP 1
    4 páginasSH19

    legacy

    1 páginasCAP-SS

    Resoluciones

    Resolutions
    1 páginasRESOLUTIONS
    Acuerdos
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    capital

    Resoluciones

    Cancellation of captial redemption reserve 19/02/2016
    RES13

    Resoluciones

    Resolutions
    1 páginasRESOLUTIONS
    Acuerdos
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    capital

    Resolución de reducción del capital social emitido

    RES06

    ¿Quiénes son los directivos de CENTRAL TRAILER RENTCO LIMITED?

    Directivos
    NombreNombrado elRenunció elRolDirecciónIdentificación de la empresaPaís de residenciaNacionalidadFecha de nacimientoOcupaciónNúmero
    OAKWOOD CORPORATE SECRETARY LIMITED
    Floor
    1 Ashley Road
    WA14 2DT Altrincham
    3rd
    Cheshire
    United Kingdom
    Secretario corporativo
    Floor
    1 Ashley Road
    WA14 2DT Altrincham
    3rd
    Cheshire
    United Kingdom
    Tipo de identificaciónEEE
    Número de registro7038430
    146358090001
    GATT, Jonathan Lawrence John
    201 Talgarth Road
    Hammersmith
    W6 8BJ London
    The Ark
    United Kingdom
    Director
    201 Talgarth Road
    Hammersmith
    W6 8BJ London
    The Ark
    United Kingdom
    United KingdomMaltese228824220001
    ENOCH, Simon Jocelyn
    38 Chiddingstone Street
    Fulham
    SW6 3TG London
    Secretario
    38 Chiddingstone Street
    Fulham
    SW6 3TG London
    British61314280001
    PRICE, Philip Ian
    4 Queenswood Avenue
    Hutton
    CM13 1HR Brentwood
    Essex
    Secretario
    4 Queenswood Avenue
    Hutton
    CM13 1HR Brentwood
    Essex
    British75578650002
    A G SECRETARIAL LIMITED
    100 Barbirolli Square
    M2 3AB Manchester
    Secretario corporativo
    100 Barbirolli Square
    M2 3AB Manchester
    90084920001
    HAMMOND SUDDARDS SECRETARIES LIMITED
    7 Devonshire Square
    Cutlers Gardens
    EC2M 4YH London
    Secretario corporativo
    7 Devonshire Square
    Cutlers Gardens
    EC2M 4YH London
    67382580002
    TRAF SHELF (NOMINEES) LIMITED
    Trafalgar House
    29 Park Place
    LS1 2SP Leeds
    West Yorkshire
    Secretario corporativo
    Trafalgar House
    29 Park Place
    LS1 2SP Leeds
    West Yorkshire
    50087010001
    BEADLE, Paul Laurence
    Old Hall Road
    M33 2HR Sale
    Dovecote House
    Cheshire
    Director
    Old Hall Road
    M33 2HR Sale
    Dovecote House
    Cheshire
    United KingdomBritish100238650001
    CAKEBREAD, David
    The Quadrant
    Aztec West
    BS32 4GQ Bristol
    2630
    United Kingdom
    Director
    The Quadrant
    Aztec West
    BS32 4GQ Bristol
    2630
    United Kingdom
    United KingdomBritish183172770001
    CHANDLER, Andrew Philip
    66 Baywell
    Leybourne
    ME19 5QQ West Malling
    Kent
    Director
    66 Baywell
    Leybourne
    ME19 5QQ West Malling
    Kent
    British53832740001
    CITRON, Zachary Joseph
    23 Holders Hill Crescent
    NW14 1NE London
    Director
    23 Holders Hill Crescent
    NW14 1NE London
    British91783950001
    CLARK, John Robert Morton
    20 Mount Avenue
    Ealing
    W5 2RG London
    Director
    20 Mount Avenue
    Ealing
    W5 2RG London
    EnglandBritish79328330001
    CLARK, Roy Graham
    18 Rosary Gardens
    SW7 4NT London
    Director
    18 Rosary Gardens
    SW7 4NT London
    British65257100001
    CLUBB, Ian Mcmaster
    Pond House
    EN5 4PS Hadley Green
    Hertfordshire
    Director
    Pond House
    EN5 4PS Hadley Green
    Hertfordshire
    British3485960001
    CROWTHER, Jonathan Michael
    11 Wheatley Rise
    LS29 8SQ Ilkley
    West Yorkshire
    Director
    11 Wheatley Rise
    LS29 8SQ Ilkley
    West Yorkshire
    EnglandBritish49068160001
    ENOCH, Simon Jocelyn
    38 Chiddingstone Street
    Fulham
    SW6 3TG London
    Director
    38 Chiddingstone Street
    Fulham
    SW6 3TG London
    EnglandBritish61314280001
    FOSTER, Roy Garvin
    Bowerbank
    36 St Marks Road
    RG9 1LW Henley On Thames
    Oxfordshire
    Director
    Bowerbank
    36 St Marks Road
    RG9 1LW Henley On Thames
    Oxfordshire
    British37099790002
    FREDHOLM, James William
    76 Staveley Road
    Chiswick
    W4 3HU London
    Director
    76 Staveley Road
    Chiswick
    W4 3HU London
    American33092100001
    GOODWIN, Stephen Keith
    Tumblewood Cottage 23 Beacon Way
    SM7 1DZ Banstead
    Surrey
    Director
    Tumblewood Cottage 23 Beacon Way
    SM7 1DZ Banstead
    Surrey
    British5343520001
    GREEN, Pamela Anne
    7 Belgravia Road
    St Johns
    WF1 3JP Wakefield
    West Yorkshire
    Director
    7 Belgravia Road
    St Johns
    WF1 3JP Wakefield
    West Yorkshire
    British38435990009
    HOWELL, David
    Flat 10 The Isabella
    Hatchford Park Ockham Lane
    KT11 1LR Cobham
    Surrey
    Director
    Flat 10 The Isabella
    Hatchford Park Ockham Lane
    KT11 1LR Cobham
    Surrey
    United KingdomBritish109591300001
    MONTAGUE, Robert Joel
    Pusey House
    SN7 8QB Pusey
    Oxfordshire
    Director
    Pusey House
    SN7 8QB Pusey
    Oxfordshire
    British65130630002
    OSBORNE, Richard Wallace Gollin Osborne
    5 Northfield Wall
    59 North Road Highgate
    N6 London
    Director
    5 Northfield Wall
    59 North Road Highgate
    N6 London
    Australian17452320001
    RAINE, Richard Denby
    1 Acris Street
    SW18 2QT London
    Director
    1 Acris Street
    SW18 2QT London
    British50519950001
    RIEDIJK, Hans Arie
    Trompenburo Straat 10m
    1079 TX Amsterdam
    The Netherlands
    Director
    Trompenburo Straat 10m
    1079 TX Amsterdam
    The Netherlands
    Dutch57483360001
    SMITH, Neil Campbell
    201 Talgarth Road
    Hammersmith
    W6 8BJ London
    The Ark
    United Kingdom
    Director
    201 Talgarth Road
    Hammersmith
    W6 8BJ London
    The Ark
    United Kingdom
    United KingdomBritish183029170001
    SMITS, Robert Anthony
    Heemraadschapslaan 2
    1181 Vb
    Amstelveen
    Director
    Heemraadschapslaan 2
    1181 Vb
    Amstelveen
    Dutch54592350001
    STONE, Richard
    6 Birchways
    WA4 5DQ Appleton
    Cheshire
    Director
    6 Birchways
    WA4 5DQ Appleton
    Cheshire
    British75179060001
    SWITHENBANK, Joseph Preston
    201 Talgarth Road
    Hammersmith
    W6 8BJ London
    The Ark
    United Kingdom
    Director
    201 Talgarth Road
    Hammersmith
    W6 8BJ London
    The Ark
    United Kingdom
    United KingdomUs Citizen183236480004
    T I P EUROPE LIMITED
    Floor
    1 Ashley Road
    WA14 2DT Altrincham
    3rd
    Cheshire
    United Kingdom
    Director corporativo
    Floor
    1 Ashley Road
    WA14 2DT Altrincham
    3rd
    Cheshire
    United Kingdom
    65164760003

    ¿Quiénes son las personas con control significativo de CENTRAL TRAILER RENTCO LIMITED?

    Personas con control significativo
    NombreNotificado elDirecciónCesado
    1 Ashley Road
    WA14 2DT Altrincham
    3rd Floor
    Cheshire
    United Kingdom
    06 abr 2016
    1 Ashley Road
    WA14 2DT Altrincham
    3rd Floor
    Cheshire
    United Kingdom
    No
    Forma jurídicaLimited By Shares
    País de registroEngland
    Autoridad legalUnited Kingdom (England)
    Lugar de registroCompanies House
    Número de registro1329406
    Naturaleza del control
    • La persona posee, directa o indirectamente, más del 75% de las acciones de la compañía.
    • La persona posee, directa o indirectamente, más del 75% de los derechos de voto en la empresa.
    • La persona tiene el derecho, directa o indirectamente, de nombrar o destituir a la mayoría de la junta directiva de la empresa.

    ¿Cuáles son las últimas declaraciones sobre personas con control significativo para CENTRAL TRAILER RENTCO LIMITED?

    Declaraciones de personas con control significativo
    Notificado elCesado elDeclaración
    31 oct 201601 dic 2017La empresa aún no ha completado las medidas razonables para determinar si existe alguna persona que sea una persona registrable o una entidad jurídica relevante registrable en relación con la empresa.

    ¿Tiene CENTRAL TRAILER RENTCO LIMITED alguna carga?

    Gravámenes
    ClasificaciónFechasEstadoDetalles
    Debenture
    Creado el 26 jul 1996
    Entregado el 30 jul 1996
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee under, or pursuant to the credit agreement, the indenture, the notes, the company's bank guarantee, the company's noteholder guarantee, the new asset financing guarantees and the other secured documents
    Breve descripción
    .. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • The Law Debenture Trust Corporation P.L.C.as Security Trustee for the Secured Parties
    Transacciones
    • 30 jul 1996Registro de un cargo (395)
    • 03 may 2001Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Mortgage
    Creado el 14 ago 1995
    Entregado el 01 sept 1995
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee pursuant to the lease agreement dated 29TH december 1989 (as defined),as amended by supplemental agreements dated 31ST december 1991 and 14TH august 1995
    Breve descripción
    The trailers as described in the attached schedule with all accessories,components,parts......etc. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • Trinity (Jersey) Limited
    Transacciones
    • 01 sept 1995Registro de un cargo (395)
    • 30 may 1996Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Debenture
    Creado el 15 mar 1994
    Entregado el 21 mar 1994
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee as security trustee for the secured parties (as defined therein) or the banks (as defined in the credit agreement dated 13TH february 1994) on any account whatsoever under the terms of the said credit agreement and a guarantee dated 15TH march 1994 and the other documents relating thereto (each as defined in the credit agreement)
    Breve descripción
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • The Law Debenture Trust Corporation P.L.C.
    Transacciones
    • 21 mar 1994Registro de un cargo (395)
    • 05 jul 2001Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Deed of charge
    Creado el 30 sept 1988
    Entregado el 19 oct 1988
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee pursuant to the first agreements of various dates
    Breve descripción
    All the company's right title & interest in the monies then or thereafterpayable to the company by the sub-leases pursuant to the terms of the sub-lease agreements.
    Personas con derecho
    • Mdfc Industrial Finance Limtied.
    Transacciones
    • 19 oct 1988Registro de una carga
    • 22 jun 2001Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Deed of charge
    Creado el 21 jul 1988
    Entregado el 11 ago 1988
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the charge.
    Breve descripción
    All the company's right title and interest in the monies payable to the company by the sub-lessees pursuant to the sub lease agreements (see form 395 for full details).
    Personas con derecho
    • Svenska Finans (UK) Limited.
    Transacciones
    • 11 ago 1988Registro de una carga
    • 19 jul 2001Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Deed of charge
    Creado el 28 jun 1988
    Entregado el 18 jul 1988
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee under or by virtue of the first agreements and under the terms of the c harge.
    Breve descripción
    All the company's right title and interest in the monies payable to the company by the sub-lessees pursuant to the sublease agreements (see form 395 for full details).
    Personas con derecho
    • Ball Leasing Limited.
    Transacciones
    • 18 jul 1988Registro de una carga
    • 22 jun 2001Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Legal charge
    Creado el 31 mar 1988
    Entregado el 07 abr 1988
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    Unit 3 badminton court church street amersham buckinghamshire title no. Bm 86544.
    Personas con derecho
    • Midland Bank PLC
    Transacciones
    • 07 abr 1988Registro de una carga
    • 22 jun 2001Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Deed of charge
    Creado el 22 feb 1988
    Entregado el 25 feb 1988
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms or by virtue of all conditional sale, hire purchase leas ing and/or bailment contracts under the terms of the charge
    Breve descripción
    All the company's rights title and interest in and to all agreements entered into or to be entered into by the company with third parties (see form 395 for full details).
    Personas con derecho
    • Security Pacific Eurofinance Inc
    Transacciones
    • 25 feb 1988Registro de una carga
    • 22 jun 2001Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Debenture
    Creado el 22 feb 1988
    Entregado el 25 feb 1988
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the security documents of even date
    Breve descripción
    Floating charge all its undertaking and all property and assets present and future.
    Personas con derecho
    • Security Pacific Eurofinance, Inc.
    Transacciones
    • 25 feb 1988Registro de una carga
    • 07 oct 1993Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Charge
    Creado el 23 dic 1987
    Entregado el 12 ene 1988
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of any agreement and under the terms of the charge
    Breve descripción
    Any agreement entered into whether before on or after the date hereof b etween the company and a person to whom the company lets or agrees to let goods. (For full details see form 395).
    Personas con derecho
    • Midland Mortgage Leasing Limited
    Transacciones
    • 12 ene 1988Registro de una carga
    • 22 jun 2001Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)

    ¿Tiene CENTRAL TRAILER RENTCO LIMITED algún caso de insolvencia?

    Número de expedienteFechasTipoProfesionalesOtro
    1
    FechaTipo
    21 dic 2017Inicio de la liquidación
    10 abr 2019Fecha de disolución
    Liquidación voluntaria de socios
    NombreRolDirecciónNombrado elCesado el
    Samantha Keen
    1 More London Place
    SE1 2AF London
    Profesional
    1 More London Place
    SE1 2AF London
    Richard Barker
    1 More London Place
    SE1 2AF London
    Profesional
    1 More London Place
    SE1 2AF London

    Fuente de datos

    • Companies House del Reino Unido
      El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros.
    • Licencia: CC0