G & A E SLINGSBY LIMITED

G & A E SLINGSBY LIMITED

  • Visión general
  • Resumen
  • Propósito
  • Dirección
  • Nombres anteriores
  • Cuentas
  • Presentaciones
  • Directivos
  • Gravámenes
  • Fuente de datos
  • Visión general

    Nombre de la empresaG & A E SLINGSBY LIMITED
    Estado de la empresaDisuelta
    Forma jurídicaSociedad de responsabilidad limitada
    Número de empresa 00982921
    JurisdicciónInglaterra/Gales
    Fecha de constitución
    Fecha de cese

    Resumen

    Tiene PSCs súper segurosNo
    Tiene gravámenes
    Tiene historial de insolvenciaNo
    La sede social está en disputaNo

    ¿Cuál es el propósito de G & A E SLINGSBY LIMITED?

    • (7499) /

    ¿Dónde se encuentra G & A E SLINGSBY LIMITED?

    Dirección de la sede social
    Parkview 1220
    Arlington Business Park Theale
    RG7 4GA Reading
    Dirección de la sede social no entregableNo

    ¿Cuáles fueron los nombres anteriores de G & A E SLINGSBY LIMITED?

    Nombres anteriores de la empresa
    Nombre de la empresaDesdeHasta
    NEOLITH LIMITED01 dic 198901 dic 1989
    NEOLITH CHEMICALS LIMITED24 jun 197024 jun 1970

    ¿Cuáles son las últimas cuentas de G & A E SLINGSBY LIMITED?

    Últimas cuentas
    Últimas cuentas cerradas hasta31 jul 2009

    ¿Cuáles son las últimas presentaciones para G & A E SLINGSBY LIMITED?

    Presentaciones
    FechaDescripciónDocumentoTipo

    Boletín oficial final disuelto por cancelación voluntaria

    1 páginasGAZ2(A)

    Primer aviso en el boletín oficial para la cancelación voluntaria

    1 páginasGAZ1(A)

    Solicitud de exclusión de la empresa del registro

    3 páginasDS01

    Estado de capital el 08 sept 2010

    • Capital: GBP 1
    4 páginasSH19

    legacy

    1 páginasSH20

    legacy

    1 páginasCAP-SS

    Resoluciones

    Resolutions
    3 páginasRESOLUTIONS
    Acuerdos
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    capital

    Resolución de reducción del capital social emitido

    RES06
    capital

    Resoluciones

    Share premium & undistributable reserves cancelled 31/08/2010
    RES13

    Déclaration annuelle établie au 01 jun 2010 avec liste complète des actionnaires

    4 páginasAR01

    Cese del nombramiento de un director

    1 páginasTM01

    Nombramiento de Mr Robert Andrew Ross Smith como director

    2 páginasAP01

    Cambio de datos del director Stephen Webster el 01 oct 2009

    2 páginasCH01

    Cambio de datos del secretario Alison Drew el 01 oct 2009

    1 páginasCH03

    Cuentas preparadas hasta el 31 jul 2009

    5 páginasAA

    legacy

    3 páginas363a

    Cuentas preparadas hasta el 31 jul 2008

    5 páginasAA

    legacy

    3 páginas363a

    Cuentas preparadas hasta el 31 jul 2007

    5 páginasAA

    legacy

    5 páginas363a

    legacy

    1 páginas288b

    legacy

    2 páginas288a

    Cuentas preparadas hasta el 31 jul 2006

    6 páginasAA

    legacy

    2 páginas363a

    Cuentas preparadas hasta el 31 jul 2005

    6 páginasAA

    legacy

    1 páginas288c

    legacy

    3 páginas363a

    ¿Quiénes son los directivos de G & A E SLINGSBY LIMITED?

    Directivos
    NombreNombrado elRenunció elRolDirecciónIdentificación de la empresaPaís de residenciaNacionalidadFecha de nacimientoOcupaciónNúmero
    DREW, Alison
    Parkview 1220
    Arlington Business Park Theale
    RG7 4GA Reading
    Secretario
    Parkview 1220
    Arlington Business Park Theale
    RG7 4GA Reading
    British86845230002
    SMITH, Robert Andrew Ross
    Arlington Business Park
    Theale
    RG7 4GA Reading
    Parkview 1220
    United Kingdom
    Director
    Arlington Business Park
    Theale
    RG7 4GA Reading
    Parkview 1220
    United Kingdom
    United KingdomBritishAccountant150753930001
    WEBSTER, Stephen Paul
    Parkview 1220
    Arlington Business Park Theale
    RG7 4GA Reading
    Director
    Parkview 1220
    Arlington Business Park Theale
    RG7 4GA Reading
    United KingdomBritishCompany Director40201730005
    WOLSELEY DIRECTORS LIMITED
    Parkview 1220
    Arlington Business Park, Theale
    RG7 4GA Reading
    Director corporativo
    Parkview 1220
    Arlington Business Park, Theale
    RG7 4GA Reading
    122185200001
    MORRIS, Anthony Charles
    42 Walnut Way
    Hyde Heath
    HP6 5SD Amersham
    Buckinghamshire
    Secretario
    42 Walnut Way
    Hyde Heath
    HP6 5SD Amersham
    Buckinghamshire
    British28467660001
    PARKER, Edward Geoffrey
    The Homestead
    133 Malvern Road
    WR2 4LN Worcester
    Secretario
    The Homestead
    133 Malvern Road
    WR2 4LN Worcester
    BritishChartered Secretary37378570013
    SMITH, Brian Frederick
    Leawood
    Bell Lane Broadheath
    WR15 8QX Tenbury Wells
    Worcestershire
    Secretario
    Leawood
    Bell Lane Broadheath
    WR15 8QX Tenbury Wells
    Worcestershire
    British6030670001
    WHITE, Mark Jonathan
    38 Grange Close
    Church Road Nascot Wood
    WD17 4HQ Watford
    Hertfordshire
    Secretario
    38 Grange Close
    Church Road Nascot Wood
    WD17 4HQ Watford
    Hertfordshire
    British82978250001
    WOODWARD, William Edward
    19 Tideswell Close
    West Hunsbury
    NN4 9XY Northampton
    Northamptonshire
    Secretario
    19 Tideswell Close
    West Hunsbury
    NN4 9XY Northampton
    Northamptonshire
    British11797040001
    BRANSON, David Anthony
    32 Chestnut Drive
    Shenstone
    WS14 0JH Lichfield
    Staffordshire
    Director
    32 Chestnut Drive
    Shenstone
    WS14 0JH Lichfield
    Staffordshire
    BritishCompany Director/Secretary272310001
    BUCKETT, Cecil John
    Vectis House 10 Cherry Hill Drive
    Barnt Green
    B45 8JY Birmingham
    West Midlands
    Director
    Vectis House 10 Cherry Hill Drive
    Barnt Green
    B45 8JY Birmingham
    West Midlands
    BritishCompany Director690420001
    EARNSHAW, Allan
    Sandy Field 566 Newchurch Road
    Rawtenstall
    BB4 7TN Rossendale
    Lancashire
    Director
    Sandy Field 566 Newchurch Road
    Rawtenstall
    BB4 7TN Rossendale
    Lancashire
    BritishCompany Director10010090001
    HAYHURST, Kevin
    7 Heath Hill Drive
    Stacksteads
    OL13 0SG Bacup
    Lancashire
    Director
    7 Heath Hill Drive
    Stacksteads
    OL13 0SG Bacup
    Lancashire
    BritishCompany Director21410340001
    PARKER, Edward Geoffrey
    The Homestead
    133 Malvern Road
    WR2 4LN Worcester
    Director
    The Homestead
    133 Malvern Road
    WR2 4LN Worcester
    BritishChartered Secretary37378570013
    POOLE, Kenneth Eccles
    15 Waingap Rise
    Syke
    OL12 9TZ Rochdale
    Lancashire
    Director
    15 Waingap Rise
    Syke
    OL12 9TZ Rochdale
    Lancashire
    BritishCompany Director6505570001
    SMITH, Brian Frederick
    Leawood
    Bell Lane Broadheath
    WR15 8QX Tenbury Wells
    Worcestershire
    Director
    Leawood
    Bell Lane Broadheath
    WR15 8QX Tenbury Wells
    Worcestershire
    BritishDirector6030670001
    STANTON, Brian William
    The Moors
    Burlingham
    WR10 3AD Pershore
    Hereford & Worcester
    Director
    The Moors
    Burlingham
    WR10 3AD Pershore
    Hereford & Worcester
    BritishDirector14648180001
    WADSWORTH, Christopher Robert
    Cherry Trees
    Hinstock
    TF9 2ST Market Drayton
    Shropshire
    England
    Director
    Cherry Trees
    Hinstock
    TF9 2ST Market Drayton
    Shropshire
    England
    BritishCompany Director27227340001
    WHITE, Mark Jonathan
    Hawthorn House
    2 Wards Drive, Sarratt
    WD3 6AE Rickmansworth
    Herts
    Director
    Hawthorn House
    2 Wards Drive, Sarratt
    WD3 6AE Rickmansworth
    Herts
    EnglandBritishSolicitor82978250002
    WOODWARD, William Edward
    19 Tideswell Close
    West Hunsbury
    NN4 9XY Northampton
    Northamptonshire
    Director
    19 Tideswell Close
    West Hunsbury
    NN4 9XY Northampton
    Northamptonshire
    United KingdomBritishCompany Secretary11797040001

    ¿Tiene G & A E SLINGSBY LIMITED alguna carga?

    Gravámenes
    ClasificaciónFechasEstadoDetalles
    Fixed and floating charge
    Creado el 24 abr 1992
    Entregado el 06 may 1992
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    Fixed and floating charges over the goodwill,book debts and patents. Undertaking and all property and assets present and future including uncalled capital.
    Personas con derecho
    • Midland Bank PLC
    Transacciones
    • 06 may 1992Registro de un cargo (395)
    • 05 feb 1997Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Floating charge
    Creado el 22 ago 1988
    Entregado el 25 ago 1988
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    Floating charge over all the. Undertaking and all property and assets present and future including uncalled capital.
    Personas con derecho
    • Midland Bank PLC
    Transacciones
    • 25 ago 1988Registro de un cargo (395)
    • 05 feb 1997Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Mortgage
    Creado el 24 jul 1985
    Entregado el 10 ago 1985
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    £17000 and all other monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    Hydraulic equipment as listed on schedule to doc M18.
    Personas con derecho
    • Commercial Credit Services Limited
    Transacciones
    • 10 ago 1985Registro de un cargo (395)
    • 19 nov 1992Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Legal charge
    Creado el 21 nov 1983
    Entregado el 29 nov 1983
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    F/H land and bldgs to the nw of the green, houghton le spring, sunderland. Title no ty 56641 together with all fixtures whatsoever now or at any time hereafter affixed or attached to the property or any part thereof other than trade machinery as defined by section 5 of the bills of sale act 1878.. together with fixed and moveable plant machinery fixtures implements and utensils.
    Personas con derecho
    • Williams & Glyns Bank PLC
    Transacciones
    • 29 nov 1983Registro de una carga
    Legal charge
    Creado el 21 nov 1983
    Entregado el 29 nov 1983
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    F/H plot of land & bldgs erected thereon k/a unit 15 glebe farm road, rugby warwickshire title no wk 249722 together with all fixtures whatsoever now or at any time hereafter affixed or attached to the property or any part thereof other than trade machinery as defined by section 5 of the bills of sale act 1878.. together with fixed and moveable plant machinery fixtures implements and utensils.
    Personas con derecho
    • Williams & Glyns Bank PLC
    Transacciones
    • 29 nov 1983Registro de una carga
    Supplemental debenture
    Creado el 26 mar 1981
    Entregado el 03 abr 1981
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    By way of first fixed charge on all book debts & other debts both present & future.
    Personas con derecho
    • Williams & Glyns Bank
    Transacciones
    • 03 abr 1981Registro de una carga

    Fuente de datos

    • Companies House del Reino Unido
      El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros.
    • Licencia: CC0