TEXTILE & DESIGN (NO 3)

TEXTILE & DESIGN (NO 3)

  • Visión general
  • Resumen
  • Propósito
  • Dirección
  • Nombres anteriores
  • Cuentas
  • Presentaciones
  • Directivos
  • Gravámenes
  • Insolvencia
  • Fuente de datos
  • Visión general

    Nombre de la empresaTEXTILE & DESIGN (NO 3)
    Estado de la empresaDisuelta
    Forma jurídicaSociedad privada sin límite de capital
    Número de empresa 00984968
    JurisdicciónInglaterra/Gales
    Fecha de constitución
    Fecha de cese

    Resumen

    Tiene PSCs súper segurosNo
    Tiene gravámenes
    Tiene historial de insolvencia
    La sede social está en disputaNo

    ¿Cuál es el propósito de TEXTILE & DESIGN (NO 3)?

    • (7499) /

    ¿Dónde se encuentra TEXTILE & DESIGN (NO 3)?

    Dirección de la sede social
    KPMG LLP
    1 The Embankment Neville Street
    LS1 4DW Leeds
    Dirección de la sede social no entregableNo

    ¿Cuáles fueron los nombres anteriores de TEXTILE & DESIGN (NO 3)?

    Nombres anteriores de la empresa
    Nombre de la empresaDesdeHasta
    ROSEBYS23 jun 200023 jun 2000
    ROSEBYS CURTAINS & LINENS LIMITED30 sept 198830 sept 1988
    ROSEBYS LIMITED17 jul 197017 jul 1970

    ¿Cuáles son las últimas cuentas de TEXTILE & DESIGN (NO 3)?

    Últimas cuentas
    Últimas cuentas cerradas hasta30 abr 2005

    ¿Cuáles son las últimas presentaciones para TEXTILE & DESIGN (NO 3)?

    Presentaciones
    FechaDescripciónDocumentoTipo

    Renuncia de bienes vacantes

    0 páginasBONA

    Renuncia de bienes vacantes

    1 páginasBONA

    Renuncia de bienes vacantes

    1 páginasBONA

    Renuncia de bienes vacantes

    1 páginasBONA

    Gaceta final disuelta tras la liquidación

    1 páginasGAZ2

    Declaración de recibos y pagos del liquidador hasta 16 mar 2010

    5 páginas4.68

    Devolución de la reunión final en una liquidación voluntaria de acreedores

    3 páginas4.72

    Aviso de cambio de la administración a la liquidación voluntaria de acreedores

    21 páginas2.34B

    Declaración de la propuesta del administrador

    103 páginas2.17B

    Declaración de la propuesta del administrador

    103 páginas2.17B

    Nombramiento de un administrador

    1 páginas2.12B

    legacy

    1 páginas287

    Certificado de cambio de nombre

    Company name changed rosebys\certificate issued on 30/09/08
    2 páginasCERTNM

    legacy

    2 páginas403a

    legacy

    1 páginas288b

    legacy

    2 páginas288a

    legacy

    8 páginas395

    legacy

    1 páginas288a

    legacy

    4 páginas363a

    legacy

    1 páginas288b

    legacy

    9 páginas395

    legacy

    1 páginas288b

    legacy

    1 páginas288b

    legacy

    8 páginas363s

    legacy

    1 páginas288b

    ¿Quiénes son los directivos de TEXTILE & DESIGN (NO 3)?

    Directivos
    NombreNombrado elRenunció elRolDirecciónIdentificación de la empresaPaís de residenciaNacionalidadFecha de nacimientoOcupaciónNúmero
    DARAL, Jagdish Singh
    H.No-312, Sector -31
    Gurgaon
    Haryana
    122001
    India
    Secretario
    H.No-312, Sector -31
    Gurgaon
    Haryana
    122001
    India
    IndianAccountant132731980001
    BARRETT, David James
    Denton Road
    Crouch End
    N8 9NS London
    10
    Director
    Denton Road
    Crouch End
    N8 9NS London
    10
    BritishCeo131080090001
    DARAL, Jagdish Singh
    H.No-312, Sector -31
    Gurgaon
    Haryana
    122001
    India
    Director
    H.No-312, Sector -31
    Gurgaon
    Haryana
    122001
    India
    IndianAccountant132731980001
    JALAN, Ravi Shanker
    330 Mandakini Enclave,
    Alaknanda
    FOREIGN New Delhi
    110019
    India
    Director
    330 Mandakini Enclave,
    Alaknanda
    FOREIGN New Delhi
    110019
    India
    IndianCompany Director114776640001
    DYSON, Mark Edward
    The Grange
    Bewholme
    YO25 8ED Driffield
    East Yorkshire
    Secretario
    The Grange
    Bewholme
    YO25 8ED Driffield
    East Yorkshire
    BritishChartered Accountant32670580003
    LOCKWOOD, Marie Jane
    71 Clough Grove
    Oughtibridge
    S35 0JU Sheffield
    Secretario
    71 Clough Grove
    Oughtibridge
    S35 0JU Sheffield
    British123618210001
    MORRISON, Stephen
    26 Gateacre Rise
    L25 5LA Liverpool
    Secretario
    26 Gateacre Rise
    L25 5LA Liverpool
    British97831490001
    TOWNDROW, Ralph Watson
    Bramsley St Barnabas Drive
    Swanland
    HU14 3NR North Ferriby
    North Humberside
    Secretario
    Bramsley St Barnabas Drive
    Swanland
    HU14 3NR North Ferriby
    North Humberside
    British28020050001
    AKESTER, Peter
    Beech House 49 Finch Park
    HU17 7DW Molescroft
    North Humberside
    Director
    Beech House 49 Finch Park
    HU17 7DW Molescroft
    North Humberside
    BritishCompany Director74234960001
    BEAUMONT, Andrew
    365 Hollinsend Road
    S12 2NN Sheffield
    South Yorkshire
    Director
    365 Hollinsend Road
    S12 2NN Sheffield
    South Yorkshire
    BritishCompany Director28367860001
    BRISTOW, Keith
    Fairview 18 Ridings Gardens
    Lofthouse
    WF3 3SN Wakefield
    West Yorkshire
    Director
    Fairview 18 Ridings Gardens
    Lofthouse
    WF3 3SN Wakefield
    West Yorkshire
    BritishDirector Of Management Information Services28367880001
    CRIBB, James
    Pendeen
    28 Caldy Road
    CH48 2HG West Kirby
    Merseyside
    Director
    Pendeen
    28 Caldy Road
    CH48 2HG West Kirby
    Merseyside
    United KingdomBritishCompany Director15119750004
    DYSON, Mark Edward
    The Grange
    Bewholme
    YO25 8ED Driffield
    East Yorkshire
    Director
    The Grange
    Bewholme
    YO25 8ED Driffield
    East Yorkshire
    BritishDirector32670580003
    DYSON, Mark Edward
    The Grange
    Bewholme
    YO25 8ED Driffield
    East Yorkshire
    Director
    The Grange
    Bewholme
    YO25 8ED Driffield
    East Yorkshire
    BritishChartered Accountant32670580003
    GALLEY, Eric
    12 Dyson Close
    LE17 4XD Lutterworth
    Leicestershire
    Director
    12 Dyson Close
    LE17 4XD Lutterworth
    Leicestershire
    BritishPersonnel Executive45893990001
    GREGORY, Nigel Dorian
    Hollih Bar Road
    Curbar Calver
    S30 1YA Sheffield
    Director
    Hollih Bar Road
    Curbar Calver
    S30 1YA Sheffield
    BritishProperty Director45894330001
    KENNEDY, Stephen Paul
    42 Cherry Lane
    WA13 0NN Lymm
    Cheshire
    Director
    42 Cherry Lane
    WA13 0NN Lymm
    Cheshire
    BritishCompany Director74234730001
    LAWTON, Merton
    48 Quarry Lane
    S11 9EB Sheffield
    South Yorkshire
    Director
    48 Quarry Lane
    S11 9EB Sheffield
    South Yorkshire
    BritishCurtain Buyer28367870001
    MANNIX, Antony Gerard
    Tall Timbers 37 Carrs Meadow
    Escrick
    YO19 6JZ York
    North Yorkshire
    Director
    Tall Timbers 37 Carrs Meadow
    Escrick
    YO19 6JZ York
    North Yorkshire
    United KingdomBritishDirector45894250002
    MANNIX, Antony Gerard
    Tall Timbers 37 Carrs Meadow
    Escrick
    YO19 6JZ York
    North Yorkshire
    Director
    Tall Timbers 37 Carrs Meadow
    Escrick
    YO19 6JZ York
    North Yorkshire
    United KingdomBritishQistribution Director45894250002
    O`GORMAN, Clifford Michael
    132 Park Avenue
    EN1 2BH Enfield
    Middlesex
    Director
    132 Park Avenue
    EN1 2BH Enfield
    Middlesex
    BritishCompany Director40160730001
    PUROHIT, Sanjay
    1405 Woodborough Lane
    Kellar
    Texas
    76248
    Usa
    Director
    1405 Woodborough Lane
    Kellar
    Texas
    76248
    Usa
    IndianCompany Director114482730001
    RICHARDS, Anthony Brinley
    5 Freesia Close
    LE11 2FD Loughborough
    Leicestershire
    Director
    5 Freesia Close
    LE11 2FD Loughborough
    Leicestershire
    EnglandBritishDirector64993620001
    RICHARDS, Anthony Brinley
    5 Freesia Close
    LE11 2FD Loughborough
    Leicestershire
    Director
    5 Freesia Close
    LE11 2FD Loughborough
    Leicestershire
    EnglandBritishCompany Director64993620001
    ROSENBLATT, Michael David
    Badgers Rake Woolton Park
    L25 6DX Liverpool
    Merseyside
    Director
    Badgers Rake Woolton Park
    L25 6DX Liverpool
    Merseyside
    BritishDirector1976970001
    SAMPATH, Parthasarthy
    A/118-B, Sector-35,
    Noida-201301 (Up)
    India
    Director
    A/118-B, Sector-35,
    Noida-201301 (Up)
    India
    IndianCompany Director114603250001
    SIMONS, Carolyn
    3 Lytton Park
    KT11 2HB Cobham
    Surrey
    Director
    3 Lytton Park
    KT11 2HB Cobham
    Surrey
    United KingdomBritishCompany Director63703440003
    TENNANT, Susan
    14 Gayton Lane
    Gayton
    CH60 3SJ Wirral
    Merseyside
    Director
    14 Gayton Lane
    Gayton
    CH60 3SJ Wirral
    Merseyside
    BritishCompany Director114776700001
    TOWNDROW, Ralph Watson
    Bramsley St Barnabas Drive
    Swanland
    HU14 3NR North Ferriby
    North Humberside
    Director
    Bramsley St Barnabas Drive
    Swanland
    HU14 3NR North Ferriby
    North Humberside
    BritishChartered Accountant28020050001
    WILLIAMS, David Anthony
    East West Main Street
    Chadwell
    LE14 4QL Melton Mowbray
    Leicestershire
    Director
    East West Main Street
    Chadwell
    LE14 4QL Melton Mowbray
    Leicestershire
    BritishBuyer71731980001
    WILLIAMS, Malcolm
    Orchard House
    Kirby Lane
    LE13 0BJ Melton Mowbray
    Leicestershire
    Director
    Orchard House
    Kirby Lane
    LE13 0BJ Melton Mowbray
    Leicestershire
    BritishCompany Director64993650002
    WILLIAMS, William Wilfred
    Moores Farm House
    Walton By Kimote
    LE17 5RG Leicester
    Leicestershire
    Director
    Moores Farm House
    Walton By Kimote
    LE17 5RG Leicester
    Leicestershire
    BritishCompany Director89151330001

    ¿Tiene TEXTILE & DESIGN (NO 3) alguna carga?

    Gravámenes
    ClasificaciónFechasEstadoDetalles
    Composite guarantee and debenture
    Creado el 15 jul 2008
    Entregado el 01 ago 2008
    Pendiente
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from any chargor to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descripción
    Assigns the key-man policies the relevant agreements the relevant policies fixed charge all plant machinery the subsidiary shares the investments floating charge all assets and undertaking see image for full details.
    Personas con derecho
    • Ghcl Limited
    Transacciones
    • 01 ago 2008Registro de un cargo (395)
    Deed of debenture
    Creado el 23 abr 2008
    Entregado el 30 abr 2008
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from each obligor to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descripción
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Personas con derecho
    • Burdale Financial Limited
    Transacciones
    • 30 abr 2008Registro de un cargo (395)
    • 24 sept 2008Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Debenture
    Creado el 28 may 2004
    Entregado el 05 jun 2004
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from each obligor to any of the finance parties (or any of them) under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descripción
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • Barclays Bank PLC as Trustee and Security Agent for the Finance Parties (The Security Trustee)
    Transacciones
    • 05 jun 2004Registro de un cargo (395)
    • 08 sept 2006Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Debenture
    Creado el 11 jun 1980
    Entregado el 19 jun 1980
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever.
    Breve descripción
    Floating charge. Undertaking and all property and assets present and future including uncalled capital.
    Personas con derecho
    • The First National Bank of Chicago
    Transacciones
    • 19 jun 1980Registro de una carga
    Floating charge
    Creado el 11 jun 1980
    Entregado el 18 jun 1980
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    £3,000,000 loan made by the citibank N.A. to cattles (holding) limited in an agreement dated 14TH jan. 1980.
    Breve descripción
    Floating charge over the. Undertaking and all property and assets present and future including uncalled capital.
    Personas con derecho
    • Citibank N.A.
    Transacciones
    • 18 jun 1980Registro de una carga
    Floting charge
    Creado el 31 mar 1980
    Entregado el 15 abr 1980
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    Floating charge over undertaking and all property and assets present and future including goodwill uncalled capital with all fixtures and fittings (including trade fixtures and fittings) and fixed plant and machinery. (Please see doc M33).
    Personas con derecho
    • Williams & Glyns Bank Limited
    Transacciones
    • 15 abr 1980Registro de una carga

    ¿Tiene TEXTILE & DESIGN (NO 3) algún caso de insolvencia?

    Número de expedienteFechasTipoProfesionalesOtro
    1
    FechaTipo
    25 sept 2008Inicio de la administración
    09 jun 2009Fin de la administración
    En administración
    NombreRolDirecciónNombrado elCesado el
    Richard Dixon Fleming
    Kpmg Llp
    1 The Embankment
    Neville Street
    Leeds Ls14dw
    Profesional
    Kpmg Llp
    1 The Embankment
    Neville Street
    Leeds Ls14dw
    Howard Smith
    Kpmg Llp
    1 The Embankment
    LS1 4DW Neville Street
    Leeds
    Profesional
    Kpmg Llp
    1 The Embankment
    LS1 4DW Neville Street
    Leeds
    Mark Granville Firmin
    Kpmg Llp
    1 The Embankment
    LS1 4DW Neville Street
    Leeds
    Profesional
    Kpmg Llp
    1 The Embankment
    LS1 4DW Neville Street
    Leeds
    2
    FechaTipo
    09 jun 2009Inicio de la liquidación
    22 jun 2010Fecha de disolución
    Liquidación voluntaria de acreedores
    NombreRolDirecciónNombrado elCesado el
    Howard Smith
    1 The Embankment
    Neville Street
    LS1 4DW Leeds
    Profesional
    1 The Embankment
    Neville Street
    LS1 4DW Leeds
    Richard Dixon Fleming
    1 The Embankment
    Neville Street
    LS1 4DW Leeds
    West Yorkshire
    Profesional
    1 The Embankment
    Neville Street
    LS1 4DW Leeds
    West Yorkshire
    Mark Granville Firmin
    Kpmg Llp
    1 The Embankment
    LS1 4DW Neville Street
    Leeds
    Profesional
    Kpmg Llp
    1 The Embankment
    LS1 4DW Neville Street
    Leeds

    Fuente de datos

    • Companies House del Reino Unido
      El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros.
    • Licencia: CC0