FIRST OIL SNS LIMITED

  • Visión general
  • Resumen
  • Propósito
  • Dirección
  • Nombres anteriores
  • Cuentas
  • Declaración anual
  • Presentaciones
  • Directivos
  • Gravámenes
  • Fuente de datos
  • Visión general

    Nombre de la empresaFIRST OIL SNS LIMITED
    Estado de la empresaDisuelta
    Forma jurídicaSociedad de responsabilidad limitada
    Número de empresa 00986309
    JurisdicciónInglaterra/Gales
    Fecha de constitución
    Fecha de cese

    Resumen

    Tiene PSCs súper segurosNo
    Tiene gravámenes
    Tiene historial de insolvenciaNo
    La sede social está en disputaNo

    ¿Cuál es el propósito de FIRST OIL SNS LIMITED?

    • Compañía no comercial (74990) / Actividades profesionales, científicas y técnicas

    ¿Dónde se encuentra FIRST OIL SNS LIMITED?

    Dirección de la sede social
    21 Regatta House
    32 Twickenham Road
    TW11 8AZ Teddington
    Middlesex
    Dirección de la sede social no entregableNo

    ¿Cuáles fueron los nombres anteriores de FIRST OIL SNS LIMITED?

    Nombres anteriores de la empresa
    Nombre de la empresaDesdeHasta
    CALEDONIA SNS LIMITED07 nov 200307 nov 2003
    CONSORT NORTH SEA LIMITED06 feb 200206 feb 2002
    ENTERPRISE OIL NORTH SEA LIMITED10 sept 200110 sept 2001
    PETROBRAS NORTH SEA LIMITED30 jun 199830 jun 1998
    SANTOS EUROPE LIMITED16 abr 199216 abr 1992
    PEKO EXPLORATION (UK) LIMITED17 jul 199017 jul 1990
    IU OIL & GAS LIMITED06 ago 197006 ago 1970

    ¿Cuáles son las últimas cuentas de FIRST OIL SNS LIMITED?

    Últimas cuentas
    Últimas cuentas cerradas hasta30 abr 2014

    ¿Cuál es el estado de la última declaración anual para FIRST OIL SNS LIMITED?

    Declaración anual
    Última declaración anual

    ¿Cuáles son las últimas presentaciones para FIRST OIL SNS LIMITED?

    Presentaciones
    FechaDescripciónDocumentoTipo

    Boletín oficial final disuelto por cancelación obligatoria

    1 páginasGAZ2

    Primer aviso en el boletín oficial para la cancelación obligatoria

    1 páginasGAZ1

    Déclaration annuelle établie au 14 jun 2015 avec liste complète des actionnaires

    3 páginasAR01
    Presentaciones asociadas
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    capital03 jul 2015

    Estado de capital el 03 jul 2015

    • Capital: GBP 41,599,622
    SH01
    X4AVZ5Y9

    Cese del nombramiento de Steven Richard George como director el 05 jun 2015

    1 páginasTM01
    X4959M37

    legacy

    1 páginasAGREEMENT1
    A408JMA5

    legacy

    PARENT_ACC
    A408JM8H

    legacy

    3 páginasGUARANTEE1
    A408JMA9

    Déclaration annuelle établie au 14 jun 2014 avec liste complète des actionnaires

    4 páginasAR01
    Presentaciones asociadas
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    capital04 jul 2014

    Estado de capital el 04 jul 2014

    • Capital: GBP 41,599,622
    SH01
    X3BE3HFT

    Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 30 abr 2013

    3 páginasAA
    S30QM489

    Déclaration annuelle établie au 14 jun 2013 avec liste complète des actionnaires

    4 páginasAR01
    X2CX049M

    Nombramiento de Mr Steven Richard George como director

    2 páginasAP01
    X23XCH9V

    legacy

    3 páginasMG02
    S23JAIIY

    Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 30 abr 2012

    3 páginasAA
    A216XYAX

    Déclaration annuelle établie au 14 jun 2012 avec liste complète des actionnaires

    3 páginasAR01
    X1DVZQYG

    Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 30 abr 2011

    3 páginasAA
    S11GQ2AJ

    Exercice comptable précédent prolongé du 31 dic 2010 au 30 abr 2011

    1 páginasAA01
    XU123XSM

    Déclaration annuelle établie au 14 jun 2011 avec liste complète des actionnaires

    3 páginasAR01
    X35IIVJJ

    Cese del nombramiento de Stephen Grant como secretario

    1 páginasTM02
    XSZUCON5

    Déclaration annuelle établie au 14 jun 2010 avec liste complète des actionnaires

    4 páginasAR01
    XTPABLN8

    Cese del nombramiento de Graham Forbes como director

    1 páginasTM01
    XM3CEJE9

    Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 31 dic 2009

    3 páginasAA
    SA07DH14

    Cambio de datos del director Ian Alexander Suttie el 19 oct 2009

    2 páginasCH01
    XO656E8O

    Cambio de datos del director Graham Andrew Forbes el 19 oct 2009

    2 páginasCH01
    XO64FE8W

    Cambio de datos del secretario Mr Stephen Grant el 19 oct 2009

    1 páginasCH03
    XO66OE87

    Resoluciones

    Resolutions
    2 páginasRESOLUTIONS
    Acuerdos
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    capital

    Resoluciones

    Authorised to enter into a second amendment and restatement agreement, a subordination deed and a guarantee and debenture 30/07/2009
    RES13

    ¿Quiénes son los directivos de FIRST OIL SNS LIMITED?

    Directivos
    NombreNombrado elRenunció elRolDirecciónIdentificación de la empresaPaís de residenciaNacionalidadFecha de nacimientoOcupaciónNúmero
    SUTTIE, Ian Alexander, Mr.
    21 Regatta House
    32 Twickenham Road
    TW11 8AZ Teddington
    Middlesex
    Director
    21 Regatta House
    32 Twickenham Road
    TW11 8AZ Teddington
    Middlesex
    ScotlandBritishDirector52794240001
    BATE, Christopher Malcolm
    Bryn Y Mor
    LL57 2HG Bangor
    Gwynedd
    Secretario
    Bryn Y Mor
    LL57 2HG Bangor
    Gwynedd
    British77942170001
    GEORGE, Steven Richard
    96 Margaret Place
    AB10 7GB Aberdeen
    Secretario
    96 Margaret Place
    AB10 7GB Aberdeen
    OtherChartered Accountant126930530001
    GRANT, Stephen
    21 Regatta House
    32 Twickenham Road
    TW11 8AZ Teddington
    Middlesex
    Secretario
    21 Regatta House
    32 Twickenham Road
    TW11 8AZ Teddington
    Middlesex
    BritishChartered Accountant139292040001
    LONGMAN, Christopher David, Dr
    Staplow House
    Staplow
    HR8 1NP Ledbury
    Herefordshire
    Secretario
    Staplow House
    Staplow
    HR8 1NP Ledbury
    Herefordshire
    British58438680001
    MCKENZIE, William Ernest
    8 Harbury Dell
    LU3 3XH Luton
    Bedfordshire
    Secretario
    8 Harbury Dell
    LU3 3XH Luton
    Bedfordshire
    British60573240002
    MEARNS, Steven Macdonald
    26 Concraig Park
    Kingswells
    AB15 8DH Aberdeen
    Aberdeenshire
    Secretario
    26 Concraig Park
    Kingswells
    AB15 8DH Aberdeen
    Aberdeenshire
    British115242820001
    PENNEY, Nigel Francis
    13 Downs Court
    Commonside Close
    SM2 5SX Sutton
    Surrey
    Secretario
    13 Downs Court
    Commonside Close
    SM2 5SX Sutton
    Surrey
    British97198480001
    SMITH, Vernon Victor
    Long Acre Paice Lane
    Medstead
    GU34 5PT Alton
    Hampshire
    Secretario
    Long Acre Paice Lane
    Medstead
    GU34 5PT Alton
    Hampshire
    British10991580001
    STOUGH, Kenneth Fred
    Rossend Guildown Road
    GU2 5ET Guildford
    Surrey
    Secretario
    Rossend Guildown Road
    GU2 5ET Guildford
    Surrey
    British39588630001
    TEMPLETON, Michael Charles
    Lothorien Barley Mow Hill
    Headley Down
    GU35 8AB Bordon
    Hampshire
    Secretario
    Lothorien Barley Mow Hill
    Headley Down
    GU35 8AB Bordon
    Hampshire
    British63244900001
    WHITE, Mark Jonathan
    38 Grange Close
    Church Road Nascot Wood
    WD17 4HQ Watford
    Hertfordshire
    Secretario
    38 Grange Close
    Church Road Nascot Wood
    WD17 4HQ Watford
    Hertfordshire
    BritishSolicitor82978250001
    DWS SECRETARIES LIMITED
    Five Chancery Lane
    Cliffords Inn
    EC4A 1BU London
    Secretario designado corporativo
    Five Chancery Lane
    Cliffords Inn
    EC4A 1BU London
    900023840001
    LEDINGHAM CHALMERS LLP
    Johnstone House
    52-54 Rose Street
    AB10 1UD Aberdeen
    Secretario corporativo
    Johnstone House
    52-54 Rose Street
    AB10 1UD Aberdeen
    73896680003
    PAULL & WILLIAMSONS
    Union Plaza (6th Floor)
    1 Union Wynd
    AB10 1DQ Aberdeen
    Secretario corporativo
    Union Plaza (6th Floor)
    1 Union Wynd
    AB10 1DQ Aberdeen
    24280001
    ADLER, Norman Ross
    11 The Avenue
    Medindie
    South Australia
    5081
    Australia
    Director
    11 The Avenue
    Medindie
    South Australia
    5081
    Australia
    AustralianManaging Director11260180001
    ARMOUR, Andrew Richard, Doctor
    Little Triton
    London Road
    OX11 9PD Blewbury
    Oxfordshire
    Director
    Little Triton
    London Road
    OX11 9PD Blewbury
    Oxfordshire
    BritishGeophysicist81558280001
    ARMSTRONG, John Dennis, Doctor
    127 Hickory Ridge
    Houston
    77024
    Usa
    Director
    127 Hickory Ridge
    Houston
    77024
    Usa
    AustralianExecutive General Manager30215120002
    BARBOSA, Gustavo Tardin
    30a Hornton Street
    W8 4NR London
    Director
    30a Hornton Street
    W8 4NR London
    BrazilianEngineer55726770001
    BARBOSA, Jose Coutinho
    Arto 102 Lazza
    Av Linea De Paula Machado 896
    FOREIGN Rio De Janeriro Rj Brazil
    Director
    Arto 102 Lazza
    Av Linea De Paula Machado 896
    FOREIGN Rio De Janeriro Rj Brazil
    BrazilianChairman59424820002
    BASTOS, Bravlio Luis Cortes Xavier
    Flat 2 41 Emperors Gate
    SW7 4HJ London
    Director
    Flat 2 41 Emperors Gate
    SW7 4HJ London
    BrazilianCompany Director56186420001
    BELL, Andrew Stewart
    178 Clonmore Street
    SW18 5HB London
    Director
    178 Clonmore Street
    SW18 5HB London
    United KingdomBritishAccountant95066820001
    BERTANI, Renato Tadeu
    Flat 14 Stanford Court
    Cornwall Gardens
    SW7 4AB London
    Director
    Flat 14 Stanford Court
    Cornwall Gardens
    SW7 4AB London
    BrazilianOil Company Executive59369040001
    BOWEN, John Myles, Dr
    Rudge Farm
    Lustleigh
    TQ13 9SL Newton Abbot
    Devon
    Director
    Rudge Farm
    Lustleigh
    TQ13 9SL Newton Abbot
    Devon
    BritishPetroleum Consultant34840710002
    CAMARGO, Jorge Margues De Toledo
    Rua Almirante Sadock De Sa
    370/101 Ipanema
    FOREIGN Rio De Janeiro
    22 471 030
    Brazil
    Director
    Rua Almirante Sadock De Sa
    370/101 Ipanema
    FOREIGN Rio De Janeiro
    22 471 030
    Brazil
    BrazilianOil Company Executive65772390001
    CRAIG, Ian
    The Georgian House
    4 Farmleigh Grove Burwood Park
    KT12 5BU Walton On Thames
    Surrey
    Director
    The Georgian House
    4 Farmleigh Grove Burwood Park
    KT12 5BU Walton On Thames
    Surrey
    BritishTechnical Director78821300001
    DA SILVA, Marcello Castilho
    Flat 8 10 Hornton Street
    W8 4NW London
    Director
    Flat 8 10 Hornton Street
    W8 4NW London
    BrazilianDirector76080340001
    DOWN, Kenneth John, Mr.
    246 Dewar Terrace
    Corinda
    Brisane
    4075
    Australia
    Director
    246 Dewar Terrace
    Corinda
    Brisane
    4075
    Australia
    AustraliaAustralianEconomist217984760001
    EDGLEY, Steven Neville
    83 Loom Lane
    WD7 8NY Radlett
    Hertfordshire
    Director
    83 Loom Lane
    WD7 8NY Radlett
    Hertfordshire
    United KingdomBritishFinance Director85718530001
    FERGUSON, Donald
    6 Cresswell Gardens
    Kensington
    SW5 0BJ London
    Director
    6 Cresswell Gardens
    Kensington
    SW5 0BJ London
    BritishDirector88767730001
    FITZGERALD, John Bryan
    146 Strangways Terrace
    FOREIGN North Adelaide
    S A 5006
    Australia
    Director
    146 Strangways Terrace
    FOREIGN North Adelaide
    S A 5006
    Australia
    AustralianCompany Director26970340001
    FORBES, Graham Andrew
    21 Regatta House
    32 Twickenham Road
    TW11 8AZ Teddington
    Middlesex
    Director
    21 Regatta House
    32 Twickenham Road
    TW11 8AZ Teddington
    Middlesex
    ScotlandBritishChartered Accountant83876980001
    GEORGE, Steven Richard
    Queens Terrace
    AB10 1XL Aberdeen
    1
    Scotland
    Director
    Queens Terrace
    AB10 1XL Aberdeen
    1
    Scotland
    ScotlandBritishChartered Accountant161491510001
    HAWKINS, Warren
    4225 Milton
    Houston
    Harris Texas
    77005
    Usa
    Director
    4225 Milton
    Houston
    Harris Texas
    77005
    Usa
    AmericanSenior Vice President94520330001
    HICKAM, Edward Eugene
    6230 Coral Ridge
    Houston
    Texas
    Usa
    Director
    6230 Coral Ridge
    Houston
    Texas
    Usa
    AmericanCompany Director43831180001

    ¿Tiene FIRST OIL SNS LIMITED alguna carga?

    Gravámenes
    ClasificaciónFechasEstadoDetalles
    Debenture
    Creado el 19 oct 2004
    Entregado el 02 nov 2004
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the obligors to the finance parties under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descripción
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland (In Its Capacity as Security Trustee Foritself and for and on Behalf of the Finance Parties)
    Transacciones
    • 02 nov 2004Registro de un cargo (395)
    • 05 mar 2013Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (MG02)
    Security agreement
    Creado el 23 oct 2003
    Entregado el 12 nov 2003
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company formerly known as consort north sea limited to any secured creditor under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descripción
    By way of an equitable mortgage all shares in any member of the group, by way of a floating charge its interest in all shares stocks debentures bonds or other securities owned by it or held by any nominee on its behalf.. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • The Royal Bank of Scotland PLC, as Trustee Fore Itself and the Secured Creditors
    Transacciones
    • 12 nov 2003Registro de un cargo (395)
    • 21 oct 2004Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Security agreement
    Creado el 17 feb 2003
    Entregado el 20 feb 2003
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All present and future obligations and liabilities due or to become due from the company to the chargee (the "facility agent") as facility agent and trustee for the finance parties on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descripción
    All of the assigned assets. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transacciones
    • 20 feb 2003Registro de un cargo (395)
    • 06 nov 2003Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Debenture
    Creado el 27 oct 1998
    Entregado el 12 nov 1998
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company and petrobras U.K. limited to any finance party under each financing document (both as defined) and under this debenture
    Breve descripción
    All property and rights,title and interest whatsoever. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland,as Agent and Security Trustee for the Financeparties
    Transacciones
    • 12 nov 1998Registro de un cargo (395)
    • 29 nov 2001Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)

    Fuente de datos

    • Companies House del Reino Unido
      El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros.
    • Licencia: CC0