STAINLESS STEEL FASTENERS LIMITED

STAINLESS STEEL FASTENERS LIMITED

  • Visión general
  • Resumen
  • Propósito
  • Dirección
  • Nombres anteriores
  • Cuentas
  • Presentaciones
  • Directivos
  • Personas con control significativo
  • Gravámenes
  • Insolvencia
  • Fuente de datos
  • Visión general

    Nombre de la empresaSTAINLESS STEEL FASTENERS LIMITED
    Estado de la empresaDisuelta
    Forma jurídicaSociedad de responsabilidad limitada
    Número de empresa 00996214
    JurisdicciónInglaterra/Gales
    Fecha de constitución
    Fecha de cese

    Resumen

    Tiene PSCs súper segurosNo
    Tiene gravámenes
    Tiene historial de insolvencia
    La sede social está en disputaNo

    ¿Cuál es el propósito de STAINLESS STEEL FASTENERS LIMITED?

    • fabricación de productos de fijación y máquinas de tornillos (25940) / Industrias manufactureras

    ¿Dónde se encuentra STAINLESS STEEL FASTENERS LIMITED?

    Dirección de la sede social
    C/O CURRIE YOUNG LIMITED
    10 King Street
    ST5 1EL Newcastle Under Lyme
    Dirección de la sede social no entregableNo

    ¿Cuáles fueron los nombres anteriores de STAINLESS STEEL FASTENERS LIMITED?

    Nombres anteriores de la empresa
    Nombre de la empresaDesdeHasta
    STAINLESS STEEL FASTENERS (CHESTERFIELD) LIMITED07 dic 197007 dic 1970

    ¿Cuáles son las últimas cuentas de STAINLESS STEEL FASTENERS LIMITED?

    Últimas cuentas
    Últimas cuentas cerradas hasta31 dic 2016

    ¿Cuáles son las últimas presentaciones para STAINLESS STEEL FASTENERS LIMITED?

    Presentaciones
    FechaDescripciónDocumentoTipo

    Gaceta final disuelta tras la liquidación

    1 páginasGAZ2

    Devolución de la reunión final en una liquidación voluntaria de acreedores

    28 páginasLIQ14

    Declaración de recibos y pagos del liquidador hasta 21 dic 2022

    29 páginasLIQ03

    Declaración de recibos y pagos del liquidador hasta 21 dic 2021

    28 páginasLIQ03

    Domicilio social registrado cambiado de C/O Currie Young Limited Alexander House Campbell Road Waters Edge Business Park Stoke on Trent Staffordshire ST4 4DB a 10 King Street Newcastle Under Lyme ST5 1EL el 08 dic 2021

    2 páginasAD01

    Declaración de recibos y pagos del liquidador hasta 21 dic 2020

    26 páginasLIQ03

    Declaración de recibos y pagos del liquidador hasta 21 dic 2019

    25 páginasLIQ03

    Declaración de recibos y pagos del liquidador hasta 21 dic 2018

    22 páginasLIQ03

    Domicilio social registrado cambiado de Unit C Barton Business Park Barton Under Needwood Burton-on-Trent DE13 8BX England a C/O Currie Young Limited Alexander House Campbell Road Waters Edge Business Park Stoke on Trent Staffordshire ST4 4DB el 15 ene 2018

    2 páginasAD01

    Notificación al Registro Mercantil de la notificación de renuncia

    5 páginasNDISC

    Notificación al Registro Mercantil de la notificación de renuncia

    5 páginasNDISC

    Notificación al Registro Mercantil de la notificación de renuncia

    5 páginasNDISC

    Notificación al Registro Mercantil de la notificación de renuncia

    5 páginasNDISC

    Declaración de asuntos

    12 páginasLIQ02

    Nombramiento de un liquidador voluntario

    1 páginas600

    Resoluciones

    Resolutions
    1 páginasRESOLUTIONS
    Acuerdos
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    liquidation

    Acuerdo extraordinario para la liquidación el 22 dic 2017

    LRESEX

    Resoluciones

    Resolutions
    38 páginasRESOLUTIONS
    Acuerdos
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    incorporation

    Resolución de adopción de los Artículos de Asociación

    RES01

    Modification des détails de International Pipeline Products Limited en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 01 sept 2017

    2 páginasPSC05

    Domicilio social registrado cambiado de Gatherley Road Brompton on Swale Richmond DL10 7JH England a Unit C Barton Business Park Barton Under Needwood Burton-on-Trent DE13 8BX el 07 sept 2017

    1 páginasAD01

    Nombramiento de Mr Timothy John Barnett como director el 01 sept 2017

    2 páginasAP01

    Modification des détails de Truflo International Limited en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 01 sept 2017

    2 páginasPSC05

    Domicilio social registrado cambiado de Broombank Road Sheepbridge Chesterfield Derbyshire S41 9QJ a Gatherley Road Brompton on Swale Richmond DL10 7JH el 05 sept 2017

    1 páginasAD01

    Cese del nombramiento de Paul Adrian Ward como director el 01 sept 2017

    1 páginasTM01

    Cese del nombramiento de Stephen Mclintock como director el 01 sept 2017

    1 páginasTM01

    Cese del nombramiento de Kevin Allsopp como director el 01 sept 2017

    1 páginasTM01

    ¿Quiénes son los directivos de STAINLESS STEEL FASTENERS LIMITED?

    Directivos
    NombreNombrado elRenunció elRolDirecciónIdentificación de la empresaPaís de residenciaNacionalidadFecha de nacimientoOcupaciónNúmero
    BARNETT, Timothy John
    King Street
    ST5 1EL Newcastle Under Lyme
    10
    Director
    King Street
    ST5 1EL Newcastle Under Lyme
    10
    EnglandBritish141039730001
    RODGER, Alan Mcintosh
    King Street
    ST5 1EL Newcastle Under Lyme
    10
    Director
    King Street
    ST5 1EL Newcastle Under Lyme
    10
    United KingdomBritish138422370001
    ALLSOPP, Kevin
    Broombank Road Sheepbridge
    Chesterfield
    S41 9QJ Derbyshire
    Secretario
    Broombank Road Sheepbridge
    Chesterfield
    S41 9QJ Derbyshire
    204297380001
    CONNER, Eileen
    1 Kipling Drive
    SW19 1TJ Wimbledon
    Secretario
    1 Kipling Drive
    SW19 1TJ Wimbledon
    British89546940001
    LAWTON, Kirsten
    31 Orchard Avenue
    KT7 0BB Thames Ditton
    Surrey
    Secretario
    31 Orchard Avenue
    KT7 0BB Thames Ditton
    Surrey
    British50045660001
    NEATE, Jonathan Charles
    Broombank Road Sheepbridge
    Chesterfield
    S41 9QJ Derbyshire
    Secretario
    Broombank Road Sheepbridge
    Chesterfield
    S41 9QJ Derbyshire
    187906380001
    RIDGEWAY, Kevin Stuart
    5 Newland Gardens
    Newbold
    S41 7BD Chesterfield
    Derbyshire
    Secretario
    5 Newland Gardens
    Newbold
    S41 7BD Chesterfield
    Derbyshire
    British73705320001
    SANDERSON, Gary
    Cliffhurst 46 Rectory Road
    Duckmanton
    S44 5JP Chesterfield
    Derbyshire
    Secretario
    Cliffhurst 46 Rectory Road
    Duckmanton
    S44 5JP Chesterfield
    Derbyshire
    British19581810003
    WILKINSON, Stephen Philip
    Broombank Road Sheepbridge
    Chesterfield
    S41 9QJ Derbyshire
    Secretario
    Broombank Road Sheepbridge
    Chesterfield
    S41 9QJ Derbyshire
    187436420001
    ADCOCK, Nicholas Simon
    Broombank Road Sheepbridge
    Chesterfield
    S41 9QJ Derbyshire
    Director
    Broombank Road Sheepbridge
    Chesterfield
    S41 9QJ Derbyshire
    EnglandBritish204292940001
    ALLSOPP, Kevin
    Broombank Road Sheepbridge
    Chesterfield
    S41 9QJ Derbyshire
    Director
    Broombank Road Sheepbridge
    Chesterfield
    S41 9QJ Derbyshire
    EnglandBritish204292980001
    BARBER, David Roy, Mr.
    12 Robin Hood Chase
    Stannington
    S6 6FH Sheffield
    South Yorkshire
    Director
    12 Robin Hood Chase
    Stannington
    S6 6FH Sheffield
    South Yorkshire
    EnglandBritish94023010002
    BOOTE, David Frank
    8 Alms Hill Drive
    S11 9QY Sheffield
    South Yorkshire
    Director
    8 Alms Hill Drive
    S11 9QY Sheffield
    South Yorkshire
    United KingdomBritish19581830001
    CARTER, David Charles
    The Rowans
    Saxilby
    LN1 2SP Lincoln
    1
    England
    Director
    The Rowans
    Saxilby
    LN1 2SP Lincoln
    1
    England
    EnglandBritish136387450002
    GANSSER-POTTS, Michael David
    Broombank Road Sheepbridge
    Chesterfield
    S41 9QJ Derbyshire
    Director
    Broombank Road Sheepbridge
    Chesterfield
    S41 9QJ Derbyshire
    EnglandBritish158445070001
    GRINDY, Roger Sydney
    2 Woodmancourt
    GU7 2BT Godalming
    Surrey
    Director
    2 Woodmancourt
    GU7 2BT Godalming
    Surrey
    British8369140001
    MCINNES, Bruce Gordon, Doctor
    5 Paget Place
    Warren Road
    KT2 7HZ Coombe Hill
    Surrey
    Director
    5 Paget Place
    Warren Road
    KT2 7HZ Coombe Hill
    Surrey
    British2311870001
    MCLINTOCK, Stephen
    Broombank Road Sheepbridge
    Chesterfield
    S41 9QJ Derbyshire
    Director
    Broombank Road Sheepbridge
    Chesterfield
    S41 9QJ Derbyshire
    EnglandBritish222266600001
    NEATE, Jonathan Charles
    Broombank Road Sheepbridge
    Chesterfield
    S41 9QJ Derbyshire
    Director
    Broombank Road Sheepbridge
    Chesterfield
    S41 9QJ Derbyshire
    EnglandBritish150450190001
    PANTRY, Malcolm Swaine
    33 Berwick Close
    Walton
    S40 3NY Chesterfield
    Derbyshire
    Director
    33 Berwick Close
    Walton
    S40 3NY Chesterfield
    Derbyshire
    British37363480001
    PERKINS, John Robert
    46 Broadway Avenue
    B63 3DF Halesowen
    West Midlands
    Director
    46 Broadway Avenue
    B63 3DF Halesowen
    West Midlands
    UkBritish67056290001
    PERKINS, John Anthony
    Southbroom 22 Ince Road
    Burwood Park
    KT12 5BJ Walton On Thames
    Surrey
    Director
    Southbroom 22 Ince Road
    Burwood Park
    KT12 5BJ Walton On Thames
    Surrey
    Irish1809090006
    PERKINS, John Anthony
    Elangeni
    20 Esher Place Avenue
    KT10 8PY Esher
    Surrey
    Director
    Elangeni
    20 Esher Place Avenue
    KT10 8PY Esher
    Surrey
    Irish1809090001
    PRICE, Edmund John
    Idle Hour Lodge 86 Ambleside Road
    GU18 5UJ Lightwater
    Surrey
    Director
    Idle Hour Lodge 86 Ambleside Road
    GU18 5UJ Lightwater
    Surrey
    British45119510001
    RIDGEWAY, Kevin Stuart
    5 Newland Gardens
    Newbold
    S41 7BD Chesterfield
    Derbyshire
    Director
    5 Newland Gardens
    Newbold
    S41 7BD Chesterfield
    Derbyshire
    EnglandBritish73705320001
    ROBINSON, Carl Nigel
    Green Acre
    Withybed Lane
    WR7 4JJ Inkberrow
    Worcestershire
    Director
    Green Acre
    Withybed Lane
    WR7 4JJ Inkberrow
    Worcestershire
    United KingdomBritish74332740003
    SANDERSON, Gary
    Cliffhurst 46 Rectory Road
    Duckmanton
    S44 5JP Chesterfield
    Derbyshire
    Director
    Cliffhurst 46 Rectory Road
    Duckmanton
    S44 5JP Chesterfield
    Derbyshire
    British19581810003
    SEDDON, Walter John
    22 Redhill Street
    NW1 4DQ London
    Director
    22 Redhill Street
    NW1 4DQ London
    South African9996130001
    STAINES, Gordon George John
    11 Lindale Road
    S41 8JH Chesterfield
    Derbyshire
    Director
    11 Lindale Road
    S41 8JH Chesterfield
    Derbyshire
    United KingdomBritish19581840001
    TONGUE, Matthew William
    Broombank Road Sheepbridge
    Chesterfield
    S41 9QJ Derbyshire
    Director
    Broombank Road Sheepbridge
    Chesterfield
    S41 9QJ Derbyshire
    United KingdomBritish188784480001
    WARD, Paul Adrian
    Broombank Road Sheepbridge
    Chesterfield
    S41 9QJ Derbyshire
    Director
    Broombank Road Sheepbridge
    Chesterfield
    S41 9QJ Derbyshire
    EnglandBritish213799490001
    WILKINSON, Stephen Philip
    8 Norton Mews
    Norton
    S8 8HN Sheffield
    Director
    8 Norton Mews
    Norton
    S8 8HN Sheffield
    EnglandBritish35390660002
    BAKER STREET CORPORATE SERVICES LIMITED
    68 Baker Street
    KT13 8AL Weybridge
    Surrey
    Director corporativo
    68 Baker Street
    KT13 8AL Weybridge
    Surrey
    50433100001
    COACH HOUSE MANAGEMENT SERVICES LIMITED
    68 Baker Street
    KT13 8AL Weybridge
    Surrey
    Director corporativo
    68 Baker Street
    KT13 8AL Weybridge
    Surrey
    43767230002

    ¿Quiénes son las personas con control significativo de STAINLESS STEEL FASTENERS LIMITED?

    Personas con control significativo
    NombreNotificado elDirecciónCesado
    Barton Business Park
    Barton Under Needwood
    DE13 8BX Burton-On-Trent
    Unit C
    England
    06 abr 2016
    Barton Business Park
    Barton Under Needwood
    DE13 8BX Burton-On-Trent
    Unit C
    England
    No
    Forma jurídicaPrivate Limited Company
    País de registroEngland
    Autoridad legalEngland And Wales
    Lugar de registroCompanies House
    Número de registro05609369
    Naturaleza del control
    • La persona posee, directa o indirectamente, más del 75% de las acciones de la compañía.

    ¿Tiene STAINLESS STEEL FASTENERS LIMITED alguna carga?

    Gravámenes
    ClasificaciónFechasEstadoDetalles
    Debenture
    Creado el 25 jun 2004
    Entregado el 02 jul 2004
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from any charging company or any other obligor to any secured party under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descripción
    Factory premises, 17 balena close poole, dorset t/no DT26933; 18 balena close poole, dorset t/no DT171260; fixed and floating charge over all property and assets present and future, including goodwill, bookdebts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • Barclays Bank PLC as Security Trustee for Itself and the Other Secured Parties (The Securityagent)
    Transacciones
    • 02 jul 2004Registro de un cargo (395)
    • 05 dic 2005Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Security accession deed
    Creado el 15 ago 2002
    Entregado el 21 ago 2002
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from any charging company or any other obligor to any secured party under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descripción
    By way of first equitable mortgage all the subsidiary shares and investments and all corresponding distribution rights.. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • Barclays Bank PLC (The Security Agent)
    Transacciones
    • 21 ago 2002Registro de un cargo (395)
    • 06 jul 2004Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Collateral mortgage
    Creado el 26 jul 1983
    Entregado el 03 ago 1983
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    For securing all monies due or to become due from to bamford hall holdings limited to the chargee on any account whatsoever the chargee
    Breve descripción
    F/H land 2.02 acres or thereabouts situated n sheepbridge chesterfield.. Together with fixed and moveable plant machinery fixtures implements and utensils.
    Personas con derecho
    • Investors in Industry PLC
    Transacciones
    • 03 ago 1983Registro de una carga
    • 30 jul 1996Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)

    ¿Tiene STAINLESS STEEL FASTENERS LIMITED algún caso de insolvencia?

    Número de expedienteFechasTipoProfesionalesOtro
    1
    FechaTipo
    22 dic 2017Inicio de la liquidación
    21 may 2024Fecha de disolución
    Liquidación voluntaria de acreedores
    NombreRolDirecciónNombrado elCesado el
    Steven John Currie
    Currie Young Limited Alexander House Waters Edge Business Park
    Campbell Road
    ST4 4DB Stoke On Trent
    Staffordshire
    Profesional
    Currie Young Limited Alexander House Waters Edge Business Park
    Campbell Road
    ST4 4DB Stoke On Trent
    Staffordshire

    Fuente de datos

    • Companies House del Reino Unido
      El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros.
    • Licencia: CC0