STAINLESS STEEL FASTENERS LIMITED
Visión general
| Nombre de la empresa | STAINLESS STEEL FASTENERS LIMITED |
|---|---|
| Estado de la empresa | Disuelta |
| Forma jurídica | Sociedad de responsabilidad limitada |
| Número de empresa | 00996214 |
| Jurisdicción | Inglaterra/Gales |
| Fecha de constitución | |
| Fecha de cese |
Resumen
| Tiene PSCs súper seguros | No |
|---|---|
| Tiene gravámenes | Sí |
| Tiene historial de insolvencia | Sí |
| La sede social está en disputa | No |
¿Cuál es el propósito de STAINLESS STEEL FASTENERS LIMITED?
- fabricación de productos de fijación y máquinas de tornillos (25940) / Industrias manufactureras
¿Dónde se encuentra STAINLESS STEEL FASTENERS LIMITED?
| Dirección de la sede social | C/O CURRIE YOUNG LIMITED 10 King Street ST5 1EL Newcastle Under Lyme |
|---|---|
| Dirección de la sede social no entregable | No |
¿Cuáles fueron los nombres anteriores de STAINLESS STEEL FASTENERS LIMITED?
| Nombre de la empresa | Desde | Hasta |
|---|---|---|
| STAINLESS STEEL FASTENERS (CHESTERFIELD) LIMITED | 07 dic 1970 | 07 dic 1970 |
¿Cuáles son las últimas cuentas de STAINLESS STEEL FASTENERS LIMITED?
| Últimas cuentas | |
|---|---|
| Últimas cuentas cerradas hasta | 31 dic 2016 |
¿Cuáles son las últimas presentaciones para STAINLESS STEEL FASTENERS LIMITED?
| Fecha | Descripción | Documento | Tipo | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gaceta final disuelta tras la liquidación | 1 páginas | GAZ2 | ||||||||||
Devolución de la reunión final en una liquidación voluntaria de acreedores | 28 páginas | LIQ14 | ||||||||||
Declaración de recibos y pagos del liquidador hasta 21 dic 2022 | 29 páginas | LIQ03 | ||||||||||
Declaración de recibos y pagos del liquidador hasta 21 dic 2021 | 28 páginas | LIQ03 | ||||||||||
Domicilio social registrado cambiado de C/O Currie Young Limited Alexander House Campbell Road Waters Edge Business Park Stoke on Trent Staffordshire ST4 4DB a 10 King Street Newcastle Under Lyme ST5 1EL el 08 dic 2021 | 2 páginas | AD01 | ||||||||||
Declaración de recibos y pagos del liquidador hasta 21 dic 2020 | 26 páginas | LIQ03 | ||||||||||
Declaración de recibos y pagos del liquidador hasta 21 dic 2019 | 25 páginas | LIQ03 | ||||||||||
Declaración de recibos y pagos del liquidador hasta 21 dic 2018 | 22 páginas | LIQ03 | ||||||||||
Domicilio social registrado cambiado de Unit C Barton Business Park Barton Under Needwood Burton-on-Trent DE13 8BX England a C/O Currie Young Limited Alexander House Campbell Road Waters Edge Business Park Stoke on Trent Staffordshire ST4 4DB el 15 ene 2018 | 2 páginas | AD01 | ||||||||||
Notificación al Registro Mercantil de la notificación de renuncia | 5 páginas | NDISC | ||||||||||
Notificación al Registro Mercantil de la notificación de renuncia | 5 páginas | NDISC | ||||||||||
Notificación al Registro Mercantil de la notificación de renuncia | 5 páginas | NDISC | ||||||||||
Notificación al Registro Mercantil de la notificación de renuncia | 5 páginas | NDISC | ||||||||||
Declaración de asuntos | 12 páginas | LIQ02 | ||||||||||
Nombramiento de un liquidador voluntario | 1 páginas | 600 | ||||||||||
Resoluciones Resolutions | 1 páginas | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Resoluciones Resolutions | 38 páginas | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Modification des détails de International Pipeline Products Limited en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 01 sept 2017 | 2 páginas | PSC05 | ||||||||||
Domicilio social registrado cambiado de Gatherley Road Brompton on Swale Richmond DL10 7JH England a Unit C Barton Business Park Barton Under Needwood Burton-on-Trent DE13 8BX el 07 sept 2017 | 1 páginas | AD01 | ||||||||||
Nombramiento de Mr Timothy John Barnett como director el 01 sept 2017 | 2 páginas | AP01 | ||||||||||
Modification des détails de Truflo International Limited en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 01 sept 2017 | 2 páginas | PSC05 | ||||||||||
Domicilio social registrado cambiado de Broombank Road Sheepbridge Chesterfield Derbyshire S41 9QJ a Gatherley Road Brompton on Swale Richmond DL10 7JH el 05 sept 2017 | 1 páginas | AD01 | ||||||||||
Cese del nombramiento de Paul Adrian Ward como director el 01 sept 2017 | 1 páginas | TM01 | ||||||||||
Cese del nombramiento de Stephen Mclintock como director el 01 sept 2017 | 1 páginas | TM01 | ||||||||||
Cese del nombramiento de Kevin Allsopp como director el 01 sept 2017 | 1 páginas | TM01 | ||||||||||
¿Quiénes son los directivos de STAINLESS STEEL FASTENERS LIMITED?
| Nombre | Nombrado el | Renunció el | Rol | Dirección | Identificación de la empresa | País de residencia | Nacionalidad | Fecha de nacimiento | Ocupación | Número |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BARNETT, Timothy John | Director | King Street ST5 1EL Newcastle Under Lyme 10 | England | British | 141039730001 | |||||
| RODGER, Alan Mcintosh | Director | King Street ST5 1EL Newcastle Under Lyme 10 | United Kingdom | British | 138422370001 | |||||
| ALLSOPP, Kevin | Secretario | Broombank Road Sheepbridge Chesterfield S41 9QJ Derbyshire | 204297380001 | |||||||
| CONNER, Eileen | Secretario | 1 Kipling Drive SW19 1TJ Wimbledon | British | 89546940001 | ||||||
| LAWTON, Kirsten | Secretario | 31 Orchard Avenue KT7 0BB Thames Ditton Surrey | British | 50045660001 | ||||||
| NEATE, Jonathan Charles | Secretario | Broombank Road Sheepbridge Chesterfield S41 9QJ Derbyshire | 187906380001 | |||||||
| RIDGEWAY, Kevin Stuart | Secretario | 5 Newland Gardens Newbold S41 7BD Chesterfield Derbyshire | British | 73705320001 | ||||||
| SANDERSON, Gary | Secretario | Cliffhurst 46 Rectory Road Duckmanton S44 5JP Chesterfield Derbyshire | British | 19581810003 | ||||||
| WILKINSON, Stephen Philip | Secretario | Broombank Road Sheepbridge Chesterfield S41 9QJ Derbyshire | 187436420001 | |||||||
| ADCOCK, Nicholas Simon | Director | Broombank Road Sheepbridge Chesterfield S41 9QJ Derbyshire | England | British | 204292940001 | |||||
| ALLSOPP, Kevin | Director | Broombank Road Sheepbridge Chesterfield S41 9QJ Derbyshire | England | British | 204292980001 | |||||
| BARBER, David Roy, Mr. | Director | 12 Robin Hood Chase Stannington S6 6FH Sheffield South Yorkshire | England | British | 94023010002 | |||||
| BOOTE, David Frank | Director | 8 Alms Hill Drive S11 9QY Sheffield South Yorkshire | United Kingdom | British | 19581830001 | |||||
| CARTER, David Charles | Director | The Rowans Saxilby LN1 2SP Lincoln 1 England | England | British | 136387450002 | |||||
| GANSSER-POTTS, Michael David | Director | Broombank Road Sheepbridge Chesterfield S41 9QJ Derbyshire | England | British | 158445070001 | |||||
| GRINDY, Roger Sydney | Director | 2 Woodmancourt GU7 2BT Godalming Surrey | British | 8369140001 | ||||||
| MCINNES, Bruce Gordon, Doctor | Director | 5 Paget Place Warren Road KT2 7HZ Coombe Hill Surrey | British | 2311870001 | ||||||
| MCLINTOCK, Stephen | Director | Broombank Road Sheepbridge Chesterfield S41 9QJ Derbyshire | England | British | 222266600001 | |||||
| NEATE, Jonathan Charles | Director | Broombank Road Sheepbridge Chesterfield S41 9QJ Derbyshire | England | British | 150450190001 | |||||
| PANTRY, Malcolm Swaine | Director | 33 Berwick Close Walton S40 3NY Chesterfield Derbyshire | British | 37363480001 | ||||||
| PERKINS, John Robert | Director | 46 Broadway Avenue B63 3DF Halesowen West Midlands | Uk | British | 67056290001 | |||||
| PERKINS, John Anthony | Director | Southbroom 22 Ince Road Burwood Park KT12 5BJ Walton On Thames Surrey | Irish | 1809090006 | ||||||
| PERKINS, John Anthony | Director | Elangeni 20 Esher Place Avenue KT10 8PY Esher Surrey | Irish | 1809090001 | ||||||
| PRICE, Edmund John | Director | Idle Hour Lodge 86 Ambleside Road GU18 5UJ Lightwater Surrey | British | 45119510001 | ||||||
| RIDGEWAY, Kevin Stuart | Director | 5 Newland Gardens Newbold S41 7BD Chesterfield Derbyshire | England | British | 73705320001 | |||||
| ROBINSON, Carl Nigel | Director | Green Acre Withybed Lane WR7 4JJ Inkberrow Worcestershire | United Kingdom | British | 74332740003 | |||||
| SANDERSON, Gary | Director | Cliffhurst 46 Rectory Road Duckmanton S44 5JP Chesterfield Derbyshire | British | 19581810003 | ||||||
| SEDDON, Walter John | Director | 22 Redhill Street NW1 4DQ London | South African | 9996130001 | ||||||
| STAINES, Gordon George John | Director | 11 Lindale Road S41 8JH Chesterfield Derbyshire | United Kingdom | British | 19581840001 | |||||
| TONGUE, Matthew William | Director | Broombank Road Sheepbridge Chesterfield S41 9QJ Derbyshire | United Kingdom | British | 188784480001 | |||||
| WARD, Paul Adrian | Director | Broombank Road Sheepbridge Chesterfield S41 9QJ Derbyshire | England | British | 213799490001 | |||||
| WILKINSON, Stephen Philip | Director | 8 Norton Mews Norton S8 8HN Sheffield | England | British | 35390660002 | |||||
| BAKER STREET CORPORATE SERVICES LIMITED | Director corporativo | 68 Baker Street KT13 8AL Weybridge Surrey | 50433100001 | |||||||
| COACH HOUSE MANAGEMENT SERVICES LIMITED | Director corporativo | 68 Baker Street KT13 8AL Weybridge Surrey | 43767230002 |
¿Quiénes son las personas con control significativo de STAINLESS STEEL FASTENERS LIMITED?
| Nombre | Notificado el | Dirección | Cesado | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| International Piping Products (Europe) Limited | 06 abr 2016 | Barton Business Park Barton Under Needwood DE13 8BX Burton-On-Trent Unit C England | No | ||||||||||
| |||||||||||||
Naturaleza del control
| |||||||||||||
¿Tiene STAINLESS STEEL FASTENERS LIMITED alguna carga?
| Clasificación | Fechas | Estado | Detalles | |
|---|---|---|---|---|
| Debenture | Creado el 25 jun 2004 Entregado el 02 jul 2004 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All monies due or to become due from any charging company or any other obligor to any secured party under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Breve descripción Factory premises, 17 balena close poole, dorset t/no DT26933; 18 balena close poole, dorset t/no DT171260; fixed and floating charge over all property and assets present and future, including goodwill, bookdebts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
| Security accession deed | Creado el 15 ago 2002 Entregado el 21 ago 2002 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All monies due or to become due from any charging company or any other obligor to any secured party under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Breve descripción By way of first equitable mortgage all the subsidiary shares and investments and all corresponding distribution rights.. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
| Collateral mortgage | Creado el 26 jul 1983 Entregado el 03 ago 1983 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada For securing all monies due or to become due from to bamford hall holdings limited to the chargee on any account whatsoever the chargee | |
Breve descripción F/H land 2.02 acres or thereabouts situated n sheepbridge chesterfield.. Together with fixed and moveable plant machinery fixtures implements and utensils. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
¿Tiene STAINLESS STEEL FASTENERS LIMITED algún caso de insolvencia?
| Número de expediente | Fechas | Tipo | Profesionales | Otro | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
| Liquidación voluntaria de acreedores |
|
Fuente de datos
- Companies House del Reino Unido
El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros. - Licencia: CC0