RFB OLD CO LIMITED
Visión general
| Nombre de la empresa | RFB OLD CO LIMITED |
|---|---|
| Estado de la empresa | Disuelta |
| Forma jurídica | Sociedad de responsabilidad limitada |
| Número de empresa | 00998670 |
| Jurisdicción | Inglaterra/Gales |
| Fecha de constitución | |
| Fecha de cese |
Resumen
| Tiene PSCs súper seguros | No |
|---|---|
| Tiene gravámenes | Sí |
| Tiene historial de insolvencia | No |
| La sede social está en disputa | No |
¿Cuál es el propósito de RFB OLD CO LIMITED?
- Fabricación de otros productos alimenticios, n.c.o.p. (10890) / Industrias manufactureras
¿Dónde se encuentra RFB OLD CO LIMITED?
| Dirección de la sede social | Premier House Centrium Business Park AL1 2RE Griffiths Way, St. Albans Hertfordshire |
|---|---|
| Dirección de la sede social no entregable | No |
¿Cuáles fueron los nombres anteriores de RFB OLD CO LIMITED?
| Nombre de la empresa | Desde | Hasta |
|---|---|---|
| R.F. BROOKES LIMITED | 25 ene 1982 | 25 ene 1982 |
| R.F.BROOKES(LEICESTER)LIMITED | 01 ene 1971 | 01 ene 1971 |
¿Cuáles son las últimas cuentas de RFB OLD CO LIMITED?
| Últimas cuentas | |
|---|---|
| Últimas cuentas cerradas hasta | 31 dic 2011 |
¿Cuáles son las últimas presentaciones para RFB OLD CO LIMITED?
| Fecha | Descripción | Documento | Tipo | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Boletín oficial final disuelto por cancelación obligatoria | 1 páginas | GAZ2 | ||||||||||||||
Primer aviso en el boletín oficial para la cancelación obligatoria | 1 páginas | GAZ1 | ||||||||||||||
Cese del nombramiento de Andrew John Mcdonald como director el 23 may 2018 | 1 páginas | TM01 | ||||||||||||||
Restauración por orden judicial | 3 páginas | AC92 | ||||||||||||||
Boletín oficial final disuelto por cancelación obligatoria | 1 páginas | GAZ2 | ||||||||||||||
Primer aviso en el boletín oficial para la cancelación obligatoria | 1 páginas | GAZ1 | ||||||||||||||
Cese del nombramiento de Emmett Mcevoy como director el 11 nov 2016 | 1 páginas | TM01 | ||||||||||||||
Restauración por orden judicial | 8 páginas | AC92 | ||||||||||||||
Boletín oficial final disuelto por cancelación voluntaria | 1 páginas | GAZ2(A) | ||||||||||||||
Déclaration annuelle établie au 30 sept 2013 avec liste complète des actionnaires | 4 páginas | AR01 | ||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Primer aviso en el boletín oficial para la cancelación voluntaria | 1 páginas | GAZ1(A) | ||||||||||||||
La acción de exclusión voluntaria ha sido suspendida | 1 páginas | SOAS(A) | ||||||||||||||
Solicitud de exclusión de la empresa del registro | 3 páginas | DS01 | ||||||||||||||
Déclaration annuelle établie au 30 sept 2012 avec liste complète des actionnaires | 5 páginas | AR01 | ||||||||||||||
Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 31 dic 2011 | 7 páginas | AA | ||||||||||||||
Nombramiento de Emmett Mcevoy como director | 2 páginas | AP01 | ||||||||||||||
Cese del nombramiento de Antony Smith como director | 1 páginas | TM01 | ||||||||||||||
Certificado de cambio de nombre Company name changed R.F. brookes LIMITED\certificate issued on 05/12/11 | 3 páginas | CERTNM | ||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Nombramiento de Mr Andrew Mcdonald como director | 2 páginas | AP01 | ||||||||||||||
Cese del nombramiento de Suzanne Wise como director | 1 páginas | TM01 | ||||||||||||||
Resoluciones Resolutions | 34 páginas | RESOLUTIONS | ||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Declaración de los objetos de la sociedad | 2 páginas | CC04 | ||||||||||||||
Aviso de eliminación de la restricción sobre los estatutos de la sociedad | 2 páginas | CC02 | ||||||||||||||
Déclaration annuelle établie au 30 sept 2011 avec liste complète des actionnaires | 4 páginas | AR01 | ||||||||||||||
Déclaration annuelle établie au 01 ago 2011 avec liste complète des actionnaires | 4 páginas | AR01 | ||||||||||||||
¿Quiénes son los directivos de RFB OLD CO LIMITED?
| Nombre | Nombrado el | Renunció el | Rol | Dirección | Identificación de la empresa | País de residencia | Nacionalidad | Fecha de nacimiento | Ocupación | Número |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WILBRAHAM, Simon Nicholas | Secretario | Premier House Centrium Business Park AL1 2RE Griffiths Way, St. Albans Hertfordshire | British | 125719290002 | ||||||
| WILBRAHAM, Simon Nicholas | Director | Premier House Centrium Business Park AL1 2RE Griffiths Way, St. Albans Hertfordshire | England | British | 125719290002 | |||||
| BURTON, Denise Patricia | Secretario | 55 Kingston Hill Place Kingston Hill KT2 7QY Kingston Upon Thames Surrey | British | 47432570002 | ||||||
| HARTREY, Patrick Mark | Secretario | 30 Colham Road UB8 3WQ Hillingdon Middlesex | British | 50340730004 | ||||||
| HINES, Christine Anne | Secretario | 33 Sandhills Road Barnt Green B45 8NP Birmingham | British | 27217290001 | ||||||
| MILLER, Roger Keith | Secretario | Hatters Barn Stockwell Lane Little Meadle HP17 9UG Aylesbury Buckinghamshire | British | 120645920001 | ||||||
| WATERS, Paul Christopher | Secretario | Avenue Road CV37 6UW Stratford-Upon-Avon 37 Warwickshire United Kingdom | British | 126327110002 | ||||||
| WILBRAHAM, Simon Nicholas | Secretario | Queens Crescent AL4 9QG St. Albans 19 Hertfordshire United Kingdom | British | 125719290002 | ||||||
| WOODMORE, Michael Brian | Secretario | 59 Terrington Hill SL7 2RE Marlow Buckinghamshire | British | 37177620001 | ||||||
| ALLNER, Andrew James | Director | 9 The Crescent Barnes SW13 0NN London | British | 73003300001 | ||||||
| CLARKE, Adam David | Director | Braeside House NP25 4JG Mitchel Troy Common Monmouthshire | United Kingdom | British | 87570630001 | |||||
| CLARKE, Jonathan Michael Rushton | Director | 1 Newalls Rise RG10 8AY Wargrave Berkshire | United Kingdom | British | 98818450001 | |||||
| COLES, Philip David | Director | Barn End Cashes Farm Elmbridge Lane Elmbridge WR9 0NQ Droitwich Worcestershire | England | British | 105679940001 | |||||
| CROSSLEY, Nigel | Director | HP9 | England | British | 145901880001 | |||||
| DUNCAN, Ian Alexander | Director | Durham House Durham Place SW3 4ET London | United Kingdom | British | 27300002 | |||||
| HARGREAVES, Stephen John | Director | Stable House Smeeton Road LE8 0QT Saddington Leicestershire | Great Britain | British | 99437380001 | |||||
| HODSON, Mark Anthony | Director | Orchard Barn Bulby PE10 0RU Bourne Lincolnshire | England | British | 142364940001 | |||||
| HUMPHREY, Paul | Director | 16 Shelley Road HP11 2UP High Wycombe Buckinghamshire | British | 86203530001 | ||||||
| JACKSON, Timothy Mark | Director | 5 Palace Road Llandaf CF5 2AF Cardiff | British | 54757060001 | ||||||
| KELLY, Timothy Geoffrey | Director | The Mansion House Abbotts Inn SP11 7AU Andover Hampshire | England | British | 92817300001 | |||||
| LAWSON, Robert | Director | 36 Exeter Road NW2 4SB London | England | British | 99991140001 | |||||
| MARCHANT, Richard Norman | Director | 60 The Mount Curdworth B76 9HR Sutton Coldfield West Midlands | British | 26880001 | ||||||
| MCDONALD, Andrew John | Director | Centrium Business Park Griffiths Way AL1 2RE St Albans Premier House Hertfordshire | England | British | 164670820001 | |||||
| MCEVOY, Emmett | Director | Centrium Business Park Griffiths Way AL1 2RE St Albans Premier House Hertfordshire United Kingdom | United Kingdom | Irish | 168590540001 | |||||
| MCMAHON, Ian Reid | Director | The Gate House Burfield Road SL4 2LH Old Windsor Berkshire | British | 84644240002 | ||||||
| MURPHY, Thomas Jerome Peter | Director | 9 One Tree Lane HP9 2BU Beaconsfield Buckinghamshire | British | 76945730001 | ||||||
| OAKLEY, Christopher Richard | Director | 26 Long Park Chesham Bois HP6 5LA Amersham Buckinghamshire | England | British | 124625030001 | |||||
| PANTER, Alan James, Mr. | Director | 14 Thornhill Bridge Wharf N1 0RU London | British | 114414690002 | ||||||
| PEELER, Andrew Michael | Director | 108 Ellesborough Road Wendover HP22 6EW Aylesbury Buckinghamshire | United Kingdom | British | 87359710001 | |||||
| PICKERING, Alistair Neil | Director | 13 Upper Cranbrook Road Redland BS6 7UW Bristol | United Kingdom | British | 83785410002 | |||||
| QUICK, Nigel Robert | Director | Autumn Cottage 8 Gladstone Street LE8 0HL Kibworth Beauchamp Leicestershire | British | 36629900001 | ||||||
| RUDDICK, Ian William | Director | 32 Woodend Drive SL5 9BG Ascot Berkshire | United Kingdom | British | 98350001 | |||||
| SCHURCH, Michael John | Director | 1 Aldersey Road GU1 2ER Guildford Surrey | United Kingdom | British | 42065200002 | |||||
| SIMMONS, Alex Thomas | Director | 39 Pedmore Lane Pedmore DY9 0SY Stourbridge West Midlands | United Kingdom | British | 105865430001 | |||||
| SMITH, Antony David | Director | Centrium Business Park Griffiths Way AL1 2RE St Albans Premier House Hertfordshire | United Kingdom | British | 147725160001 |
¿Tiene RFB OLD CO LIMITED alguna carga?
| Clasificación | Fechas | Estado | Detalles | |
|---|---|---|---|---|
| Debenture | Creado el 26 jul 2004 Entregado el 06 ago 2004 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All monies due or to become due from each obligor to the lenders (or any of them) under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Breve descripción Wern industrial estate rogerstone newport gwent f/h t/n's WA717549 WA77355 WA535808. Magna road south wigston leicester f/h t/n LT211256. Rogerstone park newport gwent f/h t/n WA859509. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
| Debenture between rhm group one limited, the chargors and the chargees (all as defined) | Creado el 11 sept 2000 Entregado el 23 sept 2000 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All present and future obligations and liabilities (whether actual or contingent and whether owed jointly or severally or in any other capacity whatsoever) of each obligor to the chargee (or any of them) under the finance documents (or any of them), together with all costs charges and expenses incurred by the lenders (or any of them) in connection with the protection, preservation or enforcement of it's respective rights under the finance documents for which any obligor is liable under the finance documents except any obligation, which, if it were so included, would result in the debenture contravening 151 of the companies act 1985, section 60 of the republic of ireland act 1963 or companies (northern ireland) order 1996. | |
Breve descripción .. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
Fuente de datos
- Companies House del Reino Unido
El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros. - Licencia: CC0