AEROSYSTEMS INTERNATIONAL LIMITED
Visión general
| Nombre de la empresa | AEROSYSTEMS INTERNATIONAL LIMITED |
|---|---|
| Estado de la empresa | Disuelta |
| Forma jurídica | Sociedad de responsabilidad limitada |
| Número de empresa | 01001553 |
| Jurisdicción | Inglaterra/Gales |
| Fecha de constitución | |
| Fecha de cese |
Resumen
| Tiene PSCs súper seguros | No |
|---|---|
| Tiene gravámenes | No |
| Tiene historial de insolvencia | Sí |
| La sede social está en disputa | No |
¿Cuál es el propósito de AEROSYSTEMS INTERNATIONAL LIMITED?
- Empresa inactiva (99999) / Actividades de organizaciones y organismos extraterritoriales
¿Dónde se encuentra AEROSYSTEMS INTERNATIONAL LIMITED?
| Dirección de la sede social | 10 Fleet Place EC4M 7QS London |
|---|---|
| Dirección de la sede social no entregable | No |
¿Cuáles fueron los nombres anteriores de AEROSYSTEMS INTERNATIONAL LIMITED?
| Nombre de la empresa | Desde | Hasta |
|---|---|---|
| STEPHEN HOWE LIMITED | 25 ago 1982 | 25 ago 1982 |
| STEPHEN HOWE CONSULTANTS LIMITED | 31 dic 1979 | 31 dic 1979 |
| STEPHEN HOWE (CONSULTANTS) LIMITED | 03 feb 1971 | 03 feb 1971 |
¿Cuáles son las últimas cuentas de AEROSYSTEMS INTERNATIONAL LIMITED?
| Últimas cuentas | |
|---|---|
| Últimas cuentas cerradas hasta | 31 dic 2018 |
¿Cuáles son las últimas presentaciones para AEROSYSTEMS INTERNATIONAL LIMITED?
| Fecha | Descripción | Documento | Tipo | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gaceta final disuelta tras la liquidación | 1 páginas | GAZ2 | ||||||||||
Devolución de la reunión final en una liquidación voluntaria de miembros | 7 páginas | LIQ13 | ||||||||||
Domicilio social registrado cambiado de 15 Canada Square London E14 5GL a 10 Fleet Place London EC4M 7QS el 14 dic 2021 | 2 páginas | AD01 | ||||||||||
Renuncia de un liquidador | 3 páginas | LIQ06 | ||||||||||
Nombramiento de un liquidador voluntario | 42 páginas | 600 | ||||||||||
Declaración de recibos y pagos del liquidador hasta 28 ene 2021 | 6 páginas | LIQ03 | ||||||||||
Domicilio social registrado cambiado de Lupin Way Alvington Yeovil Somerset BA22 8UZ a 15 Canada Square London E14 5GL el 17 feb 2020 | 2 páginas | AD01 | ||||||||||
Declaración de solvencia | 5 páginas | LIQ01 | ||||||||||
Nombramiento de un liquidador voluntario | 3 páginas | 600 | ||||||||||
Resoluciones Resolutions | 1 páginas | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Cese del nombramiento de Anthony Peter Varney como director el 30 sept 2019 | 1 páginas | TM01 | ||||||||||
Nombramiento de Mr James Edward Fothergill como director el 30 sept 2019 | 2 páginas | AP01 | ||||||||||
Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 31 dic 2018 | 9 páginas | AA | ||||||||||
Declaración de confirmación presentada el 12 jun 2019 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||||||||||
Declaración de confirmación presentada el 12 jun 2018 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||||||||||
Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 31 dic 2017 | 9 páginas | AA | ||||||||||
Nombramiento de Mr Adam William Morgan como director el 02 may 2018 | 2 páginas | AP01 | ||||||||||
Cese del nombramiento de Paul Christopher Burke como director el 25 ago 2017 | 1 páginas | TM01 | ||||||||||
Declaración de confirmación presentada el 12 jun 2017 con actualizaciones | 5 páginas | CS01 | ||||||||||
Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 31 dic 2016 | 8 páginas | AA | ||||||||||
Cuentas completas preparadas hasta el 31 dic 2015 | 12 páginas | AA | ||||||||||
Déclaration annuelle établie au 12 jun 2016 avec liste complète des actionnaires | 5 páginas | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Cuentas completas preparadas hasta el 31 dic 2014 | 13 páginas | AA | ||||||||||
Cese del nombramiento de Paul Tortolano como director el 26 jun 2015 | 1 páginas | TM01 | ||||||||||
Cese del nombramiento de Michael Christie como director el 26 jun 2015 | 1 páginas | TM01 | ||||||||||
¿Quiénes son los directivos de AEROSYSTEMS INTERNATIONAL LIMITED?
| Nombre | Nombrado el | Renunció el | Rol | Dirección | Identificación de la empresa | País de residencia | Nacionalidad | Fecha de nacimiento | Ocupación | Número |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HOLDING, Ann Louise | Secretario | c/o Bae Systems - Company Secretariat PO BOX 87 Farnborough Aerospace Centre GU14 6YU Farnborough Warwick House Hampshire | British | 176048900001 | ||||||
| FOTHERGILL, James Edward | Director | Warwick House, PO BOX 87 Farnborough Aerospace Centre GU14 6YU Farnborough C/O Bae Systems - Company Secretariat Hants. United Kingdom | United Kingdom | British | 263300650001 | |||||
| MORGAN, Adam William | Director | Warwick House, PO BOX 87 Farnborough Aerospace Centre GU14 6YU Farnborough C/O Bae Systems - Company Secretariat Hants. United Kingdom | England | British | 245983420001 | |||||
| FRAMPTON, Linda Nina | Secretario | 36 Carters Rise Calcot RG3 5XS Reading Berkshire | British | 900760001 | ||||||
| HARTLEY, Julian Mark | Secretario | 32 Essex Road WD17 4EP Watford Hertfordshire | British | 85284520001 | ||||||
| LIVINGSTONE, Robert Murray | Secretario | Esperanza Main Road Aust BS35 4AX Bristol | British | 48211350001 | ||||||
| MASON, Geoffrey Keith Howard | Secretario | 5 Monmouth Road Harlington LU5 6NE Dunstable Bedfordshire | British | 37404250001 | ||||||
| MCMANUS, Peter Duncan | Secretario | Longton Road M6 7QW Salford 1a Lancashire | British | 131011740001 | ||||||
| MOXHAM, Simon John | Secretario | 1 Glen Avenue Abbots Leigh BS8 3SD Bristol Avon | British | 87711880001 | ||||||
| MOXHAM, Simon John | Secretario | 1 Glen Avenue Abbots Leigh BS8 3SD Bristol Avon | British | 87711880001 | ||||||
| WHITE, David Thomas | Secretario | Whitestones 59 Ashley Common Road BH25 5AN New Milton Hampshire | British | 72450410001 | ||||||
| BILLINGHAM, Nigel Anthony | Director | 20 Smithbarn RH13 6EB Horsham West Sussex | British | 2403250001 | ||||||
| BLUNDELL, Phillip Scott | Director | The Firs 2 Woodville Terrace FY8 5QB Lytham St Annes Lancashire | England | British | 111325470001 | |||||
| BOOTH, Ian | Director | White Lodge Church Road GU51 4LY Fleet Hampshire | British | 71476100002 | ||||||
| BURKE, Paul Christopher | Director | Warwick House, PO BOX 87 Farnborough Aerospace Centre GU14 6YU Farnborough C/O Bae Systems - Company Secretariat Hants. United Kingdom | United Kingdom | British | 198896680001 | |||||
| BURKE, Paul Christopher | Director | 9 Lansdown Park BA1 5TG Bath Somerset | Uk | British | 98074570002 | |||||
| CASE, Richard Ian | Director | Melchester House Horsington BA8 0EG Templecombe Somerset | England | British | 3618430001 | |||||
| CHIPCHASE, Graham Andrew | Director | Brook Cottage Kings Saltern Road SO41 3QH Lymington Hampshire | British | 64473880001 | ||||||
| CHISNALL, Graham | Director | 10 Pear Tree Lane GU10 4DW Rowledge Little Orchard Surrey | United Kingdom | British | 135061600001 | |||||
| CHRISTIE, Michael | Director | Warwick House, PO BOX 87 Farnborough Aerospace Centre GU14 6YU Farnborough C/O Bae Systems - Company Secretariat Hants. United Kingdom | United Kingdom | British | 190397800001 | |||||
| DORRIAN, Alexander Moore | Director | Creggans Fredley Park Mickleham RH5 6DD Dorking Surrey | British | 67710500002 | ||||||
| FERRERO, Graeme Tweedy | Director | 21 Neville Avenue KT3 4SN New Malden Surrey | England | British | 142329290001 | |||||
| FISHBURNE, Alun William | Director | Warwick House PO BOX 87 Farnborough Aerospace Centre GU14 6YU Farnborough C/O Bae Systems-Company Secretaiat Hampshire United Kingdom | England | British | 162720930001 | |||||
| FISHER, Rory Mcculloch | Director | 14 Vicarage Way SL9 8AS Gerrards Cross Buckinghamshire | England | British | 207535160001 | |||||
| GODDARD, Philip Norman | Director | Brympton Barn Middle Chinnock TA18 7PN Crewkerne Somerset | British | 7874760002 | ||||||
| HURST, David Christopher | Director | 30a Main Street Mursley MK17 0RT Milton Keynes Buckinghamshire | British | 56770390001 | ||||||
| JOHNSTON, Alan John | Director | Loews Nether Compton DT9 4QA Sherborne Dorset | England | British | 57095240001 | |||||
| KING, Ian Graham, Mr. | Director | 6 Carlton Gardens SW1Y 5AD London Bae Systems | United Kingdom | British | 14823500003 | |||||
| MILNE, Andrew David Philip | Director | Angiers Farm Angiers Lane Fiddleford DT10 2BY Sturminster Newton Dorset | British | 46472060003 | ||||||
| MOXHAM, Simon John | Director | Alvington BA22 8UZ Yeovil Lupin Way Somerset | Uk | British | 87711880001 | |||||
| OSBORNE, Alan | Director | 15 Fir Grove KY11 8BN Dunfermline Fife | British | 80696170001 | ||||||
| OSWALD, John Julian Robertson, Admiral Of The Fleet Sir | Director | Sudlows Shedfield SO32 2HN Southampton Hampshire | British | 37689230002 | ||||||
| ROY, Scott Drysdale | Director | 1 Lower Wraxhill Road BA20 2JU Yeovil Somerset | United Kingdom | Scottish | 151749300001 | |||||
| SEEGER, William Claire | Director | 45 High Point Lane Bentleyville Ohio 44022 Usa | American | 124634530001 | ||||||
| SHELLEY, Roy Derek | Director | 19 Thorne Lane BA21 3LU Yeovil Somerset | British | 12970720001 |
¿Quiénes son las personas con control significativo de AEROSYSTEMS INTERNATIONAL LIMITED?
| Nombre | Notificado el | Dirección | Cesado | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bae Systems (Holdings) Limited | 06 abr 2016 | PO BOX 87 Farnborough Aerospace Centre GU14 6YU Farnborough Warwick House Hampshire United Kingdom | No | ||||||||||
| |||||||||||||
Naturaleza del control
| |||||||||||||
¿Tiene AEROSYSTEMS INTERNATIONAL LIMITED algún caso de insolvencia?
| Número de expediente | Fechas | Tipo | Profesionales | Otro | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
| Liquidación voluntaria de socios |
|
Fuente de datos
- Companies House del Reino Unido
El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros. - Licencia: CC0