HEATH INSURANCE BROKING LIMITED

HEATH INSURANCE BROKING LIMITED

  • Visión general
  • Resumen
  • Propósito
  • Dirección
  • Nombres anteriores
  • Cuentas
  • Presentaciones
  • Directivos
  • Personas con control significativo
  • Gravámenes
  • Fuente de datos
  • Visión general

    Nombre de la empresaHEATH INSURANCE BROKING LIMITED
    Estado de la empresaDisuelta
    Forma jurídicaSociedad de responsabilidad limitada
    Número de empresa 01005219
    JurisdicciónInglaterra/Gales
    Fecha de constitución
    Fecha de cese

    Resumen

    Tiene PSCs súper segurosNo
    Tiene gravámenes
    Tiene historial de insolvenciaNo
    La sede social está en disputaNo

    ¿Cuál es el propósito de HEATH INSURANCE BROKING LIMITED?

    • Seguros no de vida (65120) / Actividades financieras y de seguros

    ¿Dónde se encuentra HEATH INSURANCE BROKING LIMITED?

    Dirección de la sede social
    The Walbrook Building
    25 Walbrook
    EC4N 8AW London
    Dirección de la sede social no entregableNo

    ¿Cuáles fueron los nombres anteriores de HEATH INSURANCE BROKING LIMITED?

    Nombres anteriores de la empresa
    Nombre de la empresaDesdeHasta
    C E HEATH (INSURANCE BROKING) LIMITED25 abr 198825 abr 1988
    C.E. HEATH & CO. (INSURANCE BROKING) LIMITED18 mar 197118 mar 1971

    ¿Cuáles son las últimas cuentas de HEATH INSURANCE BROKING LIMITED?

    Últimas cuentas
    Últimas cuentas cerradas hasta31 dic 2017

    ¿Cuáles son las últimas presentaciones para HEATH INSURANCE BROKING LIMITED?

    Presentaciones
    FechaDescripciónDocumentoTipo

    Boletín oficial final disuelto por cancelación voluntaria

    1 páginasGAZ2(A)

    Primer aviso en el boletín oficial para la cancelación voluntaria

    1 páginasGAZ1(A)

    Solicitud de exclusión de la empresa del registro

    3 páginasDS01

    Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 31 dic 2017

    7 páginasAA

    Nombramiento de Mr Alistair Charles Peel como secretario el 09 ago 2018

    2 páginasAP03

    Cese del nombramiento de William Lindsay Mcgowan como secretario el 09 ago 2018

    1 páginasTM02

    Declaración de confirmación presentada el 31 ene 2018 sin actualizaciones

    3 páginasCS01

    Cuentas completas preparadas hasta el 31 dic 2016

    13 páginasAA

    Declaración de confirmación presentada el 31 ene 2017 con actualizaciones

    5 páginasCS01

    Cuentas completas preparadas hasta el 31 dic 2015

    13 páginasAA

    Déclaration annuelle établie au 31 ene 2016 avec liste complète des actionnaires

    3 páginasAR01
    Presentaciones asociadas
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    capital02 feb 2016

    Estado de capital el 02 feb 2016

    • Capital: GBP 55
    SH01

    Cuentas completas preparadas hasta el 31 dic 2014

    11 páginasAA

    Nombramiento de Mr Matthew Pike como director el 09 feb 2015

    2 páginasAP01

    Cese del nombramiento de David Christopher Ross como director el 09 feb 2015

    1 páginasTM01

    Déclaration annuelle établie au 31 ene 2015 avec liste complète des actionnaires

    3 páginasAR01
    Presentaciones asociadas
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    capital05 feb 2015

    Estado de capital el 05 feb 2015

    • Capital: GBP 55
    SH01

    Cese del nombramiento de Mark Stephen Mugge como director el 26 ene 2015

    1 páginasTM01

    Cuentas completas preparadas hasta el 31 dic 2013

    11 páginasAA

    Déclaration annuelle établie au 31 ene 2014 avec liste complète des actionnaires

    4 páginasAR01
    Presentaciones asociadas
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    capital03 feb 2014

    Estado de capital el 03 feb 2014

    • Capital: GBP 55
    SH01

    Cuentas completas preparadas hasta el 31 dic 2012

    11 páginasAA

    Domicilio social registrado cambiado de * 9 Alie Street London E1 8DE* el 19 ago 2013

    1 páginasAD01

    Nombramiento de Mr William Lindsay Mcgowan como secretario

    1 páginasAP03

    Cese del nombramiento de Hl Corporate Services Limited como secretario

    1 páginasTM02

    Déclaration annuelle établie au 31 ene 2013 avec liste complète des actionnaires

    4 páginasAR01

    Cambio de datos del director Mr David Christopher Ross el 11 oct 2012

    3 páginasCH01

    Cuentas completas preparadas hasta el 31 dic 2011

    12 páginasAA

    ¿Quiénes son los directivos de HEATH INSURANCE BROKING LIMITED?

    Directivos
    NombreNombrado elRenunció elRolDirecciónIdentificación de la empresaPaís de residenciaNacionalidadFecha de nacimientoOcupaciónNúmero
    PEEL, Alistair Charles
    25 Walbrook
    EC4N 8AW London
    The Walbrook Building
    Secretario
    25 Walbrook
    EC4N 8AW London
    The Walbrook Building
    249410010001
    PIKE, Matthew William
    25 Walbrook
    EC4N 8AW London
    The Walbrook Building
    Director
    25 Walbrook
    EC4N 8AW London
    The Walbrook Building
    EnglandBritish187274510001
    MCGOWAN, William Lindsay
    25 Walbrook
    EC4N 8AW London
    The Walbrook Building
    United Kingdom
    Secretario
    25 Walbrook
    EC4N 8AW London
    The Walbrook Building
    United Kingdom
    180337270001
    ROWE, Nicholas
    Amberly House
    The Cleave
    OX11 0EL Harwell
    Oxfordshire
    Secretario
    Amberly House
    The Cleave
    OX11 0EL Harwell
    Oxfordshire
    British33862660001
    SHARP, Pandora
    Flat 9 Da Vinci Court
    1 Rossetti Road
    SE16 3EA London
    Secretario
    Flat 9 Da Vinci Court
    1 Rossetti Road
    SE16 3EA London
    British64972020003
    WILKINSON, Sidney James
    67 Chessfield Park
    Little Chalfont
    HP6 6RU Amersham
    Buckinghamshire
    Secretario
    67 Chessfield Park
    Little Chalfont
    HP6 6RU Amersham
    Buckinghamshire
    British1138390001
    WILKINSON, Sidney James
    67 Chessfield Park
    Little Chalfont
    HP6 6RU Amersham
    Buckinghamshire
    Secretario
    67 Chessfield Park
    Little Chalfont
    HP6 6RU Amersham
    Buckinghamshire
    British1138390001
    HL CORPORATE SERVICES LIMITED
    Houndsditch
    EC3A 7AH London
    133
    United Kingdom
    Secretario corporativo
    Houndsditch
    EC3A 7AH London
    133
    United Kingdom
    Tipo de identificaciónEEE
    Número de registro1054707
    43700080007
    BARTON, Michael Keith
    Alie Street
    E1 8DE London
    9
    Director
    Alie Street
    E1 8DE London
    9
    EnglandUnited States109126210001
    BLOOMER, William David
    Barry Road
    East Dulwich
    SE22 0JS London
    214
    Director
    Barry Road
    East Dulwich
    SE22 0JS London
    214
    United KingdomBritish72374560002
    BROADHURST, Timothy Edward
    Highfield House Main Road
    Knockholt
    TN14 7NU Sevenoaks
    Kent
    Director
    Highfield House Main Road
    Knockholt
    TN14 7NU Sevenoaks
    Kent
    United KingdomBritish8657480001
    BRUCE, Michael Andrew
    Royston Manor St Peter's Lane
    Clayworth
    DN22 9AA Retford
    Nottinghamshire
    Director
    Royston Manor St Peter's Lane
    Clayworth
    DN22 9AA Retford
    Nottinghamshire
    United KingdomBritish61928170002
    BURTON, Michael John
    4a Langton Way
    SE3 7TL London
    Director
    4a Langton Way
    SE3 7TL London
    British63922600001
    COLOSSO, Adrian
    Burnham Road
    Woodham Mortimer
    CM9 6SP Maldon
    Hillside Farm
    Essex
    Director
    Burnham Road
    Woodham Mortimer
    CM9 6SP Maldon
    Hillside Farm
    Essex
    EnglandBritish4555310002
    DEXTER, Neil Edward
    1 Courtlands
    Prince Imperial Road
    BR7 5LX Chislehurst
    Kent
    Director
    1 Courtlands
    Prince Imperial Road
    BR7 5LX Chislehurst
    Kent
    EnglandBritish42053970001
    ELDRET, Kenneth George
    Broadmead
    3 Franklands Gardens
    RH15 0UJ Burgess Hill
    West Sussex
    Director
    Broadmead
    3 Franklands Gardens
    RH15 0UJ Burgess Hill
    West Sussex
    British34990880001
    FIELDING, Richard Walter
    West Hall
    Longburton
    DT9 5PF Sherborne
    Dorset
    Director
    West Hall
    Longburton
    DT9 5PF Sherborne
    Dorset
    United KingdomBritish77656210001
    HARRISON, Robert Melville
    Flint Cottage 53 Ridgway Road
    GU9 8NR Farnham
    Surrey
    Director
    Flint Cottage 53 Ridgway Road
    GU9 8NR Farnham
    Surrey
    British8722560001
    HORNER, Frank Henry Leslie
    Pettits House Mountnessing Lane
    Doddinghurst
    CM15 0SP Brentwood
    Essex
    Director
    Pettits House Mountnessing Lane
    Doddinghurst
    CM15 0SP Brentwood
    Essex
    British28353000001
    HUGHES, Michael Harold
    881 Ocean Drive
    Appartment 16 F
    USA Key Biscayne
    Florida
    Director
    881 Ocean Drive
    Appartment 16 F
    USA Key Biscayne
    Florida
    British65226980002
    HUGHES, Paul John
    96 Burnham Road
    SS9 2JS Leigh On Sea
    Essex
    Director
    96 Burnham Road
    SS9 2JS Leigh On Sea
    Essex
    EnglandBritish5389800001
    KAUFMAN, John Banwell
    6 Scotsdale Close
    BR5 1NU Petts Wood
    Kent
    Director
    6 Scotsdale Close
    BR5 1NU Petts Wood
    Kent
    EnglandBritish147388510001
    KIER, Michael Hector
    23 Belmont Road
    TW2 5DA Twickenham
    Middlesex
    Director
    23 Belmont Road
    TW2 5DA Twickenham
    Middlesex
    Danish8719670001
    LETBY, Roger David
    19 Alverton Close
    Great Notley
    CM7 8XU Braintree
    Essex
    Director
    19 Alverton Close
    Great Notley
    CM7 8XU Braintree
    Essex
    British28585270003
    MACKAY, Ian Hamish Noel
    27 Percy Laurie House
    217 Upper Richmond Road
    SW15 6SY London
    Director
    27 Percy Laurie House
    217 Upper Richmond Road
    SW15 6SY London
    British104334150001
    MACKENZIE GREEN, John Garvie
    Higher Langdon
    DT8 3NN Beaminster
    Dorset
    Director
    Higher Langdon
    DT8 3NN Beaminster
    Dorset
    British34988570004
    MACKENZIE GREEN, John Garvie
    Cheesedown Farm
    Steventon
    RG25 3AY Basingstoke
    Hampshire
    Director
    Cheesedown Farm
    Steventon
    RG25 3AY Basingstoke
    Hampshire
    British34988570001
    MCCARTHY, Paul Frank
    Tor House Station Road
    Woldingham
    CR3 7DA Caterham
    Surrey
    Director
    Tor House Station Road
    Woldingham
    CR3 7DA Caterham
    Surrey
    British65173730001
    MONEY, Anthony John
    Bevingdon House
    Belchamp Otten
    CO10 7BE Sudbury
    Suffolk
    Director
    Bevingdon House
    Belchamp Otten
    CO10 7BE Sudbury
    Suffolk
    EnglandBritish8785440001
    MUGGE, Mark Stephen
    25 Walbrook
    EC4N 8AW London
    The Walbrook Building
    United Kingdom
    Director
    25 Walbrook
    EC4N 8AW London
    The Walbrook Building
    United Kingdom
    EnglandAmerican162920630001
    NEWBERY, Trevor Philip
    Mount Lodge
    37 Thorpe Esplanade
    SS1 3BA Southend On Sea
    Essex
    Director
    Mount Lodge
    37 Thorpe Esplanade
    SS1 3BA Southend On Sea
    Essex
    British66912140001
    NEWBERY, Trevor Philip
    Mount Lodge
    37 Thorpe Esplanade
    SS1 3BA Southend On Sea
    Essex
    Director
    Mount Lodge
    37 Thorpe Esplanade
    SS1 3BA Southend On Sea
    Essex
    British66912140001
    NICHOLS, David William
    Fairacre Ravensdale Road
    South Ascot
    SL5 9HJ Ascot
    Berkshire
    Director
    Fairacre Ravensdale Road
    South Ascot
    SL5 9HJ Ascot
    Berkshire
    British6384890001
    PRESLAND, Peter Eric
    Rats Castle
    Castletons Oak Cranbrook Road
    TN27 8DY Biddenden Ashford
    Kent
    Director
    Rats Castle
    Castletons Oak Cranbrook Road
    TN27 8DY Biddenden Ashford
    Kent
    EnglandBritish7649630002
    PROCTOR, Jonathan Paul
    6 Herondale Avenue
    Wandsworth Common
    SW18 3JL London
    Director
    6 Herondale Avenue
    Wandsworth Common
    SW18 3JL London
    British8638320001

    ¿Quiénes son las personas con control significativo de HEATH INSURANCE BROKING LIMITED?

    Personas con control significativo
    NombreNotificado elDirecciónCesado
    Friary Intermediate Limited
    25 Walbrook
    EC4N 8AW London
    The Walbrook Building
    England
    06 abr 2016
    25 Walbrook
    EC4N 8AW London
    The Walbrook Building
    England
    No
    Forma jurídicaLimited Company
    País de registroEngland
    Autoridad legalCompanies Act 2006
    Lugar de registroEngland And Wales
    Número de registro4404202
    Naturaleza del control
    • La persona posee, directa o indirectamente, más del 75% de las acciones de la compañía.

    ¿Tiene HEATH INSURANCE BROKING LIMITED alguna carga?

    Gravámenes
    ClasificaciónFechasEstadoDetalles
    Guarantee & debenture
    Creado el 29 feb 2000
    Entregado el 09 mar 2000
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to any of the secured parties (as defined) pursuant to all or any of the secured documents (as defined), including the debenture
    Breve descripción
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • National Westminster Bank PLC
    Transacciones
    • 09 mar 2000Registro de un cargo (395)
    • 09 ene 2004Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Deed of variation made in addition to and modifying the security and trust deed dated 1 september 1989 ("the principal deed") as modified by a deed of variation dated 1 november 1993 (the "first deed of variation"),
    Creado el 23 sept 1999
    Entregado el 01 oct 1999
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of a charge
    Breve descripción
    All monies (including brokerage) for the time being standing to the credit of or pursuant to lloyds brokers byelaw (no. 5 of 1988) (see form 395 for full details).
    Personas con derecho
    • Lloyd's
    Transacciones
    • 01 oct 1999Registro de un cargo (395)
    • 13 jul 2000Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Third guarantee and debenture
    Creado el 31 dic 1997
    Entregado el 14 ene 1998
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee under or pursuant to the senior finance documents and the debenture as defined therein
    Breve descripción
    .. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • The Governor and Company of the Bank of Scotlandas Trustee for the Beneficiaries
    Transacciones
    • 14 ene 1998Registro de un cargo (395)
    • 05 may 2000Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Second guarantee and debenture
    Creado el 03 dic 1997
    Entregado el 22 dic 1997
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee under or pursuant to the senior finance documents and the debenture as defined therein
    Breve descripción
    .. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • The Governor and Company of the Bank of Scotlandas Security Trustee for the Beneficiaries
    Transacciones
    • 22 dic 1997Registro de un cargo (395)
    • 05 may 2000Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Deed of variation
    Creado el 01 nov 1993
    Entregado el 10 nov 1993
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the security and trust deed dated 01/09/89
    Breve descripción
    All monies standing to the credit of an insurance broking account. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • Lloyds
    Transacciones
    • 10 nov 1993Registro de un cargo (395)
    • 13 jul 2000Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Deposit agreement
    Creado el 07 nov 1991
    Entregado el 12 nov 1991
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the deposit agreement
    Breve descripción
    The balances for the time being standing to the credit of any accounts with the bank see form 395 for details.
    Personas con derecho
    • Citibank N.A.
    Transacciones
    • 12 nov 1991Registro de un cargo (395)
    • 07 nov 2007Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Trust deed
    Creado el 01 sept 1989
    Entregado el 14 sept 1989
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the charge
    Breve descripción
    See schedule attached to form 395 for full details.
    Personas con derecho
    • Lloyd's as Trustee
    Transacciones
    • 14 sept 1989Registro de una carga
    • 13 jul 2000Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Deposit charge
    Creado el 08 nov 1988
    Entregado el 23 nov 1988
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    All right title & interest of the company in & all sums from time to time standing to the credit of each l/c deposit account in the name of the company opened with the bank.
    Personas con derecho
    • Barclays Bank PLC
    Transacciones
    • 23 nov 1988Registro de una carga
    • 01 dic 2007Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Charge document
    Creado el 16 abr 1986
    Entregado el 25 abr 1986
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the charge
    Breve descripción
    A) all sums of money which may now or hereafter be held by or for the account of the bank in the name or the company at the main office of the bank in london together with all interest accruing from time to time thereon. B) all shares stocks, bonds debentures certificates of deposit or other securities (see doc M21 for details).
    Personas con derecho
    • The Chase Manhattan Bank N.A.
    Transacciones
    • 25 abr 1986Registro de una carga
    • 11 jul 1997Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Trust deed
    Creado el 21 feb 1983
    Entregado el 23 feb 1983
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the charge.
    Breve descripción
    All the company's right title and interest in the monies standing to the credit of the company's "c" account and monies and investments standing to the credit in other iba accounts of the company. (See doc M.20).
    Personas con derecho
    • The Corporation of Lloyd's
    Transacciones
    • 23 feb 1983Registro de una carga
    • 09 oct 1993Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)

    Fuente de datos

    • Companies House del Reino Unido
      El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros.
    • Licencia: CC0