DAWSON-KEITH LIMITED

  • Visión general
  • Resumen
  • Propósito
  • Dirección
  • Cuentas
  • Presentaciones
  • Directivos
  • Gravámenes
  • Insolvencia
  • Fuente de datos
  • Visión general

    Nombre de la empresaDAWSON-KEITH LIMITED
    Estado de la empresaDisuelta
    Forma jurídicaSociedad de responsabilidad limitada
    Número de empresa 01013692
    JurisdicciónInglaterra/Gales
    Fecha de constitución
    Fecha de cese

    Resumen

    Tiene PSCs súper segurosNo
    Tiene gravámenes
    Tiene historial de insolvencia
    La sede social está en disputaNo

    ¿Cuál es el propósito de DAWSON-KEITH LIMITED?

    • Compañía no comercial (74990) / Actividades profesionales, científicas y técnicas

    ¿Dónde se encuentra DAWSON-KEITH LIMITED?

    Dirección de la sede social
    Clive House
    12-18 Queens Road
    KT13 9XB Weybridge
    Surrey
    Dirección de la sede social no entregableNo

    ¿Cuáles son las últimas cuentas de DAWSON-KEITH LIMITED?

    Últimas cuentas
    Últimas cuentas cerradas hasta31 dic 2010

    ¿Cuáles son las últimas presentaciones para DAWSON-KEITH LIMITED?

    Presentaciones
    FechaDescripciónDocumentoTipo

    Gaceta final disuelta tras la liquidación

    1 páginasGAZ2

    Devolución de la reunión final en una liquidación voluntaria de miembros

    5 páginas4.71

    Resoluciones

    Resolutions
    1 páginasRESOLUTIONS
    Acuerdos
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    liquidation

    Acuerdo especial para la liquidación el 25 sept 2012

    LRESSP

    Nombramiento de un liquidador voluntario

    1 páginas600

    Declaración de solvencia

    3 páginas4.70

    Nombramiento de Sameet Vohra como director el 29 may 2012

    3 páginasAP01

    Cese del nombramiento de Shatish Damodar Dasani como director el 29 may 2012

    1 páginasTM01

    Déclaration annuelle établie au 18 feb 2012 avec liste complète des actionnaires

    4 páginasAR01
    Presentaciones asociadas
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    capital09 mar 2012

    Estado de capital el 09 mar 2012

    • Capital: GBP 2,094,250
    SH01

    Cambio de datos del director Mr Shatish Damodar Dasani el 20 feb 2012

    2 páginasCH01

    Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 31 dic 2010

    1 páginasAA

    Déclaration annuelle établie au 18 feb 2011 avec liste complète des actionnaires

    4 páginasAR01

    Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 31 dic 2009

    1 páginasAA

    Cambio de datos del director Paul Felbeck el 18 may 2010

    2 páginasCH01

    Déclaration annuelle établie au 18 feb 2010 avec liste complète des actionnaires

    5 páginasAR01

    Cambio de datos del director Shatish Dasani el 01 oct 2009

    2 páginasCH01

    Cambio de datos del secretario Wendy Jill Sharp el 01 oct 2009

    1 páginasCH03

    Cambio de datos del director Wendy Jill Sharp el 01 oct 2009

    2 páginasCH01

    Cambio de datos del director Paul Felbeck el 01 oct 2009

    2 páginasCH01

    Cuentas preparadas hasta el 31 dic 2008

    1 páginasAA

    legacy

    4 páginas363a

    legacy

    3 páginas288a

    legacy

    1 páginas288b

    Cuentas preparadas hasta el 31 dic 2007

    1 páginasAA

    legacy

    4 páginas363a

    Cuentas preparadas hasta el 31 dic 2006

    1 páginasAA

    ¿Quiénes son los directivos de DAWSON-KEITH LIMITED?

    Directivos
    NombreNombrado elRenunció elRolDirecciónIdentificación de la empresaPaís de residenciaNacionalidadFecha de nacimientoOcupaciónNúmero
    SHARP, Wendy Jill
    Clive House
    12-18 Queens Road
    KT13 9XB Weybridge
    Surrey
    Secretario
    Clive House
    12-18 Queens Road
    KT13 9XB Weybridge
    Surrey
    BritishCompany Secretary117318960001
    FELBECK, Paul
    Clive House
    12-18 Queens Road
    KT13 9XB Weybridge
    Surrey
    Director
    Clive House
    12-18 Queens Road
    KT13 9XB Weybridge
    Surrey
    United KingdomBritishSolicitor69837530002
    SHARP, Wendy Jill
    Clive House
    12-18 Queens Road
    KT13 9XB Weybridge
    Surrey
    Director
    Clive House
    12-18 Queens Road
    KT13 9XB Weybridge
    Surrey
    United KingdomBritishCompany Secretary117318960001
    VOHRA, Sameet
    12-18 Queens Road
    KT13 9XB Weybridge
    Clive House
    Surrey
    United Kingdom
    Director
    12-18 Queens Road
    KT13 9XB Weybridge
    Clive House
    Surrey
    United Kingdom
    EnglandBritishCompany Director126382440002
    CORKE, Philip John
    18 The Croft
    ME19 5QD Leybourne
    Kent
    Secretario
    18 The Croft
    ME19 5QD Leybourne
    Kent
    BritishAccountant52154630001
    GOLDING, Siegfried Raglan Mortimer
    8 Golf Links Avenue
    GU26 6PQ Hindhead
    Surrey
    Secretario
    8 Golf Links Avenue
    GU26 6PQ Hindhead
    Surrey
    British66662090001
    HAMER, David John
    Laurel Cottage
    Botley Road, Shedfield
    SO32 2JG Southampton
    Hampshire
    Secretario
    Laurel Cottage
    Botley Road, Shedfield
    SO32 2JG Southampton
    Hampshire
    British27523730001
    LEIGH, Martin Graham
    Cheriton 18 Paddock Way
    Woodham
    GU21 5TB Woking
    Surrey
    Secretario
    Cheriton 18 Paddock Way
    Woodham
    GU21 5TB Woking
    Surrey
    British2930710001
    ASHTON, Neil Andrew
    69 Devoke Close
    Stukeley Meadows
    PE29 6XE Huntingdon
    Cambridgeshire
    Director
    69 Devoke Close
    Stukeley Meadows
    PE29 6XE Huntingdon
    Cambridgeshire
    BritishFinance Director69229290001
    BARRY, Michael James
    The Pightle
    Scotland Corner Bucklebury
    RG7 6QD Reading
    Berkshire
    Director
    The Pightle
    Scotland Corner Bucklebury
    RG7 6QD Reading
    Berkshire
    United KingdomBritishCompany Director96184620001
    BROWN, Philip Gordon
    8 Homefield Road
    BN11 2HZ Worthing
    West Sussex
    Director
    8 Homefield Road
    BN11 2HZ Worthing
    West Sussex
    EnglandBritishManager39885680002
    CLARKSON, Jeremy David
    17 Oak Ridge
    LS22 6GT Wetherby
    West Yorkshire
    Director
    17 Oak Ridge
    LS22 6GT Wetherby
    West Yorkshire
    United KingdomBritishDirector29690770001
    COMONTE, Sheridan Willoughby Austell
    Flat 1 27 Lingfield Road
    SW19 4PU London
    Director
    Flat 1 27 Lingfield Road
    SW19 4PU London
    United KingdomBritishChief Executive126199650001
    CORKE, Philip John
    18 The Croft
    ME19 5QD Leybourne
    Kent
    Director
    18 The Croft
    ME19 5QD Leybourne
    Kent
    BritishAccountant52154630001
    DASANI, Shatish Damodar
    Clive House
    12-18 Queens Road
    KT13 9XB Weybridge
    Surrey
    Director
    Clive House
    12-18 Queens Road
    KT13 9XB Weybridge
    Surrey
    EnglandBritish132555670003
    FOWLER, Donald Magnus Charles
    Relwof Broad Road
    Hambrook
    PO18 8RG Chichester
    West Sussex
    Director
    Relwof Broad Road
    Hambrook
    PO18 8RG Chichester
    West Sussex
    BritishCompany Director37540810001
    FOX, Andrew Patrick
    4 Silcotes Court
    WF2 0UJ Wakefield
    West Yorkshire
    Director
    4 Silcotes Court
    WF2 0UJ Wakefield
    West Yorkshire
    BritishChartered Engineer75833000001
    GANDY, Robert Edward
    27 Selsmore Avenue
    PO11 9PB Hayling Island
    Hampshire
    Director
    27 Selsmore Avenue
    PO11 9PB Hayling Island
    Hampshire
    BritishCompany Director3758160001
    GOLDING, Siegfried Raglan Mortimer
    8 Golf Links Avenue
    GU26 6PQ Hindhead
    Surrey
    Director
    8 Golf Links Avenue
    GU26 6PQ Hindhead
    Surrey
    BritishCompany Director66662090001
    HAMER, David John
    Laurel Cottage
    Botley Road, Shedfield
    SO32 2JG Southampton
    Hampshire
    Director
    Laurel Cottage
    Botley Road, Shedfield
    SO32 2JG Southampton
    Hampshire
    EnglandBritishChartered Accountant27523730001
    HILL, Mark
    12 Blue Timbers Close
    GU35 0XL Bordon
    Hampshire
    Director
    12 Blue Timbers Close
    GU35 0XL Bordon
    Hampshire
    BritishCompany Director14479130001
    JOHNSON, Andrew Bainbridge
    The Old Rectory
    15 High Street
    LE15 9DN Morcott
    Leicestershire
    Director
    The Old Rectory
    15 High Street
    LE15 9DN Morcott
    Leicestershire
    United KingdomBritishDivisional Chief Executive97381620001
    LEIGH, Martin Graham
    Cheriton 18 Paddock Way
    Woodham
    GU21 5TB Woking
    Surrey
    Director
    Cheriton 18 Paddock Way
    Woodham
    GU21 5TB Woking
    Surrey
    BritishCompany Secretary2930710001
    MARSHALL, Peter Grahame
    49 Woodbury Avenue
    GU32 2ED Petersfield
    Hampshire
    Director
    49 Woodbury Avenue
    GU32 2ED Petersfield
    Hampshire
    United KingdomBritishManaging Director37718920001
    NUTTON, Richard Paul
    The Old Station House
    Thorpe Hall
    YO62 4DL Ampleforth
    York
    Director
    The Old Station House
    Thorpe Hall
    YO62 4DL Ampleforth
    York
    BritishManaging Director66704050001
    SCAHILL, David Nicholas
    Willow Tree Cottage
    Slade Lane, Ash
    GU12 6DY Aldershot
    Hampshire
    Director
    Willow Tree Cottage
    Slade Lane, Ash
    GU12 6DY Aldershot
    Hampshire
    BritishDivisional Chief Executive66661720001
    SCHOFIELD, Philip
    25 The Ridings
    KT11 2PU Cobham
    Surrey
    Director
    25 The Ridings
    KT11 2PU Cobham
    Surrey
    United KingdomUkManaging Director54460880001
    STRATTON-BROWN, Henry
    Westholme
    Pickering Road West Snainton
    YO13 9PL Scarborough
    North Yorkshire
    Director
    Westholme
    Pickering Road West Snainton
    YO13 9PL Scarborough
    North Yorkshire
    BritishFinance Director48696990002
    WEAVER, Roderick William
    23 Llandennis Avenue
    Cyncoed
    CF23 6JE Cardiff
    Director
    23 Llandennis Avenue
    Cyncoed
    CF23 6JE Cardiff
    BritishGroup Finance Director68136730001

    ¿Tiene DAWSON-KEITH LIMITED alguna carga?

    Gravámenes
    ClasificaciónFechasEstadoDetalles
    Legal charge
    Creado el 14 mar 1989
    Entregado el 23 mar 1989
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    F/H property k/a unit 3,4 and 5 brockhampton lane havant in hampshire together with all movable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Personas con derecho
    • Royal Bank of Scotland
    Transacciones
    • 23 mar 1989Registro de una carga
    • 04 mar 2005Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Letter of set-off
    Creado el 13 ene 1988
    Entregado el 21 ene 1988
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company and/or hirst & mallinson limited and/or associated british catering equipment distributors limited and/or associated british engineering PLC and/or british polar engines limited and/or peter nisbert & company limited and/or peter nisbet (midlands) limited to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    All sums standing or that may stand to the credit of any of the current accounts in the name of the company in the books of the bank. (Please see doc. For details).
    Personas con derecho
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transacciones
    • 21 ene 1988Registro de una carga
    • 27 ene 1992Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Single debenture
    Creado el 17 jul 1987
    Entregado el 18 jul 1987
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    Fixed and floating charge undertaking and all property and assets present and future including bookdebts & goodwill uncalled capital.
    Personas con derecho
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transacciones
    • 18 jul 1987Registro de una carga
    • 04 mar 2005Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Letter of set-off
    Creado el 05 sept 1986
    Entregado el 23 sept 1986
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    All sums standing to the of any of the current accounts of the company with the bank.
    Personas con derecho
    • The Royal Bank of Scotland PLC.
    Transacciones
    • 23 sept 1986Registro de una carga
    • 27 ene 1992Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Letter of set off
    Creado el 10 jun 1986
    Entregado el 24 jun 1986
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company and/or associated british engineering PLC to the chargee.
    Breve descripción
    All sum standing to the credit of any of the current accounts in name of any of associated british engineering PLC, british polar engines limited & the company in the book of the bank.
    Personas con derecho
    • The Royal Bank of Scotland PLC.
    Transacciones
    • 24 jun 1986Registro de una carga
    Charge
    Creado el 07 jun 1985
    Entregado el 19 jun 1985
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    Monies due to the company by the secretary of state acting by the export credits guarantee department under the comprehensive short term guarantee numbered cstp/345946/0675. And supplemental (extended terms) guarantee numbered:- cxtp/345946/0675. (See doc M91 for full details).
    Personas con derecho
    • Royal Bank of Scotland PLC.
    Transacciones
    • 19 jun 1985Registro de una carga
    Letter of set off.
    Creado el 27 jun 1983
    Entregado el 15 jul 1983
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company and/or all/or any of the other companies named therein to the chargee.
    Breve descripción
    All sums standing to the credit of any current account of the company.
    Personas con derecho
    • The Royal Bank of Scotland PLC.
    Transacciones
    • 15 jul 1983Registro de una carga
    Mortgage
    Creado el 22 jun 1983
    Entregado el 28 jun 1983
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    Units 3,4, 5 & 6. brockhampton lane, industrial estate, havant, hampshire.
    Personas con derecho
    • The Royal Bank of Scotland PLC.
    Transacciones
    • 28 jun 1983Registro de una carga
    • 04 mar 2005Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Mortgage debenture
    Creado el 22 jun 1983
    Entregado el 28 jun 1983
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    Floating charge over the undertaking and all property and assets present and future and fixed charge over all bookdebts, other debts, goodwill uncalled capital.
    Personas con derecho
    • The Royal Bank of Scotland PLC.
    Transacciones
    • 28 jun 1983Registro de una carga
    • 04 mar 2005Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)

    ¿Tiene DAWSON-KEITH LIMITED algún caso de insolvencia?

    Número de expedienteFechasTipoProfesionalesOtro
    1
    FechaTipo
    09 oct 2013Fecha de disolución
    25 sept 2012Inicio de la liquidación
    Liquidación voluntaria de socios
    NombreRolDirecciónNombrado elCesado el
    Timothy Gerard Walsh
    7 More London Riverside
    SE1 2RT London
    Profesional
    7 More London Riverside
    SE1 2RT London
    Peter James Greaves
    7 More London Riverside
    SE1 2RT London
    Profesional
    7 More London Riverside
    SE1 2RT London

    Fuente de datos

    • Companies House del Reino Unido
      El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros.
    • Licencia: CC0