GLENCROFT COURT MANAGEMENT LIMITED
Visión general
Nombre de la empresa | GLENCROFT COURT MANAGEMENT LIMITED |
---|---|
Estado de la empresa | Activa |
Forma jurídica | Sociedad de responsabilidad limitada |
Número de empresa | 01013847 |
Jurisdicción | Inglaterra/Gales |
Fecha de constitución |
Resumen
Tiene PSCs súper seguros | No |
---|---|
Tiene gravámenes | No |
Tiene historial de insolvencia | No |
La sede social está en disputa | No |
¿Cuál es el propósito de GLENCROFT COURT MANAGEMENT LIMITED?
- Otro alquiler y explotación de bienes inmobiliarios propios o arrendados (68209) / Actividades inmobiliarias
¿Dónde se encuentra GLENCROFT COURT MANAGEMENT LIMITED?
Dirección de la sede social | Ground Floor 58 Castle Walk RH2 9PX Reigate England |
---|---|
Dirección de la sede social no entregable | No |
¿Cuáles son las últimas cuentas de GLENCROFT COURT MANAGEMENT LIMITED?
Vencido | No |
---|---|
Próximas cuentas | |
Próximo período contable finaliza el | 30 jun 2025 |
Próximas cuentas vencen el | 31 mar 2026 |
Últimas cuentas | |
Últimas cuentas cerradas hasta | 30 jun 2024 |
¿Cuál es el estado de la última declaración de confirmación para GLENCROFT COURT MANAGEMENT LIMITED?
Última declaración de confirmación cerrada hasta | 20 nov 2025 |
---|---|
Próxima declaración de confirmación vence | 04 dic 2025 |
Última declaración de confirmación | |
Próxima declaración de confirmación cerrada hasta | 20 nov 2024 |
Vencido | No |
¿Cuáles son las últimas presentaciones para GLENCROFT COURT MANAGEMENT LIMITED?
Fecha | Descripción | Documento | Tipo | |
---|---|---|---|---|
Cuentas para una empresa pequeña preparadas hasta el 30 jun 2024 | 7 páginas | AA | ||
Declaración de confirmación presentada el 20 nov 2024 con actualizaciones | 8 páginas | CS01 | ||
Cese del nombramiento de Samuel Thomas Walsh como secretario el 03 mar 2024 | 1 páginas | TM02 | ||
Nombramiento de St Walsh Llp como secretario el 03 mar 2024 | 2 páginas | AP04 | ||
Cuentas para una empresa pequeña preparadas hasta el 30 jun 2023 | 7 páginas | AA | ||
Declaración de confirmación presentada el 20 nov 2023 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||
Cuentas para una empresa pequeña preparadas hasta el 30 jun 2022 | 7 páginas | AA | ||
Cese del nombramiento de Colin Stirling Jobson como director el 01 nov 2022 | 1 páginas | TM01 | ||
Declaración de confirmación presentada el 20 nov 2022 con actualizaciones | 7 páginas | CS01 | ||
Domicilio social registrado cambiado de Melrose 11a Longcroft Avenue Banstead Surrey SM7 3AE a Ground Floor 58 Castle Walk Reigate RH2 9PX el 21 jun 2022 | 1 páginas | AD01 | ||
Declaración de confirmación presentada el 20 nov 2021 con actualizaciones | 7 páginas | CS01 | ||
Cuentas para una empresa pequeña preparadas hasta el 30 jun 2021 | 6 páginas | AA | ||
Cuentas para una empresa pequeña preparadas hasta el 30 jun 2020 | 7 páginas | AA | ||
Declaración de confirmación presentada el 20 nov 2020 con actualizaciones | 7 páginas | CS01 | ||
Cuentas para una empresa pequeña preparadas hasta el 30 jun 2019 | 6 páginas | AA | ||
Declaración de confirmación presentada el 20 nov 2019 con actualizaciones | 7 páginas | CS01 | ||
Declaración de confirmación presentada el 20 nov 2018 con actualizaciones | 7 páginas | CS01 | ||
Cuentas para una empresa pequeña preparadas hasta el 30 jun 2018 | 6 páginas | AA | ||
Cuentas para una empresa pequeña preparadas hasta el 30 jun 2017 | 6 páginas | AA | ||
Declaración de confirmación presentada el 20 nov 2017 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||
Notification de Colin Jobson en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 11 ago 2017 | 2 páginas | PSC01 | ||
Notification de Simon Gibbs en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 11 ago 2017 | 2 páginas | PSC01 | ||
Notification de Ian Bosley en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 11 ago 2017 | 2 páginas | PSC01 | ||
Nombramiento de Mr Ian Bosley como director el 11 ago 2017 | 2 páginas | AP01 | ||
Nombramiento de Mr Simon Gibbs como director el 11 ago 2017 | 2 páginas | AP01 | ||
¿Quiénes son los directivos de GLENCROFT COURT MANAGEMENT LIMITED?
Nombre | Nombrado el | Renunció el | Rol | Dirección | Identificación de la empresa | País de residencia | Nacionalidad | Fecha de nacimiento | Ocupación | Número | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ST WALSH LLP | Secretario corporativo | Castle Walk RH2 9PX Reigate Ground Floor 58 England |
| 321327630001 | ||||||||||
BOSLEY, Ian | Director | 58 Castle Walk RH2 9PX Reigate Ground Floor England | England | British | Surveying Director | 236709240001 | ||||||||
GIBBS, Simon | Director | 58 Castle Walk RH2 9PX Reigate Ground Floor England | England | British | Commercial Manager | 236709040001 | ||||||||
LUNN, Deborah | Director | 5 Glencroft Court 11 Sherwood Park Road SM1 2SL Sutton Surrey | England | British | Manager | 124182690001 | ||||||||
MITCHELL, Bruce Robin | Director | Glencroft Court 11 Sherwood Park Road SM1 2SL Sutton 8 Surrey England | England | British | Driver/Trainer | 101886790001 | ||||||||
TROTTER, Vivienne Margaret | Director | 2 Glencroft Court Sherwood Park Road SM1 2SL Sutton Surrey | England | British | Legal Secretary | 71648270001 | ||||||||
BLACKMORE, Helen Patricia Ann | Secretario | 5 Sussex Road Carshalton Beeches SM5 3LT Carshalton Surrey | British | Property Manager | 1515110001 | |||||||||
HALE, Stephen Frederick | Secretario | 16 Lindsay Court SM1 2SN Sutton Surrey | British | 28586140001 | ||||||||||
MARCHANT, Paula | Secretario | 14 Glencroft Court Sherwood Park Road SM1 2SL Sutton Surrey | British | Bank Official | 55923460001 | |||||||||
OLIVER, Ian | Secretario | 3 Glencroft Court Sherwood Park Road SM1 2SL Sutton Surrey | British | 63819380002 | ||||||||||
WALSH, Samuel Thomas | Secretario | 11a Longcroft Avenue SM7 3AE Banstead Melrose Surrey | British | 137599900001 | ||||||||||
J J HOMES (PROPERTIES) LIMITED | Secretario corporativo | 146 Stanley Park Road SM5 3JG Carshalton Surrey | 130953830001 | |||||||||||
BLASHFIELD, Ray Robertson | Director | Flat 6 Lindsay Court Sherwood Park Road SM1 2SN Sutton Surrey | British | Director | 36545380001 | |||||||||
CADDY, Louise Susan | Director | 13 Lindsay Court 15 Sherwood Park Road SM1 2SN Sutton Surrey | British | Police Officer | 113114610001 | |||||||||
CLARKE, Nicola | Director | 13 Lindsay Court SM1 2SN Sutton Surrey | British | Nursery Officer | 31438100001 | |||||||||
DRURY, Alex Paul | Director | St. James Avenue SM1 2TQ Sutton 29 Surrey United Kingdom | United Kingdom | British | Security | 80680680002 | ||||||||
FREEMAN, Bryan | Director | 6 Glencroft Court Sherwood Park Road SM1 2SL Sutton Surrey | British | Consultant | 38640160001 | |||||||||
GOLDEN, Bridget Jane | Director | Flat 24 Lindsay Court Sherwood Park Road SM1 2SN Sutton Surrey | British | Retired | 36545290001 | |||||||||
GOREHAM, Colin | Director | Flat 11 Glencroft Court Sherwood Park Road SM1 2SL Sutton Surrey | British | Shop Manager | 36700630001 | |||||||||
HAMERTON, Sarah | Director | Lindsay Court 15 Sherwood Park Road SM1 2SN Sutton 30 Surrey England | England | British | Administrator | 179058460001 | ||||||||
INCE, Timothy | Director | 11a Longcroft Avenue SM7 3AE Banstead Melrose Surrey | United Kingdom | British | Engineer | 55944160001 | ||||||||
INCE, Timothy | Director | 9 Glencroft Court Sherwood Park Road SM1 2SL Sutton Surrey | United Kingdom | British | Company Director | 55944160001 | ||||||||
JOBSON, Colin Stirling | Director | 58 Castle Walk RH2 9PX Reigate Ground Floor England | England | British | Financial Adviser | 66738780001 | ||||||||
MARCHANT, Paula | Director | 14 Glencroft Court Sherwood Park Road SM1 2SL Sutton Surrey | British | Bank Official | 55923460001 | |||||||||
MCCAUL, Kate | Director | Lindsay Court 15 Sherwood Park Road SM1 2SN Sutton 25 Surrey Great Britain | United Kingdom | British | Web Editor | 147053190002 | ||||||||
MILES, Paul | Director | 13 Lindsay Court SM1 2SN Sutton Surrey | English | Electrical Installation Engineer | 31438110001 | |||||||||
OLIVER, Ian | Director | 3 Glencroft Court Sherwood Park Road SM1 2SL Sutton Surrey | British | Stamp Dealer | 63819380002 | |||||||||
ORPIN, David | Director | 31 Lindsay Court 15 Sherwood Park Road SM1 2SN Sutton Surrey | British | Teacher | 98458270001 | |||||||||
SHERRINGTON, Peter Thomas | Director | 13 Glencroft Court Sherwood Park Road SM1 2SL Sutton Surrey | British | Retired | 41256660002 | |||||||||
SHERRINGTON, Peter Thomas | Director | 13 Glencroft Court Sherwood Park Road SM1 2SL Sutton Surrey | British | Fireman | 41256660002 | |||||||||
SHERRINGTON, Peter Thomas | Director | 13 Glencroft Court Sherwood Park Road SM1 2SL Sutton Surrey | British | Fireman | 41256660002 | |||||||||
SWANN, Shirley Ann Maureen | Director | Yew Tree Bottom Road KT17 3NH Epsom 16 Surrey | United Kingdom | British | Retired | 132251740001 | ||||||||
TROTTER, Vivienne Margaret | Director | 2 Glencroft Court Sherwood Park Road SM1 2SL Sutton Surrey | England | British | Legal Secretary | 71648270001 | ||||||||
TUNSEI, Katie Geraldine | Director | 11a Longcroft Avenue SM7 3AE Banstead Melrose Surrey | United Kingdom | British | Tutor | 123910470002 | ||||||||
WAND, Donald Frank | Director | 18 Lindsay Court SM1 2SN Sutton Surrey | British | Engineer | 28586170001 |
¿Quiénes son las personas con control significativo de GLENCROFT COURT MANAGEMENT LIMITED?
Nombre | Notificado el | Dirección | Cesado |
---|---|---|---|
Mr Ian Bosley | 11 ago 2017 | 58 Castle Walk RH2 9PX Reigate Ground Floor England | No |
Nacionalidad: British País de residencia: England | |||
Naturaleza del control
| |||
Mr Colin Stirling Jobson | 11 ago 2017 | 58 Castle Walk RH2 9PX Reigate Ground Floor England | No |
Nacionalidad: British País de residencia: England | |||
Naturaleza del control
| |||
Mr Simon Gibbs | 11 ago 2017 | 58 Castle Walk RH2 9PX Reigate Ground Floor England | No |
Nacionalidad: British País de residencia: England | |||
Naturaleza del control
| |||
Miss Sarah Hamerton | 01 jul 2016 | 11a Longcroft Avenue SM7 3AE Banstead Melrose Surrey | Sí |
Nacionalidad: British País de residencia: England | |||
Naturaleza del control
| |||
Ms Vivienne Margaret Trotter | 01 jul 2016 | 58 Castle Walk RH2 9PX Reigate Ground Floor England | No |
Nacionalidad: British País de residencia: England | |||
Naturaleza del control
| |||
Ms Deborah Lunn | 01 jul 2016 | 58 Castle Walk RH2 9PX Reigate Ground Floor England | No |
Nacionalidad: British País de residencia: England | |||
Naturaleza del control
| |||
Mr Bruce Robin Mitchell | 01 jul 2016 | 58 Castle Walk RH2 9PX Reigate Ground Floor England | No |
Nacionalidad: British País de residencia: England | |||
Naturaleza del control
|
Fuente de datos
- Companies House del Reino Unido
El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros. - Licencia: CC0