AGBL OPCO REALISATIONS LIMITED
Visión general
| Nombre de la empresa | AGBL OPCO REALISATIONS LIMITED |
|---|---|
| Estado de la empresa | Disuelta |
| Forma jurídica | Sociedad de responsabilidad limitada |
| Número de empresa | 01016191 |
| Jurisdicción | Inglaterra/Gales |
| Fecha de constitución | |
| Fecha de cese |
Resumen
| Tiene PSCs súper seguros | No |
|---|---|
| Tiene gravámenes | Sí |
| Tiene historial de insolvencia | Sí |
| La sede social está en disputa | No |
¿Cuál es el propósito de AGBL OPCO REALISATIONS LIMITED?
- Venta al por menor de prendas de vestir en establecimientos especializados (47710) / Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos de motor y motocicletas
- Venta al por menor de calzado en establecimientos especializados (47721) / Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos de motor y motocicletas
¿Dónde se encuentra AGBL OPCO REALISATIONS LIMITED?
| Dirección de la sede social | C/O Teneo Finacial Advisory Limited 156 Great Charles Street Queensway Queensway B3 3HN Birmingham West Midlands |
|---|---|
| Dirección de la sede social no entregable | No |
¿Cuáles fueron los nombres anteriores de AGBL OPCO REALISATIONS LIMITED?
| Nombre de la empresa | Desde | Hasta |
|---|---|---|
| ARCADIA GROUP BRANDS LIMITED | 19 jun 1998 | 19 jun 1998 |
| GREENHAWK LIMITED | 17 sept 1997 | 17 sept 1997 |
| DORSUB (TMR) LIMITED | 19 may 1994 | 19 may 1994 |
| TOP MAN RETAIL LIMITED | 23 feb 1990 | 23 feb 1990 |
| TOP BOY LIMITED | 31 dic 1978 | 31 dic 1978 |
| HAND OF BURTON LIMITED | 30 jun 1971 | 30 jun 1971 |
¿Cuáles son las últimas cuentas de AGBL OPCO REALISATIONS LIMITED?
| Últimas cuentas | |
|---|---|
| Últimas cuentas cerradas hasta | 01 sept 2018 |
¿Cuáles son las últimas presentaciones para AGBL OPCO REALISATIONS LIMITED?
| Fecha | Descripción | Documento | Tipo | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gaceta final disuelta tras la liquidación | 1 páginas | GAZ2 | ||||||||||
Aviso de cambio de la administración a la disolución | 28 páginas | AM23 | ||||||||||
Domicilio social registrado cambiado de C/O Teneo Restructuring Limited 156 Great Charles Street Queensway Queensway Birmingham West Midlands B3 3HN a C/O Teneo Finacial Advisory Limited 156 Great Charles Street Queensway Queensway Birmingham West Midlands B3 3HN el 22 nov 2022 | 2 páginas | AD01 | ||||||||||
Informe de progreso del administrador | 33 páginas | AM10 | ||||||||||
Informe de progreso del administrador | 23 páginas | AM10 | ||||||||||
Certificado de cambio de nombre Company name changed arcadia group brands LIMITED\certificate issued on 07/12/21 | 2 páginas | CERTNM | ||||||||||
| ||||||||||||
Aviso de cambio de nombre | 2 páginas | CONNOT | ||||||||||
Aviso de extensión del período de la administración | 4 páginas | AM19 | ||||||||||
Domicilio social registrado cambiado de 156 Great Charles Street Queensway Birmingham West Midlands B3 3HN a C/O Teneo Restructuring Limited 156 Great Charles Street Queensway Queensway Birmingham West Midlands B3 3HN el 06 sept 2021 | 2 páginas | AD01 | ||||||||||
Informe de progreso del administrador | 26 páginas | AM10 | ||||||||||
Domicilio social registrado cambiado de C/O Deloitte Llp Four Brindley Place Birmingham B1 2HZ a 156 Great Charles Street Queensway Birmingham West Midlands B3 3HN el 28 jun 2021 | 2 páginas | AD01 | ||||||||||
Resultado de la reunión de acreedores | 44 páginas | AM07 | ||||||||||
Declaración de asuntos con el formulario AM02SOA/AM02SOC | 12 páginas | AM02 | ||||||||||
Declaración de la propuesta del administrador | 43 páginas | AM03 | ||||||||||
Domicilio social registrado cambiado de Colegrave House 70 Berners Street London W1T 3NL a C/O Deloitte Llp Four Brindley Place Birmingham B1 2HZ el 14 dic 2020 | 2 páginas | AD01 | ||||||||||
Nombramiento de un administrador | 4 páginas | AM01 | ||||||||||
Declaración de confirmación presentada el 01 jun 2020 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||||||||||
Cese del nombramiento de Paul Stephen Price como director el 13 dic 2019 | 1 páginas | TM01 | ||||||||||
Cese del nombramiento de Michelle Jane Gammon como secretario el 21 nov 2019 | 1 páginas | TM02 | ||||||||||
Cuentas completas preparadas hasta el 01 sept 2018 | 19 páginas | AA | ||||||||||
Declaración de confirmación presentada el 01 jun 2019 con actualizaciones | 5 páginas | CS01 | ||||||||||
Cese del nombramiento de Jonathan Sokoloff como director el 22 mar 2019 | 1 páginas | TM01 | ||||||||||
Cese del nombramiento de Adam Thomas Levyn como director el 22 mar 2019 | 1 páginas | TM01 | ||||||||||
Nombramiento de Mr Adam Thomas Levyn como director el 31 dic 2018 | 2 páginas | AP01 | ||||||||||
Cese del nombramiento de James Halper como director el 31 dic 2018 | 1 páginas | TM01 | ||||||||||
¿Quiénes son los directivos de AGBL OPCO REALISATIONS LIMITED?
| Nombre | Nombrado el | Renunció el | Rol | Dirección | Identificación de la empresa | País de residencia | Nacionalidad | Fecha de nacimiento | Ocupación | Número |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FOREY, Siobhan | Director | 70 Berners Street W1T 3NL London Colegrave House United Kingdom | United Kingdom | British | 111977210002 | |||||
| GRABINER, Ian Michael | Director | 70 Berners Street W1T 3NL London Colegrave House United Kingdom | Scotland | British | 63235540002 | |||||
| GREEN, Philip Nigel Ross, Sir | Director | 156 Great Charles Street Queensway Queensway B3 3HN Birmingham C/O Teneo Finacial Advisory Limited West Midlands | United Kingdom | British | 103945640001 | |||||
| BERGAMIN, Jayabaduri | Secretario | 12 Newry Road TW1 1PL Twickenham Middlesex | British | 116935080001 | ||||||
| CASH, Daphne Valerie | Secretario | 20 Chichester Mews SE27 0NS London | British | 59646330004 | ||||||
| COX, Michelle Hazel | Secretario | 154 Eastwood Road North SS9 4LZ Leigh On Sea Essex | British | 104461530003 | ||||||
| GAMMON, Michelle Jane | Secretario | 70 Berners Street W1T 3NL London Colegrave House United Kingdom | 221297650001 | |||||||
| GOLDMAN, Adam Alexander | Secretario | 70 Berners Street W1T 3NL London Colegrave House United Kingdom | British | 192403200001 | ||||||
| HICKS, Beverley | Secretario | 7 Westminster Court King & Queen Wharf Rotherhithe SE16 5SY London | British | 92357410001 | ||||||
| HODGES, John | Secretario | The Old Orchard Burney Road Westhumble RH5 6AU Dorking Surrey | British | 3666240001 | ||||||
| JACKMAN, Ian Peter | Secretario | Flat 11 Macready House 75 Crawford Street W1H 5LR London | British | 71660800001 | ||||||
| JACKMAN, Ian Peter | Secretario | Flat 11 Macready House 75 Crawford Street W1H 5LR London | British | 71660800001 | ||||||
| PREMI, Gurpal | Secretario | Colegrave House 70 Berners Street W1T 3NL London Arcadia Group Limited England | British | 180475620001 | ||||||
| RODIE, Kimberly Donna | Secretario | Falcon Grove SW11 2ST Clapham 26 London United Kingdom | 148647910001 | |||||||
| RODIE, Kimberly Donna | Secretario | Falcon Grove SW11 2ST Clapham 26 London United Kingdom | Other | 134585610002 | ||||||
| SMITH, Philip Clayton | Secretario | 24 Bishops Avenue Elstree WD6 3LZ Borehamwood Hertfordshire | British | 613980001 | ||||||
| STEVENSON, Rebecca Jayne | Secretario | 49 Rivulet Road Tottenham N17 7JT London | British | 71917770002 | ||||||
| WALDRON, Aisha Leah | Secretario | Bookerhill Road HP12 4HA High Wycombe 29 Buckinghamshire United Kingdom | 147374130001 | |||||||
| BATES, David John | Director | 11 The Laurels Potten End HP4 2SP Berkhamsted Hertfordshire | United Kingdom | British | 613990001 | |||||
| BROWN, David Nigel | Director | 116 Clarence Road AL1 4NW St Albans Hertfordshire | United Kingdom | British | 40354400003 | |||||
| BUDGE, Paul Everard | Director | Berners Street W1T 3NL London Colegrave House 68-70 United Kingdom | United Kingdom | British | 88851520002 | |||||
| BURCHILL, Richard Leeroy | Director | 70 Berners Street W1T 3NL London Colegrave House England | United Kingdom | British | 115568070002 | |||||
| CROSSLAND, Julie Sook Hein | Director | 9 Rowallan Road SW6 6AF London | England | British | 70464290002 | |||||
| DEDOMBAL, Richard | Director | Blackmoor Lane Bardsey LS17 9DY Leeds 46 United Kingdom | United Kingdom | British | 165695440001 | |||||
| DUCKELS, Colin Peter | Director | 14 Woodlands Park Scarcroft LS14 3JU Leeds West Yorkshire | United Kingdom | British | 44237310004 | |||||
| GERAGHTY, Mary Julia Margaret | Director | 70 Berners Street W1T 3NL London Colegrave House England | United Kingdom | British | 125285460003 | |||||
| GOLDMAN, Adam Alexander | Director | 4 Jenner Way Clarendon Park KT19 7LJ Epsom Surrey | England | British | 28466260004 | |||||
| HAGUE, Gillian Anne | Director | 70 Berners Street W1T 3NL London Colegrave House England | United Kingdom | British | 99223490001 | |||||
| HALPER, James | Director | 70 Berners Street W1T 3NL London Colegrave House | United States | American | 174851860001 | |||||
| HARRIS, Christopher Bryan | Director | 70 Berners Street W1T 3NL London Colegrave House United Kingdom | United Kingdom | British | 234603670001 | |||||
| HEALEY, Mark Anthony | Director | 70 Berners Street W1T 3NL London Colegrave House England | England | British | 77432550002 | |||||
| HIND, Andrew Clive | Director | 14 Princes Avenue Muswell Hill N10 3LR London | England | British | 113038870001 | |||||
| HODGES, John | Director | The Old Orchard Burney Road Westhumble RH5 6AU Dorking Surrey | British | 3666240001 | ||||||
| HOMER, Mary Elizabeth | Director | Colegrave House 70 Berners Street W1T 3NL London | United Kingdom | British | 175056190001 | |||||
| JACKMAN, Ian Peter | Director | Flat 11 Macready House 75 Crawford Street W1H 5LR London | British | 71660800001 |
¿Quiénes son las personas con control significativo de AGBL OPCO REALISATIONS LIMITED?
| Nombre | Notificado el | Dirección | Cesado | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Arcadia Group Limited | 06 abr 2016 | 70 Berners Street W1T 3NL London Colegrave House United Kingdom | No | ||||||||||
| |||||||||||||
Naturaleza del control
| |||||||||||||
¿Tiene AGBL OPCO REALISATIONS LIMITED alguna carga?
| Clasificación | Fechas | Estado | Detalles | |
|---|---|---|---|---|
| Debenture | Creado el 14 dic 2004 Entregado el 23 dic 2004 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All monies due or to become due from the charging companies to the chargee and/or the other security beneficiaries (or any of them) under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Breve descripción Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
| Deed of accession to a composite guarantee and debenture dated 10 september 2002 | Creado el 18 dic 2002 Entregado el 23 dic 2002 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All present and future obligations and liabilities of each charging company to the security trustee and the security beneficiaries (or any of them) under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Breve descripción Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
¿Tiene AGBL OPCO REALISATIONS LIMITED algún caso de insolvencia?
| Número de expediente | Fechas | Tipo | Profesionales | Otro | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
| En administración |
|
Fuente de datos
- Companies House del Reino Unido
El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros. - Licencia: CC0