AGBL OPCO REALISATIONS LIMITED

AGBL OPCO REALISATIONS LIMITED

  • Visión general
  • Resumen
  • Propósito
  • Dirección
  • Nombres anteriores
  • Cuentas
  • Presentaciones
  • Directivos
  • Personas con control significativo
  • Gravámenes
  • Insolvencia
  • Fuente de datos
  • Visión general

    Nombre de la empresaAGBL OPCO REALISATIONS LIMITED
    Estado de la empresaDisuelta
    Forma jurídicaSociedad de responsabilidad limitada
    Número de empresa 01016191
    JurisdicciónInglaterra/Gales
    Fecha de constitución
    Fecha de cese

    Resumen

    Tiene PSCs súper segurosNo
    Tiene gravámenes
    Tiene historial de insolvencia
    La sede social está en disputaNo

    ¿Cuál es el propósito de AGBL OPCO REALISATIONS LIMITED?

    • Venta al por menor de prendas de vestir en establecimientos especializados (47710) / Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos de motor y motocicletas
    • Venta al por menor de calzado en establecimientos especializados (47721) / Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos de motor y motocicletas

    ¿Dónde se encuentra AGBL OPCO REALISATIONS LIMITED?

    Dirección de la sede social
    C/O Teneo Finacial Advisory Limited 156 Great Charles Street Queensway
    Queensway
    B3 3HN Birmingham
    West Midlands
    Dirección de la sede social no entregableNo

    ¿Cuáles fueron los nombres anteriores de AGBL OPCO REALISATIONS LIMITED?

    Nombres anteriores de la empresa
    Nombre de la empresaDesdeHasta
    ARCADIA GROUP BRANDS LIMITED19 jun 199819 jun 1998
    GREENHAWK LIMITED17 sept 199717 sept 1997
    DORSUB (TMR) LIMITED19 may 199419 may 1994
    TOP MAN RETAIL LIMITED23 feb 199023 feb 1990
    TOP BOY LIMITED31 dic 197831 dic 1978
    HAND OF BURTON LIMITED30 jun 197130 jun 1971

    ¿Cuáles son las últimas cuentas de AGBL OPCO REALISATIONS LIMITED?

    Últimas cuentas
    Últimas cuentas cerradas hasta01 sept 2018

    ¿Cuáles son las últimas presentaciones para AGBL OPCO REALISATIONS LIMITED?

    Presentaciones
    FechaDescripciónDocumentoTipo

    Gaceta final disuelta tras la liquidación

    1 páginasGAZ2

    Aviso de cambio de la administración a la disolución

    28 páginasAM23

    Domicilio social registrado cambiado de C/O Teneo Restructuring Limited 156 Great Charles Street Queensway Queensway Birmingham West Midlands B3 3HN a C/O Teneo Finacial Advisory Limited 156 Great Charles Street Queensway Queensway Birmingham West Midlands B3 3HN el 22 nov 2022

    2 páginasAD01

    Informe de progreso del administrador

    33 páginasAM10

    Informe de progreso del administrador

    23 páginasAM10

    Certificado de cambio de nombre

    Company name changed arcadia group brands LIMITED\certificate issued on 07/12/21
    2 páginasCERTNM
    Acuerdos
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    change-of-name

    Resolución de cambio de nombre de la empresa el 02 dic 2021

    RES15

    Aviso de cambio de nombre

    2 páginasCONNOT

    Aviso de extensión del período de la administración

    4 páginasAM19

    Domicilio social registrado cambiado de 156 Great Charles Street Queensway Birmingham West Midlands B3 3HN a C/O Teneo Restructuring Limited 156 Great Charles Street Queensway Queensway Birmingham West Midlands B3 3HN el 06 sept 2021

    2 páginasAD01

    Informe de progreso del administrador

    26 páginasAM10

    Domicilio social registrado cambiado de C/O Deloitte Llp Four Brindley Place Birmingham B1 2HZ a 156 Great Charles Street Queensway Birmingham West Midlands B3 3HN el 28 jun 2021

    2 páginasAD01

    Resultado de la reunión de acreedores

    44 páginasAM07

    Declaración de asuntos con el formulario AM02SOA/AM02SOC

    12 páginasAM02

    Declaración de la propuesta del administrador

    43 páginasAM03

    Domicilio social registrado cambiado de Colegrave House 70 Berners Street London W1T 3NL a C/O Deloitte Llp Four Brindley Place Birmingham B1 2HZ el 14 dic 2020

    2 páginasAD01

    Nombramiento de un administrador

    4 páginasAM01

    Declaración de confirmación presentada el 01 jun 2020 sin actualizaciones

    3 páginasCS01

    Cese del nombramiento de Paul Stephen Price como director el 13 dic 2019

    1 páginasTM01

    Cese del nombramiento de Michelle Jane Gammon como secretario el 21 nov 2019

    1 páginasTM02

    Cuentas completas preparadas hasta el 01 sept 2018

    19 páginasAA

    Declaración de confirmación presentada el 01 jun 2019 con actualizaciones

    5 páginasCS01

    Cese del nombramiento de Jonathan Sokoloff como director el 22 mar 2019

    1 páginasTM01

    Cese del nombramiento de Adam Thomas Levyn como director el 22 mar 2019

    1 páginasTM01

    Nombramiento de Mr Adam Thomas Levyn como director el 31 dic 2018

    2 páginasAP01

    Cese del nombramiento de James Halper como director el 31 dic 2018

    1 páginasTM01

    ¿Quiénes son los directivos de AGBL OPCO REALISATIONS LIMITED?

    Directivos
    NombreNombrado elRenunció elRolDirecciónIdentificación de la empresaPaís de residenciaNacionalidadFecha de nacimientoOcupaciónNúmero
    FOREY, Siobhan
    70 Berners Street
    W1T 3NL London
    Colegrave House
    United Kingdom
    Director
    70 Berners Street
    W1T 3NL London
    Colegrave House
    United Kingdom
    United KingdomBritish111977210002
    GRABINER, Ian Michael
    70 Berners Street
    W1T 3NL London
    Colegrave House
    United Kingdom
    Director
    70 Berners Street
    W1T 3NL London
    Colegrave House
    United Kingdom
    ScotlandBritish63235540002
    GREEN, Philip Nigel Ross, Sir
    156 Great Charles Street Queensway
    Queensway
    B3 3HN Birmingham
    C/O Teneo Finacial Advisory Limited
    West Midlands
    Director
    156 Great Charles Street Queensway
    Queensway
    B3 3HN Birmingham
    C/O Teneo Finacial Advisory Limited
    West Midlands
    United KingdomBritish103945640001
    BERGAMIN, Jayabaduri
    12 Newry Road
    TW1 1PL Twickenham
    Middlesex
    Secretario
    12 Newry Road
    TW1 1PL Twickenham
    Middlesex
    British116935080001
    CASH, Daphne Valerie
    20 Chichester Mews
    SE27 0NS London
    Secretario
    20 Chichester Mews
    SE27 0NS London
    British59646330004
    COX, Michelle Hazel
    154 Eastwood Road North
    SS9 4LZ Leigh On Sea
    Essex
    Secretario
    154 Eastwood Road North
    SS9 4LZ Leigh On Sea
    Essex
    British104461530003
    GAMMON, Michelle Jane
    70 Berners Street
    W1T 3NL London
    Colegrave House
    United Kingdom
    Secretario
    70 Berners Street
    W1T 3NL London
    Colegrave House
    United Kingdom
    221297650001
    GOLDMAN, Adam Alexander
    70 Berners Street
    W1T 3NL London
    Colegrave House
    United Kingdom
    Secretario
    70 Berners Street
    W1T 3NL London
    Colegrave House
    United Kingdom
    British192403200001
    HICKS, Beverley
    7 Westminster Court
    King & Queen Wharf Rotherhithe
    SE16 5SY London
    Secretario
    7 Westminster Court
    King & Queen Wharf Rotherhithe
    SE16 5SY London
    British92357410001
    HODGES, John
    The Old Orchard Burney Road
    Westhumble
    RH5 6AU Dorking
    Surrey
    Secretario
    The Old Orchard Burney Road
    Westhumble
    RH5 6AU Dorking
    Surrey
    British3666240001
    JACKMAN, Ian Peter
    Flat 11 Macready House
    75 Crawford Street
    W1H 5LR London
    Secretario
    Flat 11 Macready House
    75 Crawford Street
    W1H 5LR London
    British71660800001
    JACKMAN, Ian Peter
    Flat 11 Macready House
    75 Crawford Street
    W1H 5LR London
    Secretario
    Flat 11 Macready House
    75 Crawford Street
    W1H 5LR London
    British71660800001
    PREMI, Gurpal
    Colegrave House
    70 Berners Street
    W1T 3NL London
    Arcadia Group Limited
    England
    Secretario
    Colegrave House
    70 Berners Street
    W1T 3NL London
    Arcadia Group Limited
    England
    British180475620001
    RODIE, Kimberly Donna
    Falcon Grove
    SW11 2ST Clapham
    26
    London
    United Kingdom
    Secretario
    Falcon Grove
    SW11 2ST Clapham
    26
    London
    United Kingdom
    148647910001
    RODIE, Kimberly Donna
    Falcon Grove
    SW11 2ST Clapham
    26
    London
    United Kingdom
    Secretario
    Falcon Grove
    SW11 2ST Clapham
    26
    London
    United Kingdom
    Other134585610002
    SMITH, Philip Clayton
    24 Bishops Avenue
    Elstree
    WD6 3LZ Borehamwood
    Hertfordshire
    Secretario
    24 Bishops Avenue
    Elstree
    WD6 3LZ Borehamwood
    Hertfordshire
    British613980001
    STEVENSON, Rebecca Jayne
    49 Rivulet Road
    Tottenham
    N17 7JT London
    Secretario
    49 Rivulet Road
    Tottenham
    N17 7JT London
    British71917770002
    WALDRON, Aisha Leah
    Bookerhill Road
    HP12 4HA High Wycombe
    29
    Buckinghamshire
    United Kingdom
    Secretario
    Bookerhill Road
    HP12 4HA High Wycombe
    29
    Buckinghamshire
    United Kingdom
    147374130001
    BATES, David John
    11 The Laurels
    Potten End
    HP4 2SP Berkhamsted
    Hertfordshire
    Director
    11 The Laurels
    Potten End
    HP4 2SP Berkhamsted
    Hertfordshire
    United KingdomBritish613990001
    BROWN, David Nigel
    116 Clarence Road
    AL1 4NW St Albans
    Hertfordshire
    Director
    116 Clarence Road
    AL1 4NW St Albans
    Hertfordshire
    United KingdomBritish40354400003
    BUDGE, Paul Everard
    Berners Street
    W1T 3NL London
    Colegrave House 68-70
    United Kingdom
    Director
    Berners Street
    W1T 3NL London
    Colegrave House 68-70
    United Kingdom
    United KingdomBritish88851520002
    BURCHILL, Richard Leeroy
    70 Berners Street
    W1T 3NL London
    Colegrave House
    England
    Director
    70 Berners Street
    W1T 3NL London
    Colegrave House
    England
    United KingdomBritish115568070002
    CROSSLAND, Julie Sook Hein
    9 Rowallan Road
    SW6 6AF London
    Director
    9 Rowallan Road
    SW6 6AF London
    EnglandBritish70464290002
    DEDOMBAL, Richard
    Blackmoor Lane
    Bardsey
    LS17 9DY Leeds
    46
    United Kingdom
    Director
    Blackmoor Lane
    Bardsey
    LS17 9DY Leeds
    46
    United Kingdom
    United KingdomBritish165695440001
    DUCKELS, Colin Peter
    14 Woodlands Park
    Scarcroft
    LS14 3JU Leeds
    West Yorkshire
    Director
    14 Woodlands Park
    Scarcroft
    LS14 3JU Leeds
    West Yorkshire
    United KingdomBritish44237310004
    GERAGHTY, Mary Julia Margaret
    70 Berners Street
    W1T 3NL London
    Colegrave House
    England
    Director
    70 Berners Street
    W1T 3NL London
    Colegrave House
    England
    United KingdomBritish125285460003
    GOLDMAN, Adam Alexander
    4 Jenner Way
    Clarendon Park
    KT19 7LJ Epsom
    Surrey
    Director
    4 Jenner Way
    Clarendon Park
    KT19 7LJ Epsom
    Surrey
    EnglandBritish28466260004
    HAGUE, Gillian Anne
    70 Berners Street
    W1T 3NL London
    Colegrave House
    England
    Director
    70 Berners Street
    W1T 3NL London
    Colegrave House
    England
    United KingdomBritish99223490001
    HALPER, James
    70 Berners Street
    W1T 3NL London
    Colegrave House
    Director
    70 Berners Street
    W1T 3NL London
    Colegrave House
    United StatesAmerican174851860001
    HARRIS, Christopher Bryan
    70 Berners Street
    W1T 3NL London
    Colegrave House
    United Kingdom
    Director
    70 Berners Street
    W1T 3NL London
    Colegrave House
    United Kingdom
    United KingdomBritish234603670001
    HEALEY, Mark Anthony
    70 Berners Street
    W1T 3NL London
    Colegrave House
    England
    Director
    70 Berners Street
    W1T 3NL London
    Colegrave House
    England
    EnglandBritish77432550002
    HIND, Andrew Clive
    14 Princes Avenue
    Muswell Hill
    N10 3LR London
    Director
    14 Princes Avenue
    Muswell Hill
    N10 3LR London
    EnglandBritish113038870001
    HODGES, John
    The Old Orchard Burney Road
    Westhumble
    RH5 6AU Dorking
    Surrey
    Director
    The Old Orchard Burney Road
    Westhumble
    RH5 6AU Dorking
    Surrey
    British3666240001
    HOMER, Mary Elizabeth
    Colegrave House
    70 Berners Street
    W1T 3NL London
    Director
    Colegrave House
    70 Berners Street
    W1T 3NL London
    United KingdomBritish175056190001
    JACKMAN, Ian Peter
    Flat 11 Macready House
    75 Crawford Street
    W1H 5LR London
    Director
    Flat 11 Macready House
    75 Crawford Street
    W1H 5LR London
    British71660800001

    ¿Quiénes son las personas con control significativo de AGBL OPCO REALISATIONS LIMITED?

    Personas con control significativo
    NombreNotificado elDirecciónCesado
    70 Berners Street
    W1T 3NL London
    Colegrave House
    United Kingdom
    06 abr 2016
    70 Berners Street
    W1T 3NL London
    Colegrave House
    United Kingdom
    No
    Forma jurídicaLimited By Shares
    País de registroEngland And Wales
    Autoridad legalUnited Kingdom (England And Wales)
    Lugar de registroCompanies House
    Número de registro00237511
    Naturaleza del control
    • La persona posee, directa o indirectamente, más del 75% de las acciones de la compañía.
    • La persona posee, directa o indirectamente, más del 75% de los derechos de voto en la empresa.

    ¿Tiene AGBL OPCO REALISATIONS LIMITED alguna carga?

    Gravámenes
    ClasificaciónFechasEstadoDetalles
    Debenture
    Creado el 14 dic 2004
    Entregado el 23 dic 2004
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the charging companies to the chargee and/or the other security beneficiaries (or any of them) under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descripción
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland (Security Trustee)
    Transacciones
    • 23 dic 2004Registro de un cargo (395)
    • 04 feb 2013Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (MG02)
    Deed of accession to a composite guarantee and debenture dated 10 september 2002
    Creado el 18 dic 2002
    Entregado el 23 dic 2002
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All present and future obligations and liabilities of each charging company to the security trustee and the security beneficiaries (or any of them) under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descripción
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland Acting in Its Capacity as Security Trustee Forthe Security Beneficiaries (The Security Trustee)
    Transacciones
    • 23 dic 2002Registro de un cargo (395)
    • 18 ene 2005Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)

    ¿Tiene AGBL OPCO REALISATIONS LIMITED algún caso de insolvencia?

    Número de expedienteFechasTipoProfesionalesOtro
    1
    FechaTipo
    30 nov 2020Inicio de la administración
    08 dic 2022Fin de la administración
    En administración
    NombreRolDirecciónNombrado elCesado el
    Matthew David Smith
    1 New Street Square
    EC4A 3HQ London
    Profesional
    1 New Street Square
    EC4A 3HQ London
    Gavin Maher
    1 New Street Square
    EC4A 3HQ London
    Profesional
    1 New Street Square
    EC4A 3HQ London
    Daniel Francis Butters
    1 New Street Square
    EC4A 3HQ London
    Profesional
    1 New Street Square
    EC4A 3HQ London

    Fuente de datos

    • Companies House del Reino Unido
      El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros.
    • Licencia: CC0