BEDFORDSHIRE NEWSPAPERS LIMITED

BEDFORDSHIRE NEWSPAPERS LIMITED

  • Visión general
  • Resumen
  • Propósito
  • Dirección
  • Nombres anteriores
  • Cuentas
  • Presentaciones
  • Directivos
  • Personas con control significativo
  • Gravámenes
  • Insolvencia
  • Fuente de datos
  • Visión general

    Nombre de la empresaBEDFORDSHIRE NEWSPAPERS LIMITED
    Estado de la empresaDisuelta
    Forma jurídicaSociedad de responsabilidad limitada
    Número de empresa 01021920
    JurisdicciónInglaterra/Gales
    Fecha de constitución
    Fecha de cese

    Resumen

    Tiene PSCs súper segurosNo
    Tiene gravámenes
    Tiene historial de insolvencia
    La sede social está en disputaNo

    ¿Cuál es el propósito de BEDFORDSHIRE NEWSPAPERS LIMITED?

    • Edición de periódicos (58130) / Información y comunicación

    ¿Dónde se encuentra BEDFORDSHIRE NEWSPAPERS LIMITED?

    Dirección de la sede social
    6 Snow Hill
    EC1A 2AY City Of London
    London
    Dirección de la sede social no entregableNo

    ¿Cuáles fueron los nombres anteriores de BEDFORDSHIRE NEWSPAPERS LIMITED?

    Nombres anteriores de la empresa
    Nombre de la empresaDesdeHasta
    UNIQUE NEWSPAPERS LIMITED19 jul 199619 jul 1996
    EMAP UNIQUE NEWSPAPERS LIMITED20 jun 199420 jun 1994
    TOWN CRIER LIMITED16 abr 198516 abr 1985
    ADPOWER PROMOTIONS LIMITED23 ago 197123 ago 1971

    ¿Cuáles son las últimas cuentas de BEDFORDSHIRE NEWSPAPERS LIMITED?

    Últimas cuentas
    Últimas cuentas cerradas hasta30 dic 2017

    ¿Cuáles son las últimas presentaciones para BEDFORDSHIRE NEWSPAPERS LIMITED?

    Presentaciones
    FechaDescripciónDocumentoTipo

    Gaceta final disuelta tras la liquidación

    1 páginasGAZ2

    Devolución de la reunión final en una liquidación voluntaria de acreedores

    10 páginasLIQ14

    Cese del nombramiento de David John King como director el 31 dic 2019

    1 páginasTM01

    Cese del nombramiento de Peter Michael Mccall como secretario el 31 dic 2019

    1 páginasTM02

    Domicilio social registrado cambiado de Unex House - Suite B Bourges Boulevard Peterborough Cambridgeshire PE1 1NG a 6 Snow Hill City of London London EC1A 2AY el 08 abr 2019

    2 páginasAD01

    Nombramiento de un liquidador voluntario

    3 páginas600

    Declaración de asuntos

    10 páginasLIQ02

    Resoluciones

    Resolutions
    1 páginasRESOLUTIONS
    Acuerdos
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    liquidation

    Acuerdo extraordinario para la liquidación el 18 mar 2019

    LRESEX

    Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 30 dic 2017

    8 páginasAA

    Declaración de confirmación presentada el 23 jul 2018 sin actualizaciones

    3 páginasCS01

    Cese del nombramiento de Ashley Gilroy Mark Highfield como director el 05 jun 2018

    1 páginasTM01

    Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 31 dic 2016

    8 páginasAA

    Declaración de confirmación presentada el 26 jul 2017 con actualizaciones

    4 páginasCS01

    Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 02 ene 2016

    7 páginasAA

    Declaración de confirmación presentada el 02 ago 2016 con actualizaciones

    4 páginasCS01

    Déclaration annuelle établie au 02 ago 2015 avec liste complète des actionnaires

    6 páginasAR01
    Presentaciones asociadas
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    capital07 ago 2015

    Estado de capital el 07 ago 2015

    • Capital: GBP 1,089.01
    SH01

    Domicilio social registrado cambiado de 11-13 Mill Street Bedford Bedfordshire MK40 3EU a Unex House - Suite B Bourges Boulevard Peterborough Cambridgeshire PE1 1NG el 06 ago 2015

    1 páginasAD01

    Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 03 ene 2015

    9 páginasAA

    Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 28 dic 2013

    8 páginasAA

    Cambio de datos del director Mr David John King el 01 jul 2014

    2 páginasCH01

    Cambio de datos del director Mr Ashley Gilroy Mark Highfield el 01 jul 2014

    2 páginasCH01

    Cambio de datos del secretario Mr Peter Michael Mccall el 01 jul 2014

    1 páginasCH03

    Déclaration annuelle établie au 02 ago 2014 avec liste complète des actionnaires

    6 páginasAR01
    Presentaciones asociadas
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    capital08 ago 2014

    Estado de capital el 08 ago 2014

    • Capital: GBP 1,089.01
    SH01

    Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 29 dic 2012

    8 páginasAA

    Déclaration annuelle établie au 02 ago 2013 avec liste complète des actionnaires

    6 páginasAR01
    Presentaciones asociadas
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    capital05 ago 2013

    Estado de capital tras una asignación de acciones el 05 ago 2013

    SH01

    ¿Quiénes son los directivos de BEDFORDSHIRE NEWSPAPERS LIMITED?

    Directivos
    NombreNombrado elRenunció elRolDirecciónIdentificación de la empresaPaís de residenciaNacionalidadFecha de nacimientoOcupaciónNúmero
    ABBOTT, Jane Dorothy
    Sawatdi
    East Road
    PE8 4BX Oundle
    Northhampshire
    Secretario
    Sawatdi
    East Road
    PE8 4BX Oundle
    Northhampshire
    British102874790001
    HARRIS, Christopher Ian
    6 Baker Court
    Thrapston
    NN14 4XA Kettering
    Northamptonshire
    Secretario
    6 Baker Court
    Thrapston
    NN14 4XA Kettering
    Northamptonshire
    British53420880002
    LISLE, Vincent Thomas
    5 Otters Holt
    Durkar
    WF4 3QE Wakefield
    West Yorkshire
    Secretario
    5 Otters Holt
    Durkar
    WF4 3QE Wakefield
    West Yorkshire
    British88104040001
    MCCALL, Peter Michael
    Orchard Brae House, 30 Queensferry Road
    EH4 2HS Edinburgh
    8th Floor
    Scotland
    Secretario
    Orchard Brae House, 30 Queensferry Road
    EH4 2HS Edinburgh
    8th Floor
    Scotland
    158805550001
    PATRICK, David John
    21 East Street
    NN1 5JZ Northampton
    Secretario
    21 East Street
    NN1 5JZ Northampton
    British119390850002
    STEELE, Toby Andrew Murray
    62 Dynevor Close
    Bromham
    MK43 8UD Bedford
    Bedfordshire
    Secretario
    62 Dynevor Close
    Bromham
    MK43 8UD Bedford
    Bedfordshire
    British91907510001
    VALDERAZ, Anne
    37 Manor Lane
    Alconbury
    PE17 5EH Huntingdon
    Cambridgeshire
    Secretario
    37 Manor Lane
    Alconbury
    PE17 5EH Huntingdon
    Cambridgeshire
    British48965240001
    WALMSLEY, Derek Kerr
    Sennen
    Grange Road
    MK43 7EU Felmersham
    North Bedfordshire
    Secretario
    Sennen
    Grange Road
    MK43 7EU Felmersham
    North Bedfordshire
    British16754910001
    YEOMANS, Graham Arthur
    13 Beagle Ridge Drive
    Acomb
    YO2 3JH York
    North Yorkshire
    Secretario
    13 Beagle Ridge Drive
    Acomb
    YO2 3JH York
    North Yorkshire
    British602760001
    ALLEN, Frederick John
    6 Glebe Close
    Horringer
    IP29 5PR Bury St Edmunds
    Suffolk
    Director
    6 Glebe Close
    Horringer
    IP29 5PR Bury St Edmunds
    Suffolk
    British30121880001
    BAILLIE, John Andrew Main
    Yew Cottage
    Main Road, Uffington
    PE9 4SN Stamford
    Lincolnshire
    Director
    Yew Cottage
    Main Road, Uffington
    PE9 4SN Stamford
    Lincolnshire
    British76483990001
    BOWDLER, Timothy John
    2-11 St Vincent Place
    EH3 5BQ Edinburgh
    Director
    2-11 St Vincent Place
    EH3 5BQ Edinburgh
    United KingdomBritish37521870002
    CAMMIADE, Danny
    Holyrood Road
    EH8 8AS Edinburgh
    108
    Scotland
    Director
    Holyrood Road
    EH8 8AS Edinburgh
    108
    Scotland
    EnglandBritish251394160001
    CHIAPPELLI, Marco Luigi Autimio
    21 Braid Farm Road
    EH10 6LE Edinburgh
    Director
    21 Braid Farm Road
    EH10 6LE Edinburgh
    ScotlandBritish474360001
    CLARK, Stephen Robert
    114 Hillesden Avenue
    Elstow
    MK42 9AJ Bedford
    Bedfordshire
    Director
    114 Hillesden Avenue
    Elstow
    MK42 9AJ Bedford
    Bedfordshire
    British60851690002
    ELLIS, Michael John
    40 King Street
    Somersham
    PE17 3EJ Huntingdon
    Cambridgeshire
    Director
    40 King Street
    Somersham
    PE17 3EJ Huntingdon
    Cambridgeshire
    EnglandBritish178022450001
    EVANS, Michael Joseph
    The Manor House 59 Church Street
    Nassington
    PE8 6QG Peterborough
    Cambridgeshire
    Director
    The Manor House 59 Church Street
    Nassington
    PE8 6QG Peterborough
    Cambridgeshire
    EnglandBritish30037370001
    FEETHAM, Robert Anthony
    4 The Charters
    Uffington
    PE9 4UD Stamford
    Lincolnshire
    Director
    4 The Charters
    Uffington
    PE9 4UD Stamford
    Lincolnshire
    EnglandBritish64401770001
    FRY, John Anthony
    Church Hill
    NR15 1TD Saxlingham Nethergate
    Old Rectory
    Norfolk
    Uk
    Director
    Church Hill
    NR15 1TD Saxlingham Nethergate
    Old Rectory
    Norfolk
    Uk
    EnglandBritish136914890001
    HARRIS, Christopher Ian
    31 Kettering Road
    Isham
    NN14 1HQ Kettering
    Northamptonshire
    Director
    31 Kettering Road
    Isham
    NN14 1HQ Kettering
    Northamptonshire
    British53420880003
    HIGHFIELD, Ashley Gilroy Mark
    Orchard Brae House
    30 Queensferry Road
    EH4 2HS Edinburgh
    8th Floor
    Scotland
    Director
    Orchard Brae House
    30 Queensferry Road
    EH4 2HS Edinburgh
    8th Floor
    Scotland
    United KingdomBritish164400440001
    JOHNSTON, Frederick Patrick Mair
    1 Grange Terrace
    EH9 2LD Edinburgh
    Director
    1 Grange Terrace
    EH9 2LD Edinburgh
    British328390001
    JOHNSTON, Michael Frederick
    19 Webster Gardens
    W5 5NA London
    Director
    19 Webster Gardens
    W5 5NA London
    British64615750001
    KING, David John
    Orchard Brae House
    30 Queensferry Road
    EH4 2HS Edinburgh
    8th Floor
    Scotland
    Director
    Orchard Brae House
    30 Queensferry Road
    EH4 2HS Edinburgh
    8th Floor
    Scotland
    United KingdomBritish179020430001
    LANKESTER, David Robin Archibald
    11 Bath Row
    PE9 2QU Stamford
    Lincolnshire
    Director
    11 Bath Row
    PE9 2QU Stamford
    Lincolnshire
    British49804010002
    LAWLER, Thomas Philip
    Glenlair Cottage 15 Nab Lane
    BD18 4EH Shipley
    West Yorkshire
    Director
    Glenlair Cottage 15 Nab Lane
    BD18 4EH Shipley
    West Yorkshire
    British7475760001
    MURRAY, Grant
    Holyrood Road
    EH8 8AS Edinburgh
    108
    Scotland
    Director
    Holyrood Road
    EH8 8AS Edinburgh
    108
    Scotland
    United KingdomBritish159877110001
    NIZOL, David Frederick
    18 Hallam Close
    CM15 0NW Brentwood
    Essex
    Director
    18 Hallam Close
    CM15 0NW Brentwood
    Essex
    British109032760001
    PATERSON, Stuart Randall
    41 Fernielaw Avenue
    EH13 0EF Edinburgh
    Midlothian
    Director
    41 Fernielaw Avenue
    EH13 0EF Edinburgh
    Midlothian
    ScotlandBritish64281400001
    RATCLIFFE, Neil Anthony
    Red Oaks Mill Road
    Lower Shiplake
    RG9 3LN Henley On Thames
    Oxfordshire
    Director
    Red Oaks Mill Road
    Lower Shiplake
    RG9 3LN Henley On Thames
    Oxfordshire
    United KingdomBritish122955650001
    RICHARDSON, Michael Robert
    4 Saint Marys Close
    Felmersham
    MK43 7JP Bedford
    Bedfordshire
    Director
    4 Saint Marys Close
    Felmersham
    MK43 7JP Bedford
    Bedfordshire
    England-UkBritish74383790001
    TOULMIN, George Michael
    The West Wing
    Thorp Arch Hall
    LS23 7AW Wetherby
    West Yorkshire
    Director
    The West Wing
    Thorp Arch Hall
    LS23 7AW Wetherby
    West Yorkshire
    British9253330001

    ¿Quiénes son las personas con control significativo de BEDFORDSHIRE NEWSPAPERS LIMITED?

    Personas con control significativo
    NombreNotificado elDirecciónCesado
    Johnston Press Plc
    30 Queensferry Road
    EH4 2HS Edinburgh
    Orchard Brae House
    Scotland
    06 abr 2016
    30 Queensferry Road
    EH4 2HS Edinburgh
    Orchard Brae House
    Scotland
    No
    Forma jurídicaPublic Limited Company
    País de registroUnited Kingdom
    Autoridad legalThe Companies Act 2006
    Lugar de registroScotland
    Número de registroSc015382
    Naturaleza del control
    • La persona tiene derecho a ejercer, o ejerce efectivamente, una influencia o control significativo sobre las actividades de una sociedad civil que, según la ley que la rige, no es una persona jurídica; y los miembros de esa sociedad civil (en esa calidad) poseen, directamente o indirectamente, más del 75% de las acciones de la compañía.
    • La persona tiene el derecho de ejercer, o ejerce realmente, una influencia o control significativo sobre las actividades de una firma que, según la ley que la rige, no es una persona jurídica; y los miembros de esa firma (en su calidad como tales) poseen, directa o indirectamente, más del 75% de los derechos de voto en la empresa.
    • La persona tiene el derecho de ejercer, o ejerce realmente, una influencia o control significativo sobre las actividades de una firma que, según la ley que la rige, no es una persona jurídica; y los miembros de esa firma (en su calidad como tales) tienen el derecho, directa o indirectamente, de nombrar o destituir a la mayoría de la junta directiva de la empresa.

    ¿Tiene BEDFORDSHIRE NEWSPAPERS LIMITED alguna carga?

    Gravámenes
    ClasificaciónFechasEstadoDetalles
    Debenture
    Creado el 01 jul 1996
    Entregado el 19 jul 1996
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the facility agreement, the other finance documents, the rbs facilities, the bridging facility and the rbs guarantee and/or any deed or document supplemental thereto, whether actual, contingent, sole, joint and/or several or otherwise, including, without limitation, all obligations to indemnify the chargee (the "secured obligations")
    Breve descripción
    .. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • The Royal Bank of Scotland PLC(For Itself and as Trustee for and on Behalf Ofthe Agent, the Banks and Rbs)
    Transacciones
    • 19 jul 1996Registro de un cargo (395)
    • 07 oct 1999Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Debenture
    Creado el 18 abr 1983
    Entregado el 07 may 1983
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    (Please see doc M22). Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personas con derecho
    • Dennis Roy Pegran
    Transacciones
    • 07 may 1983Registro de una carga
    Charge
    Creado el 16 oct 1981
    Entregado el 29 oct 1981
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    All book debts & other debts due, owing or incurred to the company present & future.
    Personas con derecho
    • Midland Bank PLC
    Transacciones
    • 29 oct 1981Registro de una carga
    • 24 nov 1995Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Legal charge
    Creado el 12 dic 1980
    Entregado el 18 dic 1980
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    L/H lands & premises being the old court house, priory road, st. Ives, cambridgeshire.
    Personas con derecho
    • Midland Bank PLC
    Transacciones
    • 18 dic 1980Registro de una carga
    Mortgage
    Creado el 09 feb 1978
    Entregado el 21 feb 1978
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    F/H lands and premises being:- 83 victoria rd, new chesterton, cambridgeshire, together with all fixtures. Title no:- GB 8203.
    Personas con derecho
    • Midland Bank PLC
    Transacciones
    • 21 feb 1978Registro de una carga
    • 03 abr 1996Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Mortgage
    Creado el 17 ago 1977
    Entregado el 24 ago 1977
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    Floating charge (see doc M18 for details). Undertaking and all property and assets present and future including uncalled capital.
    Personas con derecho
    • Midland Bank PLC
    Transacciones
    • 24 ago 1977Registro de una carga
    • 24 nov 1995Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)

    ¿Tiene BEDFORDSHIRE NEWSPAPERS LIMITED algún caso de insolvencia?

    Número de expedienteFechasTipoProfesionalesOtro
    1
    FechaTipo
    18 mar 2019Inicio de la liquidación
    17 abr 2020Fecha de disolución
    Liquidación voluntaria de acreedores
    NombreRolDirecciónNombrado elCesado el
    Steven Edward Butt
    Rollings Butt Llp 6 Snow Hill
    EC1A 2AY London
    Profesional
    Rollings Butt Llp 6 Snow Hill
    EC1A 2AY London
    Michael David Rollings
    Rollings Butt Llp 6 Snow Hill
    EC1A 2AY London
    Profesional
    Rollings Butt Llp 6 Snow Hill
    EC1A 2AY London

    Fuente de datos

    • Companies House del Reino Unido
      El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros.
    • Licencia: CC0