ASHDELL SCHOOLS TRUST LIMITED

ASHDELL SCHOOLS TRUST LIMITED

  • Visión general
  • Resumen
  • Propósito
  • Dirección
  • Cuentas
  • Presentaciones
  • Directivos
  • Personas con control significativo
  • Gravámenes
  • Fuente de datos
  • Visión general

    Nombre de la empresaASHDELL SCHOOLS TRUST LIMITED
    Estado de la empresaDisuelta
    Forma jurídicaSociedad de responsabilidad limitada por garantía sin capital social
    Número de empresa 01023306
    JurisdicciónInglaterra/Gales
    Fecha de constitución
    Fecha de cese

    Resumen

    Tiene PSCs súper segurosNo
    Tiene gravámenes
    Tiene historial de insolvenciaNo
    La sede social está en disputaNo

    ¿Cuál es el propósito de ASHDELL SCHOOLS TRUST LIMITED?

    • Educación primaria (85200) / Educación

    ¿Dónde se encuentra ASHDELL SCHOOLS TRUST LIMITED?

    Dirección de la sede social
    266 Fulwood Road,
    Sheffield
    S10 3BL
    Dirección de la sede social no entregableNo

    ¿Cuáles son las últimas cuentas de ASHDELL SCHOOLS TRUST LIMITED?

    Últimas cuentas
    Últimas cuentas cerradas hasta31 ago 2016

    ¿Cuáles son las últimas presentaciones para ASHDELL SCHOOLS TRUST LIMITED?

    Presentaciones
    FechaDescripciónDocumentoTipo

    Boletín oficial final disuelto por cancelación voluntaria

    1 páginasGAZ2(A)

    La acción de exclusión voluntaria ha sido suspendida

    1 páginasSOAS(A)

    Primer aviso en el boletín oficial para la cancelación voluntaria

    1 páginasGAZ1(A)

    Solicitud de exclusión de la empresa del registro

    3 páginasDS01

    Cese del nombramiento de Tom Beardmore-Gray como director el 23 mar 2018

    1 páginasTM01

    Nombramiento de Mr David Mark Boyd como director el 21 mar 2018

    2 páginasAP01

    Declaración de confirmación presentada el 20 dic 2017 sin actualizaciones

    3 páginasCS01

    Cancelación total de la carga 1

    4 páginasMR04

    Cancelación total de la carga 2

    4 páginasMR04

    Cuentas completas preparadas hasta el 31 ago 2016

    20 páginasAA

    Cese del nombramiento de Kenneth Douglas Eaton como secretario el 30 abr 2017

    1 páginasTM02

    Cese del nombramiento de Caroline Lucy Hoare como director el 31 mar 2017

    1 páginasTM01

    Declaración de confirmación presentada el 20 dic 2016 con actualizaciones

    4 páginasCS01

    Nombramiento de Mrs Caroline Lucy Hoare como director el 04 nov 2016

    2 páginasAP01

    Nombramiento de Mr Tom Beardmore-Gray como director el 04 nov 2016

    2 páginasAP01

    Resoluciones

    Resolutions
    22 páginasRESOLUTIONS
    Acuerdos
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    incorporation

    Resolución de modificación de los Artículos de Asociación

    RES01

    Cese del nombramiento de Josephine Ann Wood como director el 04 nov 2016

    1 páginasTM01

    Cese del nombramiento de Susan Lucy Singleton como director el 04 nov 2016

    1 páginasTM01

    Cese del nombramiento de Elizabeth Annabel Walker como director el 04 nov 2016

    1 páginasTM01

    Cese del nombramiento de Anthony John Riddle como director el 04 nov 2016

    1 páginasTM01

    Cese del nombramiento de David Jonathan Dunn como director el 04 nov 2016

    1 páginasTM01

    Cese del nombramiento de Daphne St.Clair Cawthorne como director el 04 nov 2016

    1 páginasTM01

    Cese del nombramiento de Christopher Michael Caddy como director el 04 nov 2016

    1 páginasTM01

    Cese del nombramiento de Christopher Mark Burke como director el 04 nov 2016

    1 páginasTM01

    Cese del nombramiento de Richard Brailsford como director el 04 nov 2016

    1 páginasTM01

    ¿Quiénes son los directivos de ASHDELL SCHOOLS TRUST LIMITED?

    Directivos
    NombreNombrado elRenunció elRolDirecciónIdentificación de la empresaPaís de residenciaNacionalidadFecha de nacimientoOcupaciónNúmero
    BOYD, David Mark
    Rochester Row
    SW1P 1JP London
    100
    England
    Director
    Rochester Row
    SW1P 1JP London
    100
    England
    EnglandBritish244724050001
    AXELBY, Graham
    86 Crimicar Lane
    S10 4FB Sheffield
    South Yorkshire
    Secretario
    86 Crimicar Lane
    S10 4FB Sheffield
    South Yorkshire
    British33337420001
    BARBER, Marie
    266 Fulwood Road,
    Sheffield
    S10 3BL
    Secretario
    266 Fulwood Road,
    Sheffield
    S10 3BL
    159737660001
    CROOKS, Freda Maureen
    44 Peterborough Road
    S10 4JE Sheffield
    S Yorks
    Secretario
    44 Peterborough Road
    S10 4JE Sheffield
    S Yorks
    British32401600001
    EATON, Kenneth Douglas
    266 Fulwood Road,
    Sheffield
    S10 3BL
    Secretario
    266 Fulwood Road,
    Sheffield
    S10 3BL
    169013520001
    ELSON, Andrea Mary
    Mill Cottage Mill Lane
    Millthorpe Holmesfield
    S18 5WL Sheffield
    Secretario
    Mill Cottage Mill Lane
    Millthorpe Holmesfield
    S18 5WL Sheffield
    British50214570001
    MANGLES, David Kenneth Pasley
    Heather Lea Avenue
    S17 3DL Sheffield
    49
    Secretario
    Heather Lea Avenue
    S17 3DL Sheffield
    49
    British146285490001
    MARSDEN, Jane
    190 Lydgate Lane
    S10 5FS Sheffield
    Secretario
    190 Lydgate Lane
    S10 5FS Sheffield
    British61763580001
    WEATHERALL, Jennifer Anne
    266 Fulwood Road,
    Sheffield
    S10 3BL
    Secretario
    266 Fulwood Road,
    Sheffield
    S10 3BL
    156815580001
    BAIRD, James Stevenson
    521 Fulwood Road
    S10 3QB Sheffield
    Director
    521 Fulwood Road
    S10 3QB Sheffield
    British61763600001
    BALFOUR, Mark Robin, Hon
    Fairways Saltergate Lane
    Bamford
    S30 2BE Sheffield
    South Yorkshire
    Director
    Fairways Saltergate Lane
    Bamford
    S30 2BE Sheffield
    South Yorkshire
    British2908220001
    BAX, Nigel Derrick Spencer, Dr
    Ashtonfields
    Church Lane Baslow
    DE45 1SP Bakewell
    Derbyshire
    Director
    Ashtonfields
    Church Lane Baslow
    DE45 1SP Bakewell
    Derbyshire
    British7462490002
    BEARDMORE-GRAY, Tom
    Rochester Row
    SW1P 1JP London
    100
    England
    Director
    Rochester Row
    SW1P 1JP London
    100
    England
    EnglandBritish133341080001
    BISSET, Moray Mclaren
    24 Grove Road
    Horbury
    WF4 6AQ Wakefield
    Mews Cottage
    Director
    24 Grove Road
    Horbury
    WF4 6AQ Wakefield
    Mews Cottage
    United KingdomBritish63309500002
    BLAKEY, Sara Barbara
    73 Ranmoor Road
    S10 3HJ Sheffield
    Yorkshire
    Director
    73 Ranmoor Road
    S10 3HJ Sheffield
    Yorkshire
    British94827640001
    BRAILSFORD, Richard
    266 Fulwood Road,
    Sheffield
    S10 3BL
    Director
    266 Fulwood Road,
    Sheffield
    S10 3BL
    EnglandBritish64805560002
    BRIDGE, Gordon Wilson
    Primrose Cottage Farm Kirk Edge Road
    High Bradfield
    S6 6LJ Sheffield
    Director
    Primrose Cottage Farm Kirk Edge Road
    High Bradfield
    S6 6LJ Sheffield
    EnglandBritish5201640001
    BURKE, Christopher Mark, The Revd Canon
    266 Fulwood Road,
    Sheffield
    S10 3BL
    Director
    266 Fulwood Road,
    Sheffield
    S10 3BL
    United KingdomBritish157364710001
    CADDY, Christopher Michael
    2 Tapton Park Mount
    Ranmoor
    S10 3FH Sheffield
    Director
    2 Tapton Park Mount
    Ranmoor
    S10 3FH Sheffield
    EnglandBritish85426990001
    CAWTHORNE, Daphne St.Clair
    80 Brooklands Avenue
    S10 4GD Sheffield
    South Yorkshire
    Director
    80 Brooklands Avenue
    S10 4GD Sheffield
    South Yorkshire
    EnglandBritish43648860001
    COOMBE, Andrew Jackson
    45 Stumperlowe Crescent Road
    S10 3PR Sheffield
    South Yorkshire
    Director
    45 Stumperlowe Crescent Road
    S10 3PR Sheffield
    South Yorkshire
    United KingdomBritish33999960001
    DUNN, David Jonathan
    Tapton House
    15 Tapton House Road
    S10 5BY Sheffield
    Director
    Tapton House
    15 Tapton House Road
    S10 5BY Sheffield
    EnglandBritish43280180002
    FACEY, Hugh David
    Clifford House
    Ecclesall Road South
    S11 9PX Sheffield
    Director
    Clifford House
    Ecclesall Road South
    S11 9PX Sheffield
    EnglandBritish81575880001
    GOMM, Sarah Jane
    Uppingham School
    LE15 9QE Uppingham
    School House
    Rutland
    Director
    Uppingham School
    LE15 9QE Uppingham
    School House
    Rutland
    EnglandBritish137045940002
    HART-HALL, Hilary
    Stoke Cottage,
    Grindleford
    S32 2HW Hope Valley
    Derbyshire
    Director
    Stoke Cottage,
    Grindleford
    S32 2HW Hope Valley
    Derbyshire
    British73149000001
    HASAN, Elizabeth
    266 Fulwood Road,
    Sheffield
    S10 3BL
    Director
    266 Fulwood Road,
    Sheffield
    S10 3BL
    EnglandBritish184294580001
    HIRD, Norma Jean
    44 Crescent Road
    S7 1HN Sheffield
    Director
    44 Crescent Road
    S7 1HN Sheffield
    EnglandBritish63779570006
    HOARE, Caroline Lucy
    Rochester Row
    SW1P 1JP London
    100
    England
    Director
    Rochester Row
    SW1P 1JP London
    100
    England
    EnglandBritish172659560001
    HOLMES, Deborah
    The Grange, Morehall Lane,
    Bolsterstone
    S36 3ST Sheffield
    South Yorkshire
    Director
    The Grange, Morehall Lane,
    Bolsterstone
    S36 3ST Sheffield
    South Yorkshire
    United KingdomBritish36262210005
    HOSTOMBE, Susan Mary
    Fullwood Hall
    S10 4PA Sheffield
    South Yorkshire
    Director
    Fullwood Hall
    S10 4PA Sheffield
    South Yorkshire
    EnglandBritish95522190001
    KLEIN, Joyce Devine
    Lowe House
    1 Ranmoor Crescent
    S10 3GU Sheffield
    South Yorkshire
    Director
    Lowe House
    1 Ranmoor Crescent
    S10 3GU Sheffield
    South Yorkshire
    American78324210001
    LARVIN, Katherine Fiona
    266 Fulwood Road,
    Sheffield
    S10 3BL
    Director
    266 Fulwood Road,
    Sheffield
    S10 3BL
    United KingdomBritish156825110001
    LONGWORTH, Catherine
    34 Westmoreland Terrace
    SW1V 4AL London
    Director
    34 Westmoreland Terrace
    SW1V 4AL London
    EnglandBritish45525270001
    LORENZ, Eleanor, Doctor
    27 Pingle Avenue
    S7 2LP Sheffield
    South Yorkshire
    Director
    27 Pingle Avenue
    S7 2LP Sheffield
    South Yorkshire
    EnglandBritish102494710001
    MACINTOSH, George Grant
    St Johns Vicarage 2 Devonshire Glen
    S17 3NY Sheffield
    Director
    St Johns Vicarage 2 Devonshire Glen
    S17 3NY Sheffield
    British50211500001

    ¿Quiénes son las personas con control significativo de ASHDELL SCHOOLS TRUST LIMITED?

    Personas con control significativo
    NombreNotificado elDirecciónCesado
    Rochester Row
    SW1P 1JP London
    100
    England
    04 nov 2016
    Rochester Row
    SW1P 1JP London
    100
    England
    No
    Forma jurídicaCompany Limited By Shares
    País de registroUnited Kingdom
    Autoridad legalCompanies Act
    Lugar de registroCompanies House
    Número de registro6400
    Naturaleza del control
    • La persona posee, directa o indirectamente, más del 75% de los derechos de voto en la empresa.

    ¿Tiene ASHDELL SCHOOLS TRUST LIMITED alguna carga?

    Gravámenes
    ClasificaciónFechasEstadoDetalles
    Legal charge
    Creado el 09 sept 1991
    Entregado el 27 sept 1991
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    1. f/h land and buildings on the north west side of fulwood road sheffield. South yorkshire t/no:- syk 5854 2. f/h land and buildings k/a 266 and 268 fulwood road sheffield south yorks t/n:- ywe 33268 3. l/h land and buildings adjoining 268 fulwood road sheffield south yorkshire t/no: ywe 33269. fixed charge over all the plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Personas con derecho
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transacciones
    • 27 sept 1991Registro de una carga
    • 17 jun 2017Satisfacción de una carga (MR04)
    Legal charge
    Creado el 07 ene 1991
    Entregado el 10 ene 1991
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    F/H property k/a aurora house 61 manchester road sheffield south yorks t/no syk 170853 & syk 28527 fixed charge over all plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Personas con derecho
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transacciones
    • 10 ene 1991Registro de una carga
    • 17 jun 2017Satisfacción de una carga (MR04)

    Fuente de datos

    • Companies House del Reino Unido
      El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros.
    • Licencia: CC0