JJB SPORTS PLC

  • Visión general
  • Resumen
  • Propósito
  • Dirección
  • Cuentas
  • Declaración anual
  • Presentaciones
  • Directivos
  • Gravámenes
  • Insolvencia
  • Fuente de datos
  • Visión general

    Nombre de la empresaJJB SPORTS PLC
    Estado de la empresaDisuelta
    Forma jurídicaSociedad anónima cotizada
    Número de empresa 01024895
    JurisdicciónInglaterra/Gales
    Fecha de constitución
    Fecha de cese

    Resumen

    Tiene PSCs súper segurosNo
    Tiene gravámenes
    Tiene historial de insolvencia
    La sede social está en disputaNo

    ¿Cuál es el propósito de JJB SPORTS PLC?

    • Venta al por menor de artículos deportivos, equipos de pesca, artículos de camping, embarcaciones y bicicletas (47640) / Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos de motor y motocicletas
    • Venta al por menor de prendas de vestir en establecimientos especializados (47710) / Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos de motor y motocicletas
    • Venta al por menor de calzado en establecimientos especializados (47721) / Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos de motor y motocicletas
    • Venta al por menor de artículos de cuero en establecimientos especializados (47722) / Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos de motor y motocicletas

    ¿Dónde se encuentra JJB SPORTS PLC?

    Dirección de la sede social
    Kpmg Llp
    1 St Peter'S Square
    M2 3AE Manchester
    Dirección de la sede social no entregableNo

    ¿Cuáles son las últimas cuentas de JJB SPORTS PLC?

    Últimas cuentas
    Últimas cuentas cerradas hasta29 ene 2012

    ¿Cuál es el estado de la última declaración anual para JJB SPORTS PLC?

    Declaración anual
    Última declaración anual

    ¿Cuáles son las últimas presentaciones para JJB SPORTS PLC?

    Presentaciones
    FechaDescripciónDocumentoTipo

    Renuncia de bienes vacantes

    1 páginasBONA

    Renuncia de bienes vacantes

    1 páginasBONA

    Renuncia de bienes vacantes

    1 páginasBONA

    Renuncia de bienes vacantes

    1 páginasBONA

    Renuncia de bienes vacantes

    1 páginasBONA

    Renuncia de bienes vacantes

    1 páginasBONA

    Renuncia de bienes vacantes

    1 páginasBONA

    Renuncia de bienes vacantes

    1 páginasBONA

    Renuncia de bienes vacantes

    1 páginasBONA

    Renuncia de bienes vacantes

    1 páginasBONA

    Renuncia de bienes vacantes

    1 páginasBONA

    Renuncia de bienes vacantes

    1 páginasBONA

    Renuncia de bienes vacantes

    1 páginasBONA

    Renuncia de bienes vacantes

    1 páginasBONA

    Gaceta final disuelta tras la liquidación

    1 páginasGAZ2

    Informe de progreso del administrador hasta 25 sept 2015

    25 páginas2.24B

    Aviso de cambio de la administración a la disolución el 25 sept 2015

    25 páginas2.35B

    Informe de progreso del administrador hasta 02 jul 2015

    24 páginas2.24B

    Informe de progreso del administrador hasta 02 ene 2014

    24 páginas2.24B

    Domicilio social registrado cambiado de Kpmg Llp 1 St Peter's Square Manchester M2 3AE a Kpmg Llp 1 St Peter's Square Manchester M2 3AE el 29 ene 2015

    2 páginasAD01

    Domicilio social registrado cambiado de Kpmg Llp Kpmg Llp St. James's Square Manchester Lancashire M2 6DS a Kpmg Llp 1 St Peter's Square Manchester M2 3AE el 29 ene 2015

    2 páginasAD01

    Informe de progreso del administrador hasta 02 jul 2014

    27 páginas2.24B

    Informe de progreso del administrador hasta 02 ene 2014

    25 páginas2.24B

    Informe de progreso del administrador hasta 02 jul 2013

    27 páginas2.24B

    Aviso de extensión del período de la administración

    1 páginas2.31B

    ¿Quiénes son los directivos de JJB SPORTS PLC?

    Directivos
    NombreNombrado elRenunció elRolDirecciónIdentificación de la empresaPaís de residenciaNacionalidadFecha de nacimientoOcupaciónNúmero
    WILLIAMS, David Robert
    1 St Peter's Square
    M2 3AE Manchester
    Kpmg Llp
    Secretario
    1 St Peter's Square
    M2 3AE Manchester
    Kpmg Llp
    161503180001
    ADAMS, David Alexander Robertson
    Three Elm Lane
    TN11 0AB Tonbridge
    Applegarth
    Kent
    United Kingdom
    Director
    Three Elm Lane
    TN11 0AB Tonbridge
    Applegarth
    Kent
    United Kingdom
    EnglandBritish55757700003
    BERNSTEIN, Richard Philip
    1 St Peter's Square
    M2 3AE Manchester
    Kpmg Llp
    Director
    1 St Peter's Square
    M2 3AE Manchester
    Kpmg Llp
    EnglandBritish3324230004
    CHRISTENSEN, Lawrence Richard
    1 St Peter's Square
    M2 3AE Manchester
    Kpmg Llp
    Director
    1 St Peter's Square
    M2 3AE Manchester
    Kpmg Llp
    United KingdomBritish171869320001
    CORLISS, Robert James
    1 St Peter's Square
    M2 3AE Manchester
    Kpmg Llp
    Director
    1 St Peter's Square
    M2 3AE Manchester
    Kpmg Llp
    UsaAmerican170571310001
    MCTIGHE, Michael
    1 St Peter's Square
    M2 3AE Manchester
    Kpmg Llp
    Director
    1 St Peter's Square
    M2 3AE Manchester
    Kpmg Llp
    United KingdomBritish156709120001
    PINSENT, Matthew Clive, Sir
    1 St Peter's Square
    M2 3AE Manchester
    Kpmg Llp
    Director
    1 St Peter's Square
    M2 3AE Manchester
    Kpmg Llp
    United KingdomBritish148640400001
    WILLIAMS, David Robert
    1 St Peter's Square
    M2 3AE Manchester
    Kpmg Llp
    Director
    1 St Peter's Square
    M2 3AE Manchester
    Kpmg Llp
    United KingdomBritish157062220001
    ASHBY, Jonathan
    Hinckley Court
    CW12 4WE Congleton
    1
    Cheshire
    Secretario
    Hinckley Court
    CW12 4WE Congleton
    1
    Cheshire
    British134682180001
    GREENWOOD, John David
    1 Brookside
    Euxton
    PR7 6HR Chorley
    Lancashire
    Secretario
    1 Brookside
    Euxton
    PR7 6HR Chorley
    Lancashire
    British4527320003
    MADELEY, David Phillip
    Mill Lane
    WA15 0RD Ashley
    One Castle Mill
    Cheshire
    Secretario
    Mill Lane
    WA15 0RD Ashley
    One Castle Mill
    Cheshire
    British128847520001
    MANNING, Richard Denley John
    Challenge Way
    Martland Park
    WN5 0LD Wigan
    Lancashire
    Secretario
    Challenge Way
    Martland Park
    WN5 0LD Wigan
    Lancashire
    British77961690001
    BEEVER, David Milton Maxwell
    Warren Farm House
    South Drive
    GU25 4JS Wentworth
    Surrey
    Director
    Warren Farm House
    South Drive
    GU25 4JS Wentworth
    Surrey
    United KingdomBritish35274610001
    BENZIE, Alan Athol Emslie
    Oakbarn, Higher House Farm
    Hocker Lane
    SK10 4SD Over Alderley
    Cheshire
    Director
    Oakbarn, Higher House Farm
    Hocker Lane
    SK10 4SD Over Alderley
    Cheshire
    EnglandBritish83412170001
    BEST, Roger Clive
    Stanner House
    Grimsargh
    PR2 5JE Preston
    Director
    Stanner House
    Grimsargh
    PR2 5JE Preston
    EnglandBritish114728210001
    CLARE, John Charles
    The Cottage Pinkneys Drive
    SL6 6QD Pinkneys Green
    Berkshire
    Director
    The Cottage Pinkneys Drive
    SL6 6QD Pinkneys Green
    Berkshire
    EnglandBritish16875650001
    COPPOCK, Lawrence Patrick
    The Close
    Church Lane
    SO51 0QH Braishfield
    Hampshire
    Director
    The Close
    Church Lane
    SO51 0QH Braishfield
    Hampshire
    EnglandUnited Kingdom152718990001
    DUNN, Barry John Keith
    The Farm House
    Back Lane Heath Charnock
    PR6 9DJ Chorley
    Director
    The Farm House
    Back Lane Heath Charnock
    PR6 9DJ Chorley
    United KingdomBritish60493690005
    FOSTER, George William
    9 Richmond Green
    Richmond Road
    WA14 2UB Bowdon
    Cheshire
    Director
    9 Richmond Green
    Richmond Road
    WA14 2UB Bowdon
    Cheshire
    United KingdomBritish106832100001
    GREENWOOD, John David
    1 Brookside
    Euxton
    PR7 6HR Chorley
    Lancashire
    Director
    1 Brookside
    Euxton
    PR7 6HR Chorley
    Lancashire
    United KingdomBritish4527320003
    HUNTER, Thomas Blane, Sir
    Ladykirk House
    Ladykirk Estate
    KA9 2SF Monkton
    Director
    Ladykirk House
    Ladykirk Estate
    KA9 2SF Monkton
    United KingdomBritish97904280003
    JONES, David Charles, Sir
    Whinbrae Wheatley Lane
    Ben Rhydding
    LS29 8SF Ilkley
    West Yorkshire
    Director
    Whinbrae Wheatley Lane
    Ben Rhydding
    LS29 8SF Ilkley
    West Yorkshire
    EnglandBritish11515940001
    JONES, Keith John
    Challenge Way
    Martland Park
    WN5 0LD Wigan
    Lancashire
    Director
    Challenge Way
    Martland Park
    WN5 0LD Wigan
    Lancashire
    United KingdomBritish161521440001
    KNIGHT, Thomas William
    Flat 5 Eastfield House
    15 Moor Road South
    NE3 1ND Gosforth
    Director
    Flat 5 Eastfield House
    15 Moor Road South
    NE3 1ND Gosforth
    British11423040008
    LANE SMITH, Roger
    Bradford Lane
    Nether Alderley
    SK10 4TR Macclesfield
    Bradford Lane Farm
    Cheshire
    Director
    Bradford Lane
    Nether Alderley
    SK10 4TR Macclesfield
    Bradford Lane Farm
    Cheshire
    United KingdomBritish109062130002
    MADELEY, David Phillip
    Mill Lane
    WA15 0RD Ashley
    One Castle Mill
    Cheshire
    Director
    Mill Lane
    WA15 0RD Ashley
    One Castle Mill
    Cheshire
    EnglandBritish128847520001
    MANNING, Richard Denley John
    Challenge Way
    Martland Park
    WN5 0LD Wigan
    Lancashire
    Director
    Challenge Way
    Martland Park
    WN5 0LD Wigan
    Lancashire
    EnglandBritish77961690002
    RIGBY, Mary
    Greystone Farm 1 Hall Lane
    Parbold
    WN8 7BD Wigan
    Lancashire
    Director
    Greystone Farm 1 Hall Lane
    Parbold
    WN8 7BD Wigan
    Lancashire
    British28471030002
    RONNIE, Christopher
    Grove House
    83 Knutsford Road
    SK9 6JH Wilmslow
    Cheshire
    Director
    Grove House
    83 Knutsford Road
    SK9 6JH Wilmslow
    Cheshire
    EnglandScottish79360390002
    SHARPE, Duncan James
    Waddington Old Hall Clitheroe Road
    Waddington
    BB7 3HP Clitheroe
    Lancashire
    Director
    Waddington Old Hall Clitheroe Road
    Waddington
    BB7 3HP Clitheroe
    Lancashire
    British13873080002
    THOMAS, Andrew Gerald
    Greenlands
    Forest Road, Little Budworth
    CW6 9ES Tarporley
    Cheshire
    Director
    Greenlands
    Forest Road, Little Budworth
    CW6 9ES Tarporley
    Cheshire
    British2024880001
    TRANTER, Colin Albert
    Off Sandy Lane
    Lower Peover
    WA16 9JF Knutsford
    Woodside Cottage
    Cheshire
    Uk
    Director
    Off Sandy Lane
    Lower Peover
    WA16 9JF Knutsford
    Woodside Cottage
    Cheshire
    Uk
    United KingdomBritish138755910001
    WAUDBY, Roy
    Western 12 Packman Lane
    Kirkella
    HU10 7TL Hull
    North Humberside
    Director
    Western 12 Packman Lane
    Kirkella
    HU10 7TL Hull
    North Humberside
    British8652040001
    WHELAN, David
    The Manor House
    Miry Lane Parbold
    WN8 7TA Wigan
    Lancashire
    Director
    The Manor House
    Miry Lane Parbold
    WN8 7TA Wigan
    Lancashire
    United KingdomBritish4527330001
    WILLIAMS, Peter Wodehouse
    Rayners Road
    SW15 2AY London
    3
    Director
    Rayners Road
    SW15 2AY London
    3
    EnglandBritish135547730001

    ¿Tiene JJB SPORTS PLC alguna carga?

    Gravámenes
    ClasificaciónFechasEstadoDetalles
    Guarantee & debenture
    Creado el 27 abr 2012
    Entregado el 04 may 2012
    Pendiente
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company and from each other chargor (except as guarantor for the company) to each finance party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descripción
    F/H land on the south west side of challenge way, wigan, t/no: GM718947; f/h land and buildings lying to the south of challenge way, wigan; and f/h land and buildings lying on the south side of challenge way, wigan, t/no:GM811303 (for details of all other property charged, please refer to the MG01 document) fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Personas con derecho
    • Lloyds Tsb Bank PLC (As Security Agent for the Finance Parties)
    Transacciones
    • 04 may 2012Registro de un cargo (MG01)
    • 04 oct 2012Declaración de que parte o la totalidad de la propiedad gravada ha sido liberada (MG04)
    • 09 oct 2012Declaración de que parte o la totalidad de la propiedad gravada ha sido liberada (MG04)
    Guarantee & debenture
    Creado el 03 jun 2009
    Entregado el 17 jun 2009
    Pendiente
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company and each other chargor to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descripción
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery (for details of properties charged please refer to the form 395). see image for full details.
    Personas con derecho
    • Bank of Scotland PLC
    Transacciones
    • 17 jun 2009Registro de un cargo (395)
    • 04 oct 2012Declaración de que parte o la totalidad de la propiedad gravada ha sido liberada (MG04)
    • 09 oct 2012Declaración de que parte o la totalidad de la propiedad gravada ha sido liberada (MG04)
    A charge over an account
    Creado el 03 jun 2009
    Entregado el 12 jun 2009
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to any finance party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descripción
    With full title guarantee charged by way of first fixed charge all of the rights, title and interest from time totime in and to each charged asset see image for full details.
    Personas con derecho
    • Barclays Bank PLC
    Transacciones
    • 12 jun 2009Registro de un cargo (395)
    • 11 dic 2009Declaración de que parte o la totalidad de la propiedad gravada ha sido liberada (MG04)
    • 17 feb 2011Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (MG02)
    Account charge
    Creado el 17 dic 2008
    Entregado el 24 dic 2008
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the secured parties on any account whatsoever
    Breve descripción
    All of the chargor's rights,title and interest from time to time in and to each charged asset see image for full details.
    Personas con derecho
    • Barclays Bank PLC as Agent and Trustee for Itself and Bank of Scotland PLC and Kaupthing Singer & Friedlander Limited
    Transacciones
    • 24 dic 2008Registro de un cargo (395)
    • 21 jul 2009Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Guarantee & debenture
    Creado el 06 oct 2008
    Entregado el 11 oct 2008
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Personas con derecho
    • Kaupthing Singer & Friedlander Limited
    Transacciones
    • 11 oct 2008Registro de un cargo (395)
    • 21 jul 2009Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Guarantee & debenture
    Creado el 26 sept 2008
    Entregado el 02 oct 2008
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Personas con derecho
    • Barclays Bank PLC
    Transacciones
    • 02 oct 2008Registro de un cargo (395)
    • 11 dic 2009Declaración de que parte o la totalidad de la propiedad gravada ha sido liberada (MG04)
    • 17 feb 2011Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (MG02)
    Guarantee & debenture
    Creado el 26 sept 2008
    Entregado el 29 sept 2008
    Pendiente
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the chargors to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Personas con derecho
    • Bank of Scotland PLC
    Transacciones
    • 29 sept 2008Registro de un cargo (395)
    • 04 oct 2012Declaración de que parte o la totalidad de la propiedad gravada ha sido liberada (MG04)
    • 09 oct 2012Declaración de que parte o la totalidad de la propiedad gravada ha sido liberada (MG04)
    Mortgage of bank account as amended by supplemental deed
    Creado el 13 jun 2005
    Entregado el 23 jun 2005
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descripción
    All its right title and interest in and to the deposit, the account numbered 611079 and agreement dated 26 february 2001. see the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • Thomas Blane Hunter, James Cairns Mcmahon and Robert Mcdougall Glennie, as Trustees of the Tbhunter Trust for Children
    Transacciones
    • 23 jun 2005Registro de un cargo (395)
    • 17 feb 2011Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (MG02)
    Mortgage of bank account as amended by supplemental deed
    Creado el 13 jun 2005
    Entregado el 23 jun 2005
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descripción
    All its right title and interest in and to the deposit, the account numbered 611061 and agreement dated 26 february 2001. see the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • Thomas Blane Hunter and James Cairns Mcmahon as Partners in the Firm of Westcoast Capital
    Transacciones
    • 23 jun 2005Registro de un cargo (395)
    • 21 feb 2011Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (MG02)
    Mortgage of bank account as amended by supplemental deed
    Creado el 13 jun 2005
    Entregado el 23 jun 2005
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descripción
    All its right title and interest in and to the deposit, the account numbered 611053 and agreement dated 26 february 2001. see the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • Thomas Blane Hunter and James Cairns Mcmahon as Partners in the Firm of Westcoast Capital
    Transacciones
    • 23 jun 2005Registro de un cargo (395)
    • 17 feb 2011Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (MG02)
    Mortgage of bank account as amended by supplemental deed
    Creado el 13 jun 2005
    Entregado el 23 jun 2005
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descripción
    All its right title and interest in and to the deposit, the account numbered 611020 and agreement dated 26 february 2001. see the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • Thomas Blane Hunter and James Cairns Mcmahon as Partners in the Firm of Westcoast Capital
    Transacciones
    • 23 jun 2005Registro de un cargo (395)
    • 17 feb 2011Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (MG02)
    Mortgage of bank account as amended by supplemental deed
    Creado el 13 jun 2005
    Entregado el 23 jun 2005
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descripción
    All its right title and interest in and to the deposit, the account numbered 611038 and agreement dated 26 february 2001. see the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • Thomas Blane Hunter
    Transacciones
    • 23 jun 2005Registro de un cargo (395)
    • 17 feb 2011Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (MG02)
    Mortgage of bank account as amended by supplemental deed
    Creado el 13 jun 2005
    Entregado el 23 jun 2005
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descripción
    All its right title and interest in and to the deposit, the account numbered 611046 and agreement dated 26 february 2001. see the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • Thomas Blane Hunter
    Transacciones
    • 23 jun 2005Registro de un cargo (395)
    • 17 feb 2011Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (MG02)
    Mortgage of bank account
    Creado el 26 feb 2001
    Entregado el 03 mar 2001
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All moneys, obligations and liabilities due or to become due from the company to the chargee under the loan note instrument in respect of the mortgage notes (as defined)
    Breve descripción
    All its right, title and interest in and to the deposit (as defined). See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • Thomas Blane Hunter
    Transacciones
    • 03 mar 2001Registro de un cargo (395)
    • 17 feb 2011Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (MG02)
    Mortgage of bank account
    Creado el 26 feb 2001
    Entregado el 03 mar 2001
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All moneys, obligations and liabilities due or to become due from the company to the chargee under the loan note instrument in respect of the mortgage notes (as defined)
    Breve descripción
    All its right, title and interest in and to the deposit (as defined). See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • Thomas Blane Hunter
    Transacciones
    • 03 mar 2001Registro de un cargo (395)
    • 17 feb 2011Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (MG02)
    Mortgage of bank account
    Creado el 26 feb 2001
    Entregado el 03 mar 2001
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All moneys, obligations and liabilities due or to become due from the company to the chargee under the loan note instrument in respect of the mortgage notes (as defined)
    Breve descripción
    All its right, title and interest in and to the deposit (as defined). See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • Thomas Blane Hunter, Marion Agnes Hunter and Robert Mcdougall Glennieas Trustees of the Tb Hunter's Charitable Trust
    Transacciones
    • 03 mar 2001Registro de un cargo (395)
    • 17 feb 2011Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (MG02)
    Mortgage of bank account
    Creado el 26 feb 2001
    Entregado el 03 mar 2001
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All moneys, obligations and liabilities due or to become due from the company to the chargee under the loan note instrument in respect of the mortgage notes (as defined)
    Breve descripción
    All its right, title and interest in and to the deposit (as defined). See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • Thomas Blane Hunter and Robert Mcdougall Glennie as Trustees of the Tb Hunter Trust Forchildren
    Transacciones
    • 03 mar 2001Registro de un cargo (395)
    • 17 feb 2011Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (MG02)
    Mortgage of bank account
    Creado el 26 feb 2001
    Entregado el 03 mar 2001
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All moneys, obligations and liabilities due or to become due from the company to the chargee under the loan note instrument in respect of the mortgage notes (as defined)
    Breve descripción
    All its right, title and interest in and to the deposit (as defined). See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • Thomas Blane Hunter and James Cairns Mcmahon as Partners in the Firm of Westcoast Capital
    Transacciones
    • 03 mar 2001Registro de un cargo (395)
    • 17 feb 2011Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (MG02)
    Mortgage of bank account
    Creado el 26 feb 2001
    Entregado el 03 mar 2001
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All moneys, obligations and liabilities due or to become due from the company to the chargee under the loan note instrument in respect of the mortgage notes (as defined)
    Breve descripción
    All its right, title and interest in and to the deposit (as defined). See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • Thomas Blane Hunter and James Cairns Mcmahon as Partners in the Firm of Westcoast Capital
    Transacciones
    • 03 mar 2001Registro de un cargo (395)
    • 17 feb 2011Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (MG02)
    Mortgage of bank account
    Creado el 26 feb 2001
    Entregado el 03 mar 2001
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All moneys, obligations and liabilities due or to become due from the company to the chargee under the loan note instrument in respect of the mortgage notes (as defined)
    Breve descripción
    All its right, title and interest in and to the deposit (as defined). See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • Thomas Blane Hunter and James Cairns Mcmahon as Partners in the Firm of Westcoast Capital
    Transacciones
    • 03 mar 2001Registro de un cargo (395)
    • 17 feb 2011Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (MG02)
    Security deposit agreement
    Creado el 11 sept 1998
    Entregado el 16 sept 1998
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the counter-indemnity and under the security deposit agreement
    Breve descripción
    The deposit and all rights and benefits accruing or arising in connection therewith. Deposit means the amount credited to the account from time to time in sterling (initially being the sum of £170,478,001) including all interest credited thereto.. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • Ubs Ag
    Transacciones
    • 16 sept 1998Registro de un cargo (395)
    • 13 mar 2009Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Legal charge
    Creado el 12 nov 1993
    Entregado el 19 nov 1993
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    Land and buildings on the north side of leopold street, wigan, greater manchester t/no gm 347289.
    Personas con derecho
    • Barclays Bank PLC
    Transacciones
    • 19 nov 1993Registro de un cargo (395)
    • 25 sept 1998Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Legal charge
    Creado el 20 may 1993
    Entregado el 03 jun 1993
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    Land and buildings west of wallgate wigan gtr manchester t/n GM167976.
    Personas con derecho
    • Barclays Bank PLC
    Transacciones
    • 03 jun 1993Registro de un cargo (395)
    • 25 oct 1994Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Legal charge
    Creado el 13 oct 1992
    Entregado el 23 oct 1992
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    54 and 56 wallgate wigan greater manchester title no: GM150634.
    Personas con derecho
    • Barclays Bank PLC
    Transacciones
    • 23 oct 1992Registro de un cargo (395)
    • 25 oct 1994Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Legal charge
    Creado el 12 jun 1992
    Entregado el 22 jun 1992
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    36 & 38 whitechapel & 25-31 (odd) williamson street liverpool merseyside t/no ms 332264.
    Personas con derecho
    • Barclays Bank PLC
    Transacciones
    • 22 jun 1992Registro de un cargo (395)
    • 25 sept 1998Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)

    ¿Tiene JJB SPORTS PLC algún caso de insolvencia?

    Número de expedienteFechasTipoProfesionalesOtro
    1
    FechaTipo
    30 abr 2009Fecha de la reunión para aprobar el CVA
    16 jun 2010Fecha de finalización o terminación del CVA
    Acuerdo voluntario de reestructuración empresarial (CVA)
    NombreRolDirecciónNombrado elCesado el
    Richard Dixon Fleming
    8 Salisbury Square
    EC4Y 8BB London
    Profesional
    8 Salisbury Square
    EC4Y 8BB London
    2
    FechaTipo
    22 mar 2011Fecha de la reunión para aprobar el CVA
    01 oct 2012Fecha de finalización o terminación del CVA
    Acuerdo voluntario de reestructuración empresarial (CVA)
    NombreRolDirecciónNombrado elCesado el
    Brian Green
    Kpmg Llp
    St James' Square
    M2 6DS Manchester
    Profesional
    Kpmg Llp
    St James' Square
    M2 6DS Manchester
    3
    FechaTipo
    01 oct 2012Inicio de la administración
    25 sept 2015Fin de la administración
    En administración
    NombreRolDirecciónNombrado elCesado el
    Richard Dixon Fleming
    8 Salisbury Square
    EC4Y 8BB London
    Profesional
    8 Salisbury Square
    EC4Y 8BB London
    Brian Green
    Kpmg Llp
    St James' Square
    M2 6DS Manchester
    Profesional
    Kpmg Llp
    St James' Square
    M2 6DS Manchester
    David James Costley-Wood
    Kpmg Llp
    St James Square
    M2 6DS Manchester
    Profesional
    Kpmg Llp
    St James Square
    M2 6DS Manchester

    Fuente de datos

    • Companies House del Reino Unido
      El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros.
    • Licencia: CC0