BLAND GROUP PROPERTIES LIMITED
Visión general
| Nombre de la empresa | BLAND GROUP PROPERTIES LIMITED |
|---|---|
| Estado de la empresa | Disuelta |
| Forma jurídica | Sociedad de responsabilidad limitada |
| Número de empresa | 01031864 |
| Jurisdicción | Inglaterra/Gales |
| Fecha de constitución | |
| Fecha de cese |
Resumen
| Tiene PSCs súper seguros | No |
|---|---|
| Tiene gravámenes | Sí |
| Tiene historial de insolvencia | No |
| La sede social está en disputa | No |
¿Cuál es el propósito de BLAND GROUP PROPERTIES LIMITED?
- Otro alquiler y explotación de bienes inmobiliarios propios o arrendados (68209) / Actividades inmobiliarias
¿Dónde se encuentra BLAND GROUP PROPERTIES LIMITED?
| Dirección de la sede social | Encombe House Estate Office Corfe Caslte BH20 5LW Wareham Dorset England |
|---|---|
| Dirección de la sede social no entregable | No |
¿Cuáles fueron los nombres anteriores de BLAND GROUP PROPERTIES LIMITED?
| Nombre de la empresa | Desde | Hasta |
|---|---|---|
| CADOGAN HOLIDAYS LIMITED | 26 ago 1993 | 26 ago 1993 |
| GIBRALTAR HOLIDAYS LIMITED | 16 sept 1986 | 16 sept 1986 |
| HOUSE OF BELLINGHAM(U.K.)LIMITED(THE) | 19 nov 1971 | 19 nov 1971 |
¿Cuáles son las últimas cuentas de BLAND GROUP PROPERTIES LIMITED?
| Últimas cuentas | |
|---|---|
| Últimas cuentas cerradas hasta | 31 mar 2020 |
¿Cuáles son las últimas presentaciones para BLAND GROUP PROPERTIES LIMITED?
| Fecha | Descripción | Documento | Tipo | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Boletín oficial final disuelto por cancelación voluntaria | 1 páginas | GAZ2(A) | ||||||||||
Primer aviso en el boletín oficial para la cancelación voluntaria | 1 páginas | GAZ1(A) | ||||||||||
Solicitud de exclusión de la empresa del registro | 1 páginas | DS01 | ||||||||||
Cese del nombramiento de Ian Mackie como secretario el 29 ene 2021 | 1 páginas | TM02 | ||||||||||
Nombramiento de Mrs Sarah Ann Tomlinson como secretario el 29 ene 2021 | 2 páginas | AP03 | ||||||||||
Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 31 mar 2020 | 6 páginas | AA | ||||||||||
Declaración de confirmación presentada el 19 mar 2020 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||||||||||
Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 31 mar 2019 | 6 páginas | AA | ||||||||||
Declaración de confirmación presentada el 19 mar 2019 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||||||||||
Los registros se han trasladado a la dirección del domicilio social registrado Encombe House Estate Office Corfe Caslte Wareham Dorset BH20 5LW | 1 páginas | AD04 | ||||||||||
Domicilio social registrado cambiado de The Beehive Beehive Ring Road Gatwick West Sussex RH6 0PA a Encombe House Estate Office Corfe Caslte Wareham Dorset BH20 5LW el 07 nov 2018 | 1 páginas | AD01 | ||||||||||
Cambio de datos del director Mr James Peter Gaggero el 28 may 2018 | 2 páginas | CH01 | ||||||||||
Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 31 mar 2018 | 6 páginas | AA | ||||||||||
Declaración de confirmación presentada el 19 mar 2018 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||||||||||
Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 31 mar 2017 | 7 páginas | AA | ||||||||||
Declaración de confirmación presentada el 19 mar 2017 con actualizaciones | 7 páginas | CS01 | ||||||||||
Cambio de datos del secretario Mr Ian Mackie el 22 nov 2016 | 1 páginas | CH03 | ||||||||||
Nombramiento de Mr Ian Mackie como secretario el 18 oct 2016 | 2 páginas | AP03 | ||||||||||
Cese del nombramiento de Nicola Louise Mayhew como secretario el 18 oct 2016 | 1 páginas | TM02 | ||||||||||
Cuentas completas preparadas hasta el 31 mar 2016 | 13 páginas | AA | ||||||||||
Déclaration annuelle établie au 19 mar 2016 avec liste complète des actionnaires | 5 páginas | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Cese del nombramiento de Henry Michael Game como director el 23 feb 2016 | 1 páginas | TM01 | ||||||||||
Cuentas completas preparadas hasta el 31 mar 2015 | 12 páginas | AA | ||||||||||
Déclaration annuelle établie au 19 mar 2015 avec liste complète des actionnaires | 6 páginas | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Cuentas completas preparadas hasta el 31 mar 2014 | 12 páginas | AA | ||||||||||
¿Quiénes son los directivos de BLAND GROUP PROPERTIES LIMITED?
| Nombre | Nombrado el | Renunció el | Rol | Dirección | Identificación de la empresa | País de residencia | Nacionalidad | Fecha de nacimiento | Ocupación | Número |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOMLINSON, Sarah Ann | Secretario | Estate Office Corfe Caslte BH20 5LW Wareham Encombe House Dorset England | 279100800001 | |||||||
| GAGGERO, James Peter George | Director | Estate Office Corfe Castle BH20 5LW Wareham Encombe House Dorset England | United Kingdom | British | 133601430002 | |||||
| ATTWOOD, Christopher | Secretario | 1 The Drive Warwick Park TN2 5ER Tunbridge Wells Southwinds Kent | 146060280001 | |||||||
| BLUNDEN, Lee David | Secretario | 9 The Laurels BH22 9TB Ferndown Dorset | British | 47119720002 | ||||||
| HEATH, David Ronald | Secretario | 129 Stakes Road Purbrook PO7 5PD Waterlooville Hampshire | British | 10334550001 | ||||||
| MACKIE, Ian | Secretario | Irish Town GX11 1AA Gibraltar Cloister Building United Kingdom | 216551100001 | |||||||
| MALE, Barry William | Secretario | The Lake House Old Hollow RH10 4TA Rowfant Sussex | British | 43524120002 | ||||||
| MAYHEW, Nicola Louise | Secretario | Fitzgerald Close PO15 7DZ Whiteley, Fareham 3 Hampshire United Kingdom | 164924830001 | |||||||
| READ, Timothy George | Secretario | 105 Olympic Way Fair Oak SO50 8QS Eastleigh Hampshire | British | 82236180001 | ||||||
| REYNOLDS, Susan Mary | Secretario | 18 Chessel Avenue Bitterne SO19 4DX Southampton | British | 64692680002 | ||||||
| REYNOLDS, Susan Mary | Secretario | 72 Athelstan Road SO19 4DD Southampton Hampshire | British | 64692680001 | ||||||
| THOMSON, Simon Patrick | Secretario | Beehive Ring Road RH6 0PA Gatwick The Beehive West Sussex | 151018500001 | |||||||
| WEST, Ian Robert Kenneth | Secretario | 15 Windover Close Bitterne SO19 5JS Southampton Hampshire | British | 20875520001 | ||||||
| ALLEN, Thomas William | Director | 36 Chelwood Gardens TW9 4JQ Richmond Surrey | United Kingdom | British | 126978240001 | |||||
| ATTWOOD, Christopher Raymond | Director | Southwinds 1 The Drive Warwick Park TN2 5ER Tunbridge Wells Kent | England | British | 106529990001 | |||||
| BLUNDEN, Lee David | Director | 9 The Laurels BH22 9TB Ferndown Dorset | United Kingdom | British | 47119720002 | |||||
| CHAPMAN, Neil | Director | Flat 4 5 Brunswick Terrace BN3 1HN Hove East Sussex | England | British | 43006170002 | |||||
| DAVID, Gary | Director | Upper Sutton Farm House Thorncross Lane, Brighstone PO30 4PW Newport Isle Of Wight | British | 63223900002 | ||||||
| GAGGERO, Joseph James | Director | Cloister Buildings PO BOX 403 FOREIGN Irish Town Gibraltar Europe | British | 11079290004 | ||||||
| GAME, Henry Michael | Director | Beehive Ring Road RH6 0PA Gatwick The Beehive West Sussex | United Kingdom | British | 140368320002 | |||||
| HUGHES, Henry Stuart | Director | 3 Broadwater Court Broadwater Down TN2 5PB Tunbridge Wells Kent | British | 38934050001 | ||||||
| KENT, Joss | Director | 16 Bute Gardens W6 7DX London | United Kingdom | British | 110344820001 | |||||
| KENWORTHY, Peter | Director | 5 Bakehouse Barn Close RH12 5JE Horsham West Sussex | England | British | 47694840001 | |||||
| LAWRENCE, Geoffrey Edward | Director | 9 Buldowne Walk Sway SO41 6DU Lymington Hampshire | British | 123055680001 | ||||||
| MATHIESON, Douglas | Director | Hill Lane SO15 4AF Southampton 151 Hampshire | British | 133540640001 | ||||||
| MAY, Iain Richard Campbell | Director | Beehive Ring Road RH6 0PA Gatwick The Beehive West Sussex | United Kingdom | British | 32619030003 | |||||
| OSBORNE, John Graham | Director | 73 Honeycrock Lane Salfords RH1 5DG Redhill Surrey | British | 56259410001 | ||||||
| RHODES, Stephen Graham | Director | 1 Scarborough Close SM2 7EA Sutton Surrey | United Kingdom | British | 110694320001 | |||||
| RILEY, John Joseph | Director | 24 Weald Close RH13 6HE Horsham West Sussex | British | 124777030001 | ||||||
| SHEATE, David | Director | Fibbards Road SO42 7RD Brockenhurst Ivyholme Hampshire | United Kingdom | British | 133540250001 |
¿Quiénes son las personas con control significativo de BLAND GROUP PROPERTIES LIMITED?
| Nombre | Notificado el | Dirección | Cesado | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bland Group Uk Holdings Limited | 06 abr 2016 | Beehive Ring Road RH6 0PA Gatwick The Beehive West Sussex United Kingdom | No | ||||||||||
| |||||||||||||
Naturaleza del control
| |||||||||||||
¿Tiene BLAND GROUP PROPERTIES LIMITED alguna carga?
| Clasificación | Fechas | Estado | Detalles | |
|---|---|---|---|---|
| A registered charge | Creado el 21 ago 2013 Entregado el 28 ago 2013 | Satisfecho en su totalidad | ||
Breve descripción Cadogan house, 37 commercial road, southampton t/no HP294362. Notification of addition to or amendment of charge. Contiene una garantía fija: Sí | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
| Deed of charge over credit balances | Creado el 19 abr 2000 Entregado el 03 may 2000 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Breve descripción Barclays bank PLC re cadogan holidays limited business premium account number 70329886. the charge creates a fixed charge over all the deposit(s) referred to in the schedule to the form 395 (including all or any part of the money payable pursuant to such deposit(s) and the debts represented thereby) together with all interest from time to time accruing thereon it also creates an assignment by the chargor for the purposes of and to give effect to the security over the right of the chargor to require repayment of such deposit(s) and interest thereon. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
Fuente de datos
- Companies House del Reino Unido
El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros. - Licencia: CC0