EKACROFT LIMITED

  • Visión general
  • Resumen
  • Propósito
  • Dirección
  • Cuentas
  • Presentaciones
  • Directivos
  • Gravámenes
  • Insolvencia
  • Fuente de datos
  • Visión general

    Nombre de la empresaEKACROFT LIMITED
    Estado de la empresaDisuelta
    Forma jurídicaSociedad de responsabilidad limitada
    Número de empresa 01034416
    JurisdicciónInglaterra/Gales
    Fecha de constitución
    Fecha de cese

    Resumen

    Tiene PSCs súper segurosNo
    Tiene gravámenes
    Tiene historial de insolvencia
    La sede social está en disputaNo

    ¿Cuál es el propósito de EKACROFT LIMITED?

    • Desarrollo de proyectos de construcción (41100) / Construcción

    ¿Dónde se encuentra EKACROFT LIMITED?

    Dirección de la sede social
    15 Canada Square
    E14 5GL London
    Dirección de la sede social no entregableNo

    ¿Cuáles son las últimas cuentas de EKACROFT LIMITED?

    Últimas cuentas
    Últimas cuentas cerradas hasta30 sept 2015

    ¿Cuáles son las últimas presentaciones para EKACROFT LIMITED?

    Presentaciones
    FechaDescripciónDocumentoTipo

    Gaceta final disuelta tras la liquidación

    1 páginasGAZ2

    Cese del nombramiento de Nicholas Mark Fletcher Jopling como director el 20 dic 2017

    1 páginasTM01

    Devolución de la reunión final en una liquidación voluntaria de miembros

    6 páginasLIQ13

    Presentación de insolvencia

    Insolvency:secretary of state's release of liquidator
    1 páginasLIQ MISC

    Declaración de recibos y pagos del liquidador hasta 30 nov 2016

    4 páginas4.68

    Orden judicial de insolvencia

    Court order insolvency:c/o replacement of liquidator
    30 páginasLIQ MISC OC

    Aviso de cese de funciones como liquidador voluntario

    1 páginas4.40

    Nombramiento de un liquidador voluntario

    2 páginas600

    Cese del nombramiento de Nicholas Peter On como director el 25 jul 2016

    1 páginasTM01

    Cese del nombramiento de Helen Christine Gordon como director el 24 jun 2016

    1 páginasTM01

    Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 30 sept 2015

    6 páginasAA

    Nombramiento de Adam Mcghin como secretario el 04 mar 2016

    3 páginasAP03

    Cese del nombramiento de Michael Patrick Windle como secretario el 04 mar 2016

    2 páginasTM02

    Nombramiento de Helen Christine Gordon como director el 31 dic 2015

    3 páginasAP01

    Cese del nombramiento de Andrew Rolland Cunningham como director el 31 dic 2015

    2 páginasTM01

    Cese del nombramiento de Mark Greenwood como director el 22 dic 2015

    2 páginasTM01

    Domicilio social registrado cambiado de Citygate Saint James Boulevard Newcastle upon Tyne NE1 4JE a 15 Canada Square London E14 5GL el 18 dic 2015

    2 páginasAD01

    Nombramiento de un liquidador voluntario

    2 páginas600

    Resoluciones

    Resolutions
    1 páginasRESOLUTIONS
    Acuerdos
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    liquidation

    Acuerdo especial para la liquidación el 01 dic 2015

    LRESSP

    Declaración de solvencia

    3 páginas4.70

    Déclaration annuelle établie au 30 sept 2015 avec liste complète des actionnaires

    8 páginasAR01
    Presentaciones asociadas
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    capital23 oct 2015

    Estado de capital el 23 oct 2015

    • Capital: GBP 100
    SH01

    Cambio de datos del director Mr Mark Jeremy Robson el 06 may 2015

    3 páginasCH01

    Cancelación total de la carga 5

    4 páginasMR04

    Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 30 sept 2014

    6 páginasAA

    Déclaration annuelle établie au 30 sept 2014 avec liste complète des actionnaires

    8 páginasAR01
    Presentaciones asociadas
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    capital30 oct 2014

    Estado de capital el 30 oct 2014

    • Capital: GBP 100
    SH01

    ¿Quiénes son los directivos de EKACROFT LIMITED?

    Directivos
    NombreNombrado elRenunció elRolDirecciónIdentificación de la empresaPaís de residenciaNacionalidadFecha de nacimientoOcupaciónNúmero
    MCGHIN, Adam
    St. James Boulevard
    NE1 4JE Newcastle
    Citygate
    United Kingdom
    Secretario
    St. James Boulevard
    NE1 4JE Newcastle
    Citygate
    United Kingdom
    206242240001
    ROBSON, Mark Jeremy
    Albury Park Road
    NE30 2SH Tynemouth
    12
    Tyne & Wear
    United Kingdom
    Director
    Albury Park Road
    NE30 2SH Tynemouth
    12
    Tyne & Wear
    United Kingdom
    United KingdomBritish97977930003
    DAVIS, Geoffrey Joseph
    9 The Copse
    Burnopfield
    NE16 6HA Newcastle Upon Tyne
    Tyne & Wear
    Secretario
    9 The Copse
    Burnopfield
    NE16 6HA Newcastle Upon Tyne
    Tyne & Wear
    British65421150001
    GLANVILLE, Marie Louise
    28 Bramhall Drive
    High Generals Wood Rickleton
    NE38 9DB Washington
    Tyne & Wear
    Secretario
    28 Bramhall Drive
    High Generals Wood Rickleton
    NE38 9DB Washington
    Tyne & Wear
    English86483290001
    MILBURN, Peter Michael
    Derwent Lodge
    DH8 0TG Shotley Bridge
    County Durham
    Secretario
    Derwent Lodge
    DH8 0TG Shotley Bridge
    County Durham
    British36406380001
    WINDLE, Michael Patrick
    Stanton Townhead
    NE65 8PR Morpeth
    High Priar
    Northumberland
    Secretario
    Stanton Townhead
    NE65 8PR Morpeth
    High Priar
    Northumberland
    British135308530001
    COUCH, Peter Quentin Patrick
    Amberley
    GL5 5AG Gloucestershire
    Follifoot House
    Director
    Amberley
    GL5 5AG Gloucestershire
    Follifoot House
    UkBritish156117090001
    CRUMBLEY, Brian Aidan
    10 Westfield Grove
    Gosforth
    NE3 4YA Newcastle Upon Tyne
    Tyne & Wear
    Director
    10 Westfield Grove
    Gosforth
    NE3 4YA Newcastle Upon Tyne
    Tyne & Wear
    EnglandBritish8495220002
    CUNNINGHAM, Andrew Rolland
    St James' Boulevard
    NE1 4JE Newcastle Upon Tyne
    Citygate
    United Kingdom
    Director
    St James' Boulevard
    NE1 4JE Newcastle Upon Tyne
    Citygate
    United Kingdom
    EnglandBritish74581390003
    DAVIS, Geoffrey Joseph
    17 Lintzford Road
    Hamsterley Mill Rowlands Gill
    NE39 1HA Newcastle Upon Tyne
    Director
    17 Lintzford Road
    Hamsterley Mill Rowlands Gill
    NE39 1HA Newcastle Upon Tyne
    EnglandBritish65421150003
    DICKINSON, Ian Joicey
    The Manor House
    NE44 6HW Riding Mill
    Northumberland
    Director
    The Manor House
    NE44 6HW Riding Mill
    Northumberland
    British8256940001
    DICKINSON, Robert Henry
    Styford Hall
    NE43 7TX Stocksfield
    Northumberland
    Director
    Styford Hall
    NE43 7TX Stocksfield
    Northumberland
    United KingdomBritish1509850001
    DICKINSON, Rupert Jerome
    59 Albert Bridge Road
    SW11 4AQ London
    Director
    59 Albert Bridge Road
    SW11 4AQ London
    United KingdomBritish60267600001
    DICKINSON, Stephen
    Crow Hall
    NE47 7BJ Bardon Mill
    Northumberland
    Director
    Crow Hall
    NE47 7BJ Bardon Mill
    Northumberland
    United KingdomBritish8256950001
    GORDON, Helen Christine
    St James' Boulevard
    NE1 4JE Newcastle Upon Tyne
    Citygate
    United Kingdom
    Director
    St James' Boulevard
    NE1 4JE Newcastle Upon Tyne
    Citygate
    United Kingdom
    EnglandBritish59902650001
    GREENWOOD, Mark
    Slayley
    NE47 0AA Hexham
    Winter House
    Northumberland
    Director
    Slayley
    NE47 0AA Hexham
    Winter House
    Northumberland
    United KingdomBritish154194730002
    JOPLING, Nicholas Mark Fletcher
    Canada Square
    E14 5GL London
    15
    Director
    Canada Square
    E14 5GL London
    15
    EnglandBritish60099210003
    MILBURN, Peter Michael
    Derwent Lodge
    DH8 0TG Shotley Bridge
    County Durham
    Director
    Derwent Lodge
    DH8 0TG Shotley Bridge
    County Durham
    British36406380001
    ON, Nicholas Peter
    Saint James' Boulevard
    NE1 4JE Newcastle Upon Tyne
    Citygate
    United Kingdom
    Director
    Saint James' Boulevard
    NE1 4JE Newcastle Upon Tyne
    Citygate
    United Kingdom
    United KingdomBritish135860930002
    PRATT, Andrew Michael
    Shadybrook, Beeches Drive
    Farnham Common
    SL2 3JT Slough
    Berkshire
    Director
    Shadybrook, Beeches Drive
    Farnham Common
    SL2 3JT Slough
    Berkshire
    EnglandBritish123314130002
    SCHWERDT, Peter Christopher George
    Newtown House
    Alton Barnes
    SN8 4LB Marlborough
    Wiltshire
    Director
    Newtown House
    Alton Barnes
    SN8 4LB Marlborough
    Wiltshire
    United KingdomBritish44923060004
    SLADE, Sean Anthony
    Idlewood
    Maidenhead Road
    SL6 9DF Cookham
    Berkshire
    Director
    Idlewood
    Maidenhead Road
    SL6 9DF Cookham
    Berkshire
    British94640230001
    YUDOLPH, Debra Rachel
    43 Netheravon Road
    W4 2AN London
    Director
    43 Netheravon Road
    W4 2AN London
    EnglandBritish105582680001

    ¿Tiene EKACROFT LIMITED alguna carga?

    Gravámenes
    ClasificaciónFechasEstadoDetalles
    Security agreement
    Creado el 30 jun 2004
    Entregado el 17 jul 2004
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from each obligor to the beneficiaries (or any of them) under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descripción
    By way of a first floating charge all of the company's properties and all other assets both present and future.
    Personas con derecho
    • Barclays Bank PLC as Agent and Trustee for Itself and Each of the Beneficiaries
    Transacciones
    • 17 jul 2004Registro de un cargo (395)
    • 19 feb 2015Satisfacción de una carga (MR04)
    Deed of charge
    Creado el 30 sept 1992
    Entregado el 20 oct 1992
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    All book and other debts......all moneysthe company may receive....see form 395.
    Personas con derecho
    • Barclays Bank PLC
    Transacciones
    • 20 oct 1992Registro de un cargo (395)
    • 21 ago 2004Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Floating charge
    Creado el 19 may 1988
    Entregado el 09 jun 1988
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    The f/hold & l/hold property of the company both present and future together with all buildings fixtures (including and fixtures) and fixed plant and machinery from time to time thereon the goodwill and uncalled capital of the company both present and future all the asset & undertaking see doc m 184.
    Personas con derecho
    • Barclays Bank PLC
    Transacciones
    • 09 jun 1988Registro de una carga
    • 21 ago 2004Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Deposit of deed
    Creado el 06 sept 1974
    Entregado el 20 sept 1974
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from courstone properties LTD to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    178 bedford rd, kempston, beds 182 bedford rd, kempston, beds 184 bedford rd, kempston, beds.
    Personas con derecho
    • Lloyds Bank International Limited
    Transacciones
    • 20 sept 1974Registro de una carga
    • 21 ago 2004Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Equitable charge
    Creado el 06 sept 1974
    Entregado el 20 sept 1974
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from courtstone properties LTD to the chargee on any account whatsoever.
    Breve descripción
    178 bedford rd, kempston, beds 182 bedford rd, kempston, beds 184 bedford rd, kempston beds,.
    Personas con derecho
    • Lloyds Bank International Limited
    Transacciones
    • 20 sept 1974Registro de una carga
    • 21 ago 2004Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)

    ¿Tiene EKACROFT LIMITED algún caso de insolvencia?

    Número de expedienteFechasTipoProfesionalesOtro
    1
    FechaTipo
    20 mar 2018Fecha de disolución
    01 dic 2015Inicio de la liquidación
    Liquidación voluntaria de socios
    NombreRolDirecciónNombrado elCesado el
    Allan Watson Graham
    Kpmg Restructuring 15 Canada Square
    E14 5GL London
    Profesional
    Kpmg Restructuring 15 Canada Square
    E14 5GL London
    John David Thomas Milsom
    15 Canada Square
    E14 5GL London
    Profesional
    15 Canada Square
    E14 5GL London
    Mark Jeremy Orton
    Kpmg Llp One Snowhill
    Snow Hill Queensway
    B4 6GH Birmingham
    Profesional
    Kpmg Llp One Snowhill
    Snow Hill Queensway
    B4 6GH Birmingham

    Fuente de datos

    • Companies House del Reino Unido
      El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros.
    • Licencia: CC0