EKACROFT LIMITED
Visión general
| Nombre de la empresa | EKACROFT LIMITED |
|---|---|
| Estado de la empresa | Disuelta |
| Forma jurídica | Sociedad de responsabilidad limitada |
| Número de empresa | 01034416 |
| Jurisdicción | Inglaterra/Gales |
| Fecha de constitución | |
| Fecha de cese |
Resumen
| Tiene PSCs súper seguros | No |
|---|---|
| Tiene gravámenes | Sí |
| Tiene historial de insolvencia | Sí |
| La sede social está en disputa | No |
¿Cuál es el propósito de EKACROFT LIMITED?
- Desarrollo de proyectos de construcción (41100) / Construcción
¿Dónde se encuentra EKACROFT LIMITED?
| Dirección de la sede social | 15 Canada Square E14 5GL London |
|---|---|
| Dirección de la sede social no entregable | No |
¿Cuáles son las últimas cuentas de EKACROFT LIMITED?
| Últimas cuentas | |
|---|---|
| Últimas cuentas cerradas hasta | 30 sept 2015 |
¿Cuáles son las últimas presentaciones para EKACROFT LIMITED?
| Fecha | Descripción | Documento | Tipo | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gaceta final disuelta tras la liquidación | 1 páginas | GAZ2 | ||||||||||
Cese del nombramiento de Nicholas Mark Fletcher Jopling como director el 20 dic 2017 | 1 páginas | TM01 | ||||||||||
Devolución de la reunión final en una liquidación voluntaria de miembros | 6 páginas | LIQ13 | ||||||||||
Presentación de insolvencia Insolvency:secretary of state's release of liquidator | 1 páginas | LIQ MISC | ||||||||||
Declaración de recibos y pagos del liquidador hasta 30 nov 2016 | 4 páginas | 4.68 | ||||||||||
Orden judicial de insolvencia Court order insolvency:c/o replacement of liquidator | 30 páginas | LIQ MISC OC | ||||||||||
Aviso de cese de funciones como liquidador voluntario | 1 páginas | 4.40 | ||||||||||
Nombramiento de un liquidador voluntario | 2 páginas | 600 | ||||||||||
Cese del nombramiento de Nicholas Peter On como director el 25 jul 2016 | 1 páginas | TM01 | ||||||||||
Cese del nombramiento de Helen Christine Gordon como director el 24 jun 2016 | 1 páginas | TM01 | ||||||||||
Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 30 sept 2015 | 6 páginas | AA | ||||||||||
Nombramiento de Adam Mcghin como secretario el 04 mar 2016 | 3 páginas | AP03 | ||||||||||
Cese del nombramiento de Michael Patrick Windle como secretario el 04 mar 2016 | 2 páginas | TM02 | ||||||||||
Nombramiento de Helen Christine Gordon como director el 31 dic 2015 | 3 páginas | AP01 | ||||||||||
Cese del nombramiento de Andrew Rolland Cunningham como director el 31 dic 2015 | 2 páginas | TM01 | ||||||||||
Cese del nombramiento de Mark Greenwood como director el 22 dic 2015 | 2 páginas | TM01 | ||||||||||
Domicilio social registrado cambiado de Citygate Saint James Boulevard Newcastle upon Tyne NE1 4JE a 15 Canada Square London E14 5GL el 18 dic 2015 | 2 páginas | AD01 | ||||||||||
Nombramiento de un liquidador voluntario | 2 páginas | 600 | ||||||||||
Resoluciones Resolutions | 1 páginas | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Declaración de solvencia | 3 páginas | 4.70 | ||||||||||
Déclaration annuelle établie au 30 sept 2015 avec liste complète des actionnaires | 8 páginas | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Cambio de datos del director Mr Mark Jeremy Robson el 06 may 2015 | 3 páginas | CH01 | ||||||||||
Cancelación total de la carga 5 | 4 páginas | MR04 | ||||||||||
Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 30 sept 2014 | 6 páginas | AA | ||||||||||
Déclaration annuelle établie au 30 sept 2014 avec liste complète des actionnaires | 8 páginas | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
¿Quiénes son los directivos de EKACROFT LIMITED?
| Nombre | Nombrado el | Renunció el | Rol | Dirección | Identificación de la empresa | País de residencia | Nacionalidad | Fecha de nacimiento | Ocupación | Número |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MCGHIN, Adam | Secretario | St. James Boulevard NE1 4JE Newcastle Citygate United Kingdom | 206242240001 | |||||||
| ROBSON, Mark Jeremy | Director | Albury Park Road NE30 2SH Tynemouth 12 Tyne & Wear United Kingdom | United Kingdom | British | 97977930003 | |||||
| DAVIS, Geoffrey Joseph | Secretario | 9 The Copse Burnopfield NE16 6HA Newcastle Upon Tyne Tyne & Wear | British | 65421150001 | ||||||
| GLANVILLE, Marie Louise | Secretario | 28 Bramhall Drive High Generals Wood Rickleton NE38 9DB Washington Tyne & Wear | English | 86483290001 | ||||||
| MILBURN, Peter Michael | Secretario | Derwent Lodge DH8 0TG Shotley Bridge County Durham | British | 36406380001 | ||||||
| WINDLE, Michael Patrick | Secretario | Stanton Townhead NE65 8PR Morpeth High Priar Northumberland | British | 135308530001 | ||||||
| COUCH, Peter Quentin Patrick | Director | Amberley GL5 5AG Gloucestershire Follifoot House | Uk | British | 156117090001 | |||||
| CRUMBLEY, Brian Aidan | Director | 10 Westfield Grove Gosforth NE3 4YA Newcastle Upon Tyne Tyne & Wear | England | British | 8495220002 | |||||
| CUNNINGHAM, Andrew Rolland | Director | St James' Boulevard NE1 4JE Newcastle Upon Tyne Citygate United Kingdom | England | British | 74581390003 | |||||
| DAVIS, Geoffrey Joseph | Director | 17 Lintzford Road Hamsterley Mill Rowlands Gill NE39 1HA Newcastle Upon Tyne | England | British | 65421150003 | |||||
| DICKINSON, Ian Joicey | Director | The Manor House NE44 6HW Riding Mill Northumberland | British | 8256940001 | ||||||
| DICKINSON, Robert Henry | Director | Styford Hall NE43 7TX Stocksfield Northumberland | United Kingdom | British | 1509850001 | |||||
| DICKINSON, Rupert Jerome | Director | 59 Albert Bridge Road SW11 4AQ London | United Kingdom | British | 60267600001 | |||||
| DICKINSON, Stephen | Director | Crow Hall NE47 7BJ Bardon Mill Northumberland | United Kingdom | British | 8256950001 | |||||
| GORDON, Helen Christine | Director | St James' Boulevard NE1 4JE Newcastle Upon Tyne Citygate United Kingdom | England | British | 59902650001 | |||||
| GREENWOOD, Mark | Director | Slayley NE47 0AA Hexham Winter House Northumberland | United Kingdom | British | 154194730002 | |||||
| JOPLING, Nicholas Mark Fletcher | Director | Canada Square E14 5GL London 15 | England | British | 60099210003 | |||||
| MILBURN, Peter Michael | Director | Derwent Lodge DH8 0TG Shotley Bridge County Durham | British | 36406380001 | ||||||
| ON, Nicholas Peter | Director | Saint James' Boulevard NE1 4JE Newcastle Upon Tyne Citygate United Kingdom | United Kingdom | British | 135860930002 | |||||
| PRATT, Andrew Michael | Director | Shadybrook, Beeches Drive Farnham Common SL2 3JT Slough Berkshire | England | British | 123314130002 | |||||
| SCHWERDT, Peter Christopher George | Director | Newtown House Alton Barnes SN8 4LB Marlborough Wiltshire | United Kingdom | British | 44923060004 | |||||
| SLADE, Sean Anthony | Director | Idlewood Maidenhead Road SL6 9DF Cookham Berkshire | British | 94640230001 | ||||||
| YUDOLPH, Debra Rachel | Director | 43 Netheravon Road W4 2AN London | England | British | 105582680001 |
¿Tiene EKACROFT LIMITED alguna carga?
| Clasificación | Fechas | Estado | Detalles | |
|---|---|---|---|---|
| Security agreement | Creado el 30 jun 2004 Entregado el 17 jul 2004 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All monies due or to become due from each obligor to the beneficiaries (or any of them) under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Breve descripción By way of a first floating charge all of the company's properties and all other assets both present and future. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
| Deed of charge | Creado el 30 sept 1992 Entregado el 20 oct 1992 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Breve descripción All book and other debts......all moneysthe company may receive....see form 395. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
| Floating charge | Creado el 19 may 1988 Entregado el 09 jun 1988 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Breve descripción The f/hold & l/hold property of the company both present and future together with all buildings fixtures (including and fixtures) and fixed plant and machinery from time to time thereon the goodwill and uncalled capital of the company both present and future all the asset & undertaking see doc m 184. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
| Deposit of deed | Creado el 06 sept 1974 Entregado el 20 sept 1974 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All monies due or to become due from courstone properties LTD to the chargee on any account whatsoever | |
Breve descripción 178 bedford rd, kempston, beds 182 bedford rd, kempston, beds 184 bedford rd, kempston, beds. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
| Equitable charge | Creado el 06 sept 1974 Entregado el 20 sept 1974 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All monies due or to become due from courtstone properties LTD to the chargee on any account whatsoever. | |
Breve descripción 178 bedford rd, kempston, beds 182 bedford rd, kempston, beds 184 bedford rd, kempston beds,. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
¿Tiene EKACROFT LIMITED algún caso de insolvencia?
| Número de expediente | Fechas | Tipo | Profesionales | Otro | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
| Liquidación voluntaria de socios |
|
Fuente de datos
- Companies House del Reino Unido
El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros. - Licencia: CC0