JBMHL LIMITED

  • Visión general
  • Resumen
  • Propósito
  • Dirección
  • Nombres anteriores
  • Cuentas
  • Declaración anual
  • Presentaciones
  • Directivos
  • Gravámenes
  • Insolvencia
  • Fuente de datos
  • Visión general

    Nombre de la empresaJBMHL LIMITED
    Estado de la empresaDisuelta
    Forma jurídicaSociedad de responsabilidad limitada
    Número de empresa 01043129
    JurisdicciónInglaterra/Gales
    Fecha de constitución
    Fecha de cese

    Resumen

    Tiene PSCs súper segurosNo
    Tiene gravámenes
    Tiene historial de insolvencia
    La sede social está en disputaNo

    ¿Cuál es el propósito de JBMHL LIMITED?

    • Empresa inactiva (99999) / Actividades de organizaciones y organismos extraterritoriales

    ¿Dónde se encuentra JBMHL LIMITED?

    Dirección de la sede social
    No 1 Dorset Street
    SO15 2DP Southampton
    Hampshire
    Dirección de la sede social no entregableNo

    ¿Cuáles fueron los nombres anteriores de JBMHL LIMITED?

    Nombres anteriores de la empresa
    Nombre de la empresaDesdeHasta
    JBM HOLDINGS LIMITED01 jun 199401 jun 1994
    J.B.M. ELECTRICAL DISTRIBUTORS LIMITED31 dic 197731 dic 1977

    ¿Cuáles son las últimas cuentas de JBMHL LIMITED?

    Últimas cuentas
    Últimas cuentas cerradas hasta31 dic 2013

    ¿Cuál es el estado de la última declaración anual para JBMHL LIMITED?

    Declaración anual
    Última declaración anual

    ¿Cuáles son las últimas presentaciones para JBMHL LIMITED?

    Presentaciones
    FechaDescripciónDocumentoTipo

    Gaceta final disuelta tras la liquidación

    1 páginasGAZ2

    Devolución de la reunión final en una liquidación voluntaria de miembros

    6 páginas4.71

    Domicilio social registrado cambiado de PO Box 1 Tatton Street Knutsford Cheshire WA16 6AY a No 1 Dorset Street Southampton Hampshire SO15 2DP el 11 jun 2015

    2 páginasAD01

    Declaración de solvencia

    3 páginas4.70

    Nombramiento de un liquidador voluntario

    2 páginas600

    Resoluciones

    Resolutions
    1 páginasRESOLUTIONS
    Acuerdos
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    liquidation

    Acuerdo especial para la liquidación el 21 may 2015

    LRESSP

    Memorándum y Estatutos

    5 páginasMA

    Resoluciones

    Resolutions
    1 páginasRESOLUTIONS
    Acuerdos
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    incorporation

    Resolución del Memorándum y/o Artículos de Asociación

    RES01
    capital

    Resolución de asignación de valores

    RES10
    capital

    Resolución de eliminación de derechos de suscripción preferente

    RES11
    capital

    Resoluciones

    Restriction of share capital removed/ 31/12/2014
    RES13

    Estado de capital tras una asignación de acciones el 01 ene 2015

    • Capital: GBP 234,993
    4 páginasSH01

    Certificado de cambio de nombre

    Company name changed jbm holdings LIMITED\certificate issued on 17/03/15
    3 páginasCERTNM
    Presentaciones asociadas
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    change-of-name17 mar 2015

    Cambio de nombre por resolución

    NM01
    Acuerdos
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    change-of-name

    Resolución de cambio de nombre de la empresa el 05 mar 2015

    RES15

    Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 31 dic 2013

    4 páginasAA

    Déclaration annuelle établie au 21 jun 2014 avec liste complète des actionnaires

    4 páginasAR01
    Presentaciones asociadas
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    capital26 jun 2014

    Estado de capital el 26 jun 2014

    • Capital: GBP 167,750
    SH01

    Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 31 dic 2012

    4 páginasAA

    Cancelación total de la carga 5

    3 páginasMR04

    Cancelación total de la carga 1

    3 páginasMR04

    Cancelación total de la carga 2

    3 páginasMR04

    Cancelación total de la carga 3

    3 páginasMR04

    Cancelación total de la carga 4

    3 páginasMR04

    Déclaration annuelle établie au 21 jun 2013 avec liste complète des actionnaires

    4 páginasAR01

    Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 31 dic 2011

    4 páginasAA

    Déclaration annuelle établie au 21 jun 2012 avec liste complète des actionnaires

    4 páginasAR01

    Déclaration annuelle établie au 21 jun 2011 avec liste complète des actionnaires

    15 páginasAR01

    Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 31 dic 2010

    4 páginasAA

    Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 31 dic 2009

    4 páginasAA

    Déclaration annuelle établie au 21 jun 2010 avec liste complète des actionnaires

    14 páginasAR01

    ¿Quiénes son los directivos de JBMHL LIMITED?

    Directivos
    NombreNombrado elRenunció elRolDirecciónIdentificación de la empresaPaís de residenciaNacionalidadFecha de nacimientoOcupaciónNúmero
    ELSEGOOD, Philip Graham
    Dorset Street
    SO15 2DP Southampton
    No 1
    Hampshire
    Secretario
    Dorset Street
    SO15 2DP Southampton
    No 1
    Hampshire
    British22304520002
    GODDARD, Roger David
    Dorset Street
    SO15 2DP Southampton
    No 1
    Hampshire
    Director
    Dorset Street
    SO15 2DP Southampton
    No 1
    Hampshire
    United KingdomBritish83553400001
    MCNAIR, Douglas Talbot
    Dorset Street
    SO15 2DP Southampton
    No 1
    Hampshire
    Director
    Dorset Street
    SO15 2DP Southampton
    No 1
    Hampshire
    United KingdomBritish855740001
    COCKROFT, Richard Martin
    20 Evelyn Crescent
    Shirley
    SO15 5JE Southampton
    Hampshire
    Secretario
    20 Evelyn Crescent
    Shirley
    SO15 5JE Southampton
    Hampshire
    British31450950001
    MONKS, John Byron
    Copper Ridge
    Chapel Lane
    SO43 7FG Lyndhurst
    Hampshire
    Secretario
    Copper Ridge
    Chapel Lane
    SO43 7FG Lyndhurst
    Hampshire
    British13594610001
    BALLANTYNE, Ronald Young
    Westway Albert Square
    Bowdon
    WA14 2ND Altrincham
    Cheshire
    Director
    Westway Albert Square
    Bowdon
    WA14 2ND Altrincham
    Cheshire
    EnglandBritish855730001
    BENTON, Brian William
    Forest Borders
    Chapel Lane
    SO41 6BS Sway Lymington
    Hants
    Director
    Forest Borders
    Chapel Lane
    SO41 6BS Sway Lymington
    Hants
    British31450960001
    COCKROFT, Richard Martin
    20 Evelyn Crescent
    Shirley
    SO15 5JE Southampton
    Hampshire
    Director
    20 Evelyn Crescent
    Shirley
    SO15 5JE Southampton
    Hampshire
    British31450950001
    MONKS, Christopher Maurice
    6 Montfort Close
    SO51 5PH Romsey
    Hampshire
    Director
    6 Montfort Close
    SO51 5PH Romsey
    Hampshire
    British38341280001
    MONKS, John Byron
    Copper Ridge
    Chapel Lane
    SO43 7FG Lyndhurst
    Hampshire
    Director
    Copper Ridge
    Chapel Lane
    SO43 7FG Lyndhurst
    Hampshire
    British13594610001
    MONKS, John Laurence
    Nursery Farm Cottage
    Stock Lane, Landford
    SP5 2ER Salisbury
    Wiltshire
    Director
    Nursery Farm Cottage
    Stock Lane, Landford
    SP5 2ER Salisbury
    Wiltshire
    British65758480001
    SAVAGE, Edward James
    Chelidon Crossway
    Southdown Shawford
    SO21 2BT Winchester
    Hants
    Director
    Chelidon Crossway
    Southdown Shawford
    SO21 2BT Winchester
    Hants
    British13594620001

    ¿Tiene JBMHL LIMITED alguna carga?

    Gravámenes
    ClasificaciónFechasEstadoDetalles
    Legal charge
    Creado el 06 jun 1990
    Entregado el 08 jun 1990
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    F/H property k/a unit 11 towergate industrial park colebrook way andover hampshire together with all buildings, erections & fixtures (other than trade machinery as defined).
    Personas con derecho
    • Lombard North Central PLC
    Transacciones
    • 08 jun 1990Registro de una carga
    • 04 jul 2013Satisfacción de una carga (MR04)
    Charge supplemental to a mortgage debentutre dated 19-7-77.
    Creado el 10 ago 1989
    Entregado el 15 ago 1989
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    A specific charge over the benefit of all book debts and other debts due or owing to the company but so that the company shall pay into the company's account with national westminster bank PLC all monies which it may receive in respect of all book and other debts hereby charged by any other existing or future charge and shall not without consent in writing by nat. West. Bank PLC sellfactor discount or charge or assign the same in favour of any other person and the company shall if called upon to do by nat. West. Bank PLC execute legal assignments of such book and other debts to the national westminster bank PLC.
    Personas con derecho
    • National Westminster Bank PLC
    Transacciones
    • 15 ago 1989Registro de una carga
    • 04 jul 2013Satisfacción de una carga (MR04)
    Legal charge
    Creado el 01 nov 1988
    Entregado el 05 nov 1988
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    F/H, unit 11 tower gate industrial park, weyhill road, andover, hampshire with all buildings and erections and all fixtures (other than trade machinery).
    Personas con derecho
    • Lombard North Central PLC.
    Transacciones
    • 05 nov 1988Registro de una carga
    • 04 jul 2013Satisfacción de una carga (MR04)
    Legal mortgage
    Creado el 03 abr 1987
    Entregado el 13 abr 1987
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    Unicorn house princes street northam southampton hampshire title no hp 240245 and/or the proceeds of sale thereof. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Personas con derecho
    • National Westminster Bank PLC
    Transacciones
    • 13 abr 1987Registro de una carga
    • 04 jul 2013Satisfacción de una carga (MR04)
    Mortgage debenture
    Creado el 19 jul 1977
    Entregado el 28 jul 1977
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    A specific equitable charge over all the company's estate or interest in all freehold and leasehold properties, all stock shares and other securites. All book debts and other debts, assignment of goodwill, a floating charge over undertaking all other property and assets present and future (please see doc M10).
    Personas con derecho
    • National Westminster Bank PLC
    Transacciones
    • 28 jul 1977Registro de una carga
    • 04 jul 2013Satisfacción de una carga (MR04)

    ¿Tiene JBMHL LIMITED algún caso de insolvencia?

    Número de expedienteFechasTipoProfesionalesOtro
    1
    FechaTipo
    21 may 2015Inicio de la liquidación
    14 abr 2016Fecha de disolución
    Liquidación voluntaria de socios
    NombreRolDirecciónNombrado elCesado el
    Sean Kenneth Croston
    1 Dorset Street
    SO15 2DP Southampton
    Hampshire
    Profesional
    1 Dorset Street
    SO15 2DP Southampton
    Hampshire

    Fuente de datos

    • Companies House del Reino Unido
      El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros.
    • Licencia: CC0